INNOVATE RAIL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéINNOVATE RAIL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01774174
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de INNOVATE RAIL LIMITED ?

    • (6312) /

    Où se situe INNOVATE RAIL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BDO STOY HAYWARD LLP
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de INNOVATE RAIL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ROUNDOAK RAIL LIMITED30 nov. 198330 nov. 1983

    Quels sont les derniers comptes de INNOVATE RAIL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2006

    Quels sont les derniers dépôts pour INNOVATE RAIL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 déc. 2010

    5 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    3 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 juin 2010

    5 pages4.68

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    9 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 29 déc. 2008

    57 pages2.24B

    legacy

    1 pages288b

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    6 pages2.16B

    Résultat de la réunion des créanciers

    3 pages2.23B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    187 pages2.17B

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    legacy

    1 pages287

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    legacy

    1 pages288c

    Comptes annuels établis au 31 oct. 2006

    17 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    2 pages363a

    Qui sont les dirigeants de INNOVATE RAIL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EVANS, Ralph Anthony
    Grace House 90 Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6JU York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Grace House 90 Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6JU York
    North Yorkshire
    EnglandBritish48052490002
    DAVEY, Ian Harding
    53 Cromwell Road
    DN35 0AU Cleethorpes
    South Humberside
    Secrétaire
    53 Cromwell Road
    DN35 0AU Cleethorpes
    South Humberside
    British2052870001
    DIBDIN, Doris
    25 St Andrews Drive
    Burton Upon Stather
    DN15 9BY Scunthorpe
    South Humberside
    Secrétaire
    25 St Andrews Drive
    Burton Upon Stather
    DN15 9BY Scunthorpe
    South Humberside
    British3187700001
    CLARK, Robert William
    Primrose Cottage Prestwood
    DY7 5AN Stourbridge
    Staffordshire
    Administrateur
    Primrose Cottage Prestwood
    DY7 5AN Stourbridge
    Staffordshire
    British61948360001
    DARGAVEL, Stephen Geoffrey
    Ranelagh Gardens
    SW6 3PA London
    Suite 08 Hurlingham Studios
    Administrateur
    Ranelagh Gardens
    SW6 3PA London
    Suite 08 Hurlingham Studios
    British40896630002
    DIBDIN, Doris
    25 St Andrews Drive
    Burton Upon Stather
    DN15 9BY Scunthorpe
    South Humberside
    Administrateur
    25 St Andrews Drive
    Burton Upon Stather
    DN15 9BY Scunthorpe
    South Humberside
    United KingdomBritish3187700001
    DIBDIN, Thomas Peter
    25 St Andrews Drive
    Burton Upon Stather
    DN15 9BY Scunthorpe
    South Humberside
    Administrateur
    25 St Andrews Drive
    Burton Upon Stather
    DN15 9BY Scunthorpe
    South Humberside
    EnglandBritish33893060002
    JACKSON, Paul
    14 Redmain Way
    West Derby
    L12 0LU Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    14 Redmain Way
    West Derby
    L12 0LU Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish40294740001
    OSBORNE, Peter Gordon
    25 Scrooby Street
    S61 4PH Rotherham
    South Yorkshire
    Administrateur
    25 Scrooby Street
    S61 4PH Rotherham
    South Yorkshire
    British94197700011
    SAVAGE, Stephen John
    The Old Vicarage
    1 Church Street Caistor
    LN8 3ET Market Rasen
    Lincolnshire
    Administrateur
    The Old Vicarage
    1 Church Street Caistor
    LN8 3ET Market Rasen
    Lincolnshire
    EnglandBritish42339130002
    STITCHMAN, John Adam
    Apartment 610 The Litmus Building
    195 Huntingdon Street
    NG1 3NX Nottingham
    Administrateur
    Apartment 610 The Litmus Building
    195 Huntingdon Street
    NG1 3NX Nottingham
    British125897930001
    YOUNG, Michael
    1 Avenue Road
    DE56 4DW Duffield
    Derbyshire
    Administrateur
    1 Avenue Road
    DE56 4DW Duffield
    Derbyshire
    United KingdomBritish126009380001

    INNOVATE RAIL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 29 sept. 2006
    Livré le 13 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from innovate rail limited innovate holdings limited innovate phil hanley limited corby chilled distribution limited corby chilled distribution (northern) limited corby chilled distribution (scotland) LTD and eimskipafelag islands ehf to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Glitnir Banki Hf as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transactions
    • 13 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Fixed and floating charge
    Créé le 12 janv. 2006
    Livré le 13 janv. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 13 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 10 nov. 2004
    Livré le 17 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit agreement
    Créé le 04 avr. 2001
    Livré le 12 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement and the lease of even date
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Robert John Hugo Randall and David John George Royds
    Transactions
    • 12 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 26 janv. 2001
    Livré le 31 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property former marconi works deykin avenue birmingham. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 31 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 20 mai 1988
    Livré le 07 juin 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    See doc for details.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Tsb England and Wales PLC
    Transactions
    • 07 juin 1988Enregistrement d'une charge
    • 19 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 17 juin 1987
    Livré le 29 juin 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    For details see form 395 doc. M52.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 29 juin 1987Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 29 août 1985
    Livré le 03 sept. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing £62,610 and all other monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    Two volvo bm 4300B articulated loading shovels with hydraulic attachment brackets pt. No. 90271, hi-tip buckets 4.3 cu.M. Pt. No. 99795 machine numbers chassis 5644 engine 64916. chassis 5645 engine 64925.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Leasing LTD
    • Lloyds Bowmaker Equipment Leasing LTD
    • Lloyds Bowmaker LTD
    Transactions
    • 03 sept. 1985Enregistrement d'une charge
    • 19 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    INNOVATE RAIL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 juin 2009Administration ended
    30 juin 2008Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Antony David Nygate
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    James Joseph Bannon
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    2
    DateType
    16 juin 2011Dissolved on
    30 juin 2009Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Antony David Nygate
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    James Joseph Bannon
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0