PCF PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED

PCF PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPCF PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01774545
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PCF PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe PCF PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Pinners Hall
    105-108 Old Broad Street
    EC2N 1ER London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PCF PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PCF LEASING LIMITED06 juil. 199806 juil. 1998
    AMC LEASING LIMITED24 mars 199524 mars 1995
    MDFC LEASING LIMITED30 déc. 198330 déc. 1983
    KIRKLEIGH LIMITED01 déc. 198301 déc. 1983

    Quels sont les derniers comptes de PCF PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour PCF PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    État du capital après une attribution d'actions au 05 sept. 2016

    • Capital: GBP 6,490,520
    4 pagesSH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 mars 2016 au 30 sept. 2016

    3 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 janv. 2016

    État du capital au 29 janv. 2016

    • Capital: GBP 1,501,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    18 pagesAA

    Nomination de David Richard Bull en tant qu'administrateur le 03 août 2015

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Zane Robert Kerse en tant que directeur le 31 juil. 2015

    2 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 févr. 2015

    État du capital au 20 févr. 2015

    • Capital: GBP 1,501,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    20 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Brandon House 180 Borough High Street London SE1 1LB à Pinners Hall 105-108 Old Broad Street London EC2N 1ER le 05 nov. 2014

    2 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 févr. 2014

    État du capital au 28 févr. 2014

    • Capital: GBP 1,501,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    19 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert John Murray le 31 mai 2012

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Scott David Maybury le 31 mai 2012

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Zane Robert Kerse le 31 mai 2012

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Robert John Murray le 31 mai 2012

    1 pagesCH03

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    25 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 39 Victoria Street London SW1H 0EU* le 14 mai 2012

    2 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    15 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    22 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de PCF PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MURRAY, Robert John
    105-108 Old Broad Street
    EC2N 1ER London
    Pinners Hall
    Secrétaire
    105-108 Old Broad Street
    EC2N 1ER London
    Pinners Hall
    British34741140002
    BULL, David Richard
    Old Broad Street
    EC2N 1ER London
    Pinners Hall 105-108
    England
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1ER London
    Pinners Hall 105-108
    England
    EnglandBritishFinance Director200176850001
    MAYBURY, Scott David
    105-108 Old Broad Street
    EC2N 1ER London
    Pinners Hall
    Administrateur
    105-108 Old Broad Street
    EC2N 1ER London
    Pinners Hall
    EnglandAustralianAccountant37924230004
    MURRAY, Robert John
    105-108 Old Broad Street
    EC2N 1ER London
    Pinners Hall
    Administrateur
    105-108 Old Broad Street
    EC2N 1ER London
    Pinners Hall
    EnglandBritishBanker34741140002
    JENKINS, Christopher John
    25 Purley Bury Avenue
    CR8 1JF Purley
    Surrey
    Secrétaire
    25 Purley Bury Avenue
    CR8 1JF Purley
    Surrey
    British41492190001
    FINLAY, James William Eyjolfur
    26 Earls Road
    TN4 8EA Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    26 Earls Road
    TN4 8EA Tunbridge Wells
    Kent
    BritishBanker5699700001
    JENKINS, Christopher John
    25 Purley Bury Avenue
    CR8 1JF Purley
    Surrey
    Administrateur
    25 Purley Bury Avenue
    CR8 1JF Purley
    Surrey
    BritishSolicitor41492190001
    KERSE, Zane Robert
    105-108 Old Broad Street
    EC2N 1ER London
    Pinners Hall
    Administrateur
    105-108 Old Broad Street
    EC2N 1ER London
    Pinners Hall
    EnglandBritishAccountant134375920001
    LAWLOR, Thomas Joseph
    2522 234th Street
    Torrance California Ca 90505
    America
    Administrateur
    2522 234th Street
    Torrance California Ca 90505
    America
    AmericanBusiness Executive5699710001
    MOTHERWAY, Thomas John
    10482 Broadview Place
    Santa Ana
    FOREIGN Orange California
    92705 Usa
    Administrateur
    10482 Broadview Place
    Santa Ana
    FOREIGN Orange California
    92705 Usa
    AmericanExecutive39981940001
    NELSON, Anthony Noel
    Ascotts
    RH19 2PS Felbridge
    Sussex
    Administrateur
    Ascotts
    RH19 2PS Felbridge
    Sussex
    United KingdomBritishSolicitor5699720001
    ROSEN, George
    32025 Sea Ridge Circle
    Rancho Palo Verdes California Ca90274
    America
    Administrateur
    32025 Sea Ridge Circle
    Rancho Palo Verdes California Ca90274
    America
    AmericanBusiness Executive5699730001
    STEPHEN, John Alexander
    19 Edward Road
    TW12 1LH Hampton Hill
    Middlesex
    Administrateur
    19 Edward Road
    TW12 1LH Hampton Hill
    Middlesex
    EnglandBritishBanker36744470001

    PCF PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security agreement
    Créé le 31 mars 2005
    Livré le 20 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Master block discounting agreement
    Créé le 23 déc. 2002
    Livré le 27 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights title and interest in and to the unassigned debts relating to the equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Singer & Friedlander Leasing Limited
    Transactions
    • 27 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Account assignment
    Créé le 29 nov. 1999
    Livré le 10 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of lease agreements (as therein defined)
    Brèves mentions
    Assigns all monies credited to and for the time being standing to the credit of account 50582530... see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ing Lease (UK) LTD
    Transactions
    • 10 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 mars 1996
    Livré le 12 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The whole of the undertaking property and assets of the company.
    Personnes ayant droit
    • Amc Trust Limited
    Transactions
    • 12 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Equipment mortgage and assignment
    Créé le 30 déc. 1994
    Livré le 18 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the drawdown facility (as defined therein)
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest in and to the equipment being 3 makino machine centres, serial nos. B56-444N, B57-525N and A56-17. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mcdonnell Douglas Finance Corporation
    Transactions
    • 18 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Equipment mortgage and assignment
    Créé le 30 déc. 1994
    Livré le 18 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the drawdown facility (as defined therein)
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest in and to the equipment being 2 toyoda FH55 horizontal machinery centres, serial nos. NM6892 and NM6860 and 1 tooling package. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mcdonnell Douglas Finance Corporation
    Transactions
    • 18 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Equipment mortgage and assignment
    Créé le 30 déc. 1994
    Livré le 18 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the drawdown facility (as defined therein)
    Brèves mentions
    All of the company's right title and interest in and to the equipment being 2 toyoda FH80 horizontal machinery centres with fanuc isma control, serial nos. NM7016 and NM7097. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mcdonnell Douglas Finance Corporation
    Transactions
    • 18 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Account assignment
    Créé le 31 déc. 1992
    Livré le 11 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement of even date and under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All moneys from time to time credited to and for the time being standing to the credit of the cash collateral account (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Internationale Nederlanden Lease (UK) Limitedacting as Agents for Internationale Nederlandenbank Nv
    Transactions
    • 11 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of indeminity & aircraft mortgage
    Créé le 31 oct. 1985
    Livré le 01 nov. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 31/10/85 pursuant to a lease agreement dated 18/12/84 and novation agreement dated
    Brèves mentions
    31/10/85 see schedule attached to doc M23 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Security Pacific International Leasing (Europe) Inc
    Transactions
    • 01 nov. 1985Enregistrement d'une charge
    Deed of indeminity & aircraft mortgage
    Créé le 31 oct. 1985
    Livré le 01 nov. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 31/10/85 pursuant to a lease agreement dated 18/12/84 and novation agreement dated 31/10/85
    Brèves mentions
    See schedule attached to doc M22 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Security Pacific International Leasing (Europe) Inc.
    Transactions
    • 01 nov. 1985Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0