PCF PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | PCF PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01774545 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PCF PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED ?
Adresse du siège social | Pinners Hall 105-108 Old Broad Street EC2N 1ER London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PCF PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour PCF PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 05 sept. 2016
| 4 pages | SH01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 31 mars 2016 au 30 sept. 2016 | 3 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2015 | 18 pages | AA | ||||||||||
Nomination de David Richard Bull en tant qu'administrateur le 03 août 2015 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Zane Robert Kerse en tant que directeur le 31 juil. 2015 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 10 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 7 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2014 | 20 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Brandon House 180 Borough High Street London SE1 1LB à Pinners Hall 105-108 Old Broad Street London EC2N 1ER le 05 nov. 2014 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2013 | 19 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert John Murray le 31 mai 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Scott David Maybury le 31 mai 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Zane Robert Kerse le 31 mai 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Robert John Murray le 31 mai 2012 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2012 | 25 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * 39 Victoria Street London SW1H 0EU* le 14 mai 2012 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires | 15 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2011 | 22 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PCF PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURRAY, Robert John | Secrétaire | 105-108 Old Broad Street EC2N 1ER London Pinners Hall | British | 34741140002 | ||||||
BULL, David Richard | Administrateur | Old Broad Street EC2N 1ER London Pinners Hall 105-108 England | England | British | Finance Director | 200176850001 | ||||
MAYBURY, Scott David | Administrateur | 105-108 Old Broad Street EC2N 1ER London Pinners Hall | England | Australian | Accountant | 37924230004 | ||||
MURRAY, Robert John | Administrateur | 105-108 Old Broad Street EC2N 1ER London Pinners Hall | England | British | Banker | 34741140002 | ||||
JENKINS, Christopher John | Secrétaire | 25 Purley Bury Avenue CR8 1JF Purley Surrey | British | 41492190001 | ||||||
FINLAY, James William Eyjolfur | Administrateur | 26 Earls Road TN4 8EA Tunbridge Wells Kent | British | Banker | 5699700001 | |||||
JENKINS, Christopher John | Administrateur | 25 Purley Bury Avenue CR8 1JF Purley Surrey | British | Solicitor | 41492190001 | |||||
KERSE, Zane Robert | Administrateur | 105-108 Old Broad Street EC2N 1ER London Pinners Hall | England | British | Accountant | 134375920001 | ||||
LAWLOR, Thomas Joseph | Administrateur | 2522 234th Street Torrance California Ca 90505 America | American | Business Executive | 5699710001 | |||||
MOTHERWAY, Thomas John | Administrateur | 10482 Broadview Place Santa Ana FOREIGN Orange California 92705 Usa | American | Executive | 39981940001 | |||||
NELSON, Anthony Noel | Administrateur | Ascotts RH19 2PS Felbridge Sussex | United Kingdom | British | Solicitor | 5699720001 | ||||
ROSEN, George | Administrateur | 32025 Sea Ridge Circle Rancho Palo Verdes California Ca90274 America | American | Business Executive | 5699730001 | |||||
STEPHEN, John Alexander | Administrateur | 19 Edward Road TW12 1LH Hampton Hill Middlesex | England | British | Banker | 36744470001 |
PCF PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Security agreement | Créé le 31 mars 2005 Livré le 20 avr. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Master block discounting agreement | Créé le 23 déc. 2002 Livré le 27 déc. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All rights title and interest in and to the unassigned debts relating to the equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Account assignment | Créé le 29 nov. 1999 Livré le 10 déc. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of lease agreements (as therein defined) | |
Brèves mentions Assigns all monies credited to and for the time being standing to the credit of account 50582530... see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 01 mars 1996 Livré le 12 mars 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The whole of the undertaking property and assets of the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Equipment mortgage and assignment | Créé le 30 déc. 1994 Livré le 18 janv. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the drawdown facility (as defined therein) | |
Brèves mentions All the company's right title and interest in and to the equipment being 3 makino machine centres, serial nos. B56-444N, B57-525N and A56-17. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Equipment mortgage and assignment | Créé le 30 déc. 1994 Livré le 18 janv. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the drawdown facility (as defined therein) | |
Brèves mentions All the company's right title and interest in and to the equipment being 2 toyoda FH55 horizontal machinery centres, serial nos. NM6892 and NM6860 and 1 tooling package. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Equipment mortgage and assignment | Créé le 30 déc. 1994 Livré le 18 janv. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the drawdown facility (as defined therein) | |
Brèves mentions All of the company's right title and interest in and to the equipment being 2 toyoda FH80 horizontal machinery centres with fanuc isma control, serial nos. NM7016 and NM7097. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Account assignment | Créé le 31 déc. 1992 Livré le 11 janv. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement of even date and under the terms of the charge | |
Brèves mentions All moneys from time to time credited to and for the time being standing to the credit of the cash collateral account (see form 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of indeminity & aircraft mortgage | Créé le 31 oct. 1985 Livré le 01 nov. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 31/10/85 pursuant to a lease agreement dated 18/12/84 and novation agreement dated | |
Brèves mentions 31/10/85 see schedule attached to doc M23 for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of indeminity & aircraft mortgage | Créé le 31 oct. 1985 Livré le 01 nov. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 31/10/85 pursuant to a lease agreement dated 18/12/84 and novation agreement dated 31/10/85 | |
Brèves mentions See schedule attached to doc M22 for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0