WYNDEHAM MASTERPIECE LIMITED

WYNDEHAM MASTERPIECE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWYNDEHAM MASTERPIECE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01774813
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WYNDEHAM MASTERPIECE LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe WYNDEHAM MASTERPIECE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    18 Westside Centre London Road
    Stanway
    CO3 8PH Colchester
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WYNDEHAM MASTERPIECE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WYNDEHAM GRAPHICS LIMITED10 août 200410 août 2004
    GRAPHIC FACILITIES LIMITED02 déc. 198302 déc. 1983

    Quels sont les derniers comptes de WYNDEHAM MASTERPIECE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour WYNDEHAM MASTERPIECE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 09 déc. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2020

    3 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 18 Westside Centre London Road Stanway Colchester CO3 8PH England à 18 Westside Centre London Road Stanway Colchester CO3 8PH le 16 déc. 2020

    1 pagesAD01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2019

    3 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 18 London Road Stanway Colchester CO3 8PH England à 18 Westside Centre London Road Stanway Colchester CO3 8PH le 16 déc. 2020

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 16 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 22 Westside Centre London Road Colchester Essex CO3 8PH England à 18 London Road Stanway Colchester CO3 8PH le 02 oct. 2020

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 17 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Zoe Repman en tant que secrétaire le 19 sept. 2019

    1 pagesTM02

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2018

    2 pagesAA

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 17 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2017

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2016

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Peter Cannon en tant que directeur le 10 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    3 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Bentalls Complex Colchester Road Heybridge Essex CM9 4NW à 22 Westside Centre London Road Colchester Essex CO3 8PH le 24 août 2016

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul George Utting le 22 juin 2016

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 janv. 2016

    État du capital au 05 janv. 2016

    • Capital: GBP 200,000
    SH01

    Qui sont les dirigeants de WYNDEHAM MASTERPIECE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    UTTING, Paul George
    Westside Centre, London Road
    CO3 8PH Colchester
    22
    Essex
    England
    Administrateur
    Westside Centre, London Road
    CO3 8PH Colchester
    22
    Essex
    England
    EnglandBritishDirector65550960005
    ALLEN, Maureen Martha
    The Bungalow 11 Anchor Close
    Cheshunt
    EN8 0PJ Waltham Cross
    Hertfordshire
    Secrétaire
    The Bungalow 11 Anchor Close
    Cheshunt
    EN8 0PJ Waltham Cross
    Hertfordshire
    BritishFinancial Controller67098750001
    GANDER, Barry Ivan
    13 Prince Edward Road
    CM11 2HA Billericay
    Essex
    Secrétaire
    13 Prince Edward Road
    CM11 2HA Billericay
    Essex
    BritishLithographer33545590002
    GANDER, Elizabeth Mary Winifred
    10 Lake Avenue
    CM12 0AJ Billericay
    Essex
    Secrétaire
    10 Lake Avenue
    CM12 0AJ Billericay
    Essex
    British33545580002
    HOLLEBONE, Paul Stephen
    Old Orchard Dog Lane
    BN44 3GE Steyning
    West Sussex
    Secrétaire
    Old Orchard Dog Lane
    BN44 3GE Steyning
    West Sussex
    BritishChartered Accountant15201600002
    JORDON, Declan
    Tisbara 17 Elliscombe Road
    Charlton
    SE7 7PF London
    Secrétaire
    Tisbara 17 Elliscombe Road
    Charlton
    SE7 7PF London
    IrishFinancial Director84869800001
    REPMAN, Zoe
    Westside Centre
    London Road
    CO3 8PH Colchester
    22
    Essex
    England
    Secrétaire
    Westside Centre
    London Road
    CO3 8PH Colchester
    22
    Essex
    England
    147333580001
    SADHEURA, Harjeet Singh
    131 Headstone Lane
    HA2 6LX Harrow
    Middlesex
    Secrétaire
    131 Headstone Lane
    HA2 6LX Harrow
    Middlesex
    BritishFinance Director65153230001
    UTTING, Paul George
    2 Walpole Gardens
    Strawberry Hill
    TW2 5SJ Twickenham
    Secrétaire
    2 Walpole Gardens
    Strawberry Hill
    TW2 5SJ Twickenham
    British65550960004
    BEDSON, Bryan Stanley
    The Old Rectory
    Patching
    BN13 3XF Arundel
    West Sussex
    Administrateur
    The Old Rectory
    Patching
    BN13 3XF Arundel
    West Sussex
    United KingdomBritishCompany Director18576770001
    CANNON, Peter
    14 Landview Gardens
    CM5 9EQ Chipping Ongar
    Essex
    Administrateur
    14 Landview Gardens
    CM5 9EQ Chipping Ongar
    Essex
    EnglandBritishSales Director95210390001
    COPPOCK, Lawrence Patrick
    The Close
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    Administrateur
    The Close
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    EnglandUnited KingdomChartered Accountant152718990001
    FITZPATRICK, Barry
    11 Tudor Drive
    Otford
    TN14 5QP Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    11 Tudor Drive
    Otford
    TN14 5QP Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishTechnical Director123801130001
    GANDER, Barry Ivan
    13 Prince Edward Road
    CM11 2HA Billericay
    Essex
    Administrateur
    13 Prince Edward Road
    CM11 2HA Billericay
    Essex
    BritishLithographer33545590002
    GANDER, Elizabeth Mary Winifred
    10 Lake Avenue
    CM12 0AJ Billericay
    Essex
    Administrateur
    10 Lake Avenue
    CM12 0AJ Billericay
    Essex
    BritishDirector33545580002
    HAGEMAN, Ian Jonathen
    21 Oxenden Wood Road
    BR6 6HR Orpington
    Kent
    Administrateur
    21 Oxenden Wood Road
    BR6 6HR Orpington
    Kent
    BritishDirector42114270001
    HOLLEBONE, Paul Stephen
    Old Orchard Dog Lane
    BN44 3GE Steyning
    West Sussex
    Administrateur
    Old Orchard Dog Lane
    BN44 3GE Steyning
    West Sussex
    EnglandBritishChartered Accountant15201600002
    HOLMES, Gavin Charles
    Montrose House
    Birchwood Road, Cock Clarks
    CM3 6RF Chelmsford
    Administrateur
    Montrose House
    Birchwood Road, Cock Clarks
    CM3 6RF Chelmsford
    EnglandBritishManaging Director50610090003
    IRVING, Gordon Robin
    377 Mountnessing Road
    CM12 0EU Billericay
    Essex
    Administrateur
    377 Mountnessing Road
    CM12 0EU Billericay
    Essex
    EnglandBritishWorks Director85089920002
    JORDON, Declan
    Tisbara 17 Elliscombe Road
    Charlton
    SE7 7PF London
    Administrateur
    Tisbara 17 Elliscombe Road
    Charlton
    SE7 7PF London
    IrishFinancial Director84869800001
    PAGE, Andrew Stephen
    29 Russell Avenue
    MK40 3TD Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    29 Russell Avenue
    MK40 3TD Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector86557080001
    PIPE, Leslie Albert
    76 Dynham Road
    NW6 2NR London
    Administrateur
    76 Dynham Road
    NW6 2NR London
    BritishLithographer50696900001
    SADHEURA, Harjeet Singh
    131 Headstone Lane
    HA2 6LX Harrow
    Middlesex
    Administrateur
    131 Headstone Lane
    HA2 6LX Harrow
    Middlesex
    BritishFinance Director65153230001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour WYNDEHAM MASTERPIECE LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    17 déc. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    WYNDEHAM MASTERPIECE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Full form debenture
    Créé le 05 déc. 2008
    Livré le 19 déc. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Leumi Abl Limited
    Transactions
    • 19 déc. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 01 déc. 2006
    Livré le 08 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Landsbanki Commercial Finance
    Transactions
    • 08 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 nov. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 02 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 01 déc. 2006
    Livré le 08 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    1 europa business park croft way witham braintree essex t/no EX676665 all buildings,fixtures and fittings and fixed plant and machinery from time to time thereon and all rights,easements and privileges appurtenant to or benefiting the property,fixed charge the benefit of all deeds,agreements,contract and warranties. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Landsbanki Commercial Finance
    Transactions
    • 08 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of accession supplemental to a debenture dated 24 march 2006 and
    Créé le 12 juin 2006
    Livré le 13 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other security beneficiares (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The bentalls complex colchester road maldon essex, f/h t/n EX443872, castle press 371 victoria street grimsby f/h t/n HS165423, unit 11/12 grange industrial estate grange road southwick west sussex f/h t/n WSX142782, for details of furtherproperties charged, please refer to form. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Landsbanki Islands Hf (As Security Trustee for the Security Beneficiaries)
    Transactions
    • 13 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 avr. 2002
    Livré le 25 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h property k/a unit 1 europa business park witham essex CM4 2FN, by way of fixed charge all of its present and future right title and interest in the insurances and all claims and rights to returns of premium in respect thereof.
    Personnes ayant droit
    • Associates Commercial Corporation Limited
    Transactions
    • 25 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 janv. 2002
    Livré le 19 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit 1 europa business park whitham essex CM4 2FN.
    Personnes ayant droit
    • Halifax PLC
    Transactions
    • 19 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of floating charge
    Créé le 17 janv. 2002
    Livré le 19 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Whatsoever and wheresoever present and/or future. Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Halifax PLC
    Transactions
    • 19 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 avr. 2001
    Livré le 19 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that the leasehold land and premises situate at and known as unit 3, maverton road industrial estate, maverton road, bow, london, E3 as the same is demised by a lease dated the 28TH day of november 2000 made between dudley UK limited of the one part and graphic facilities limited of the other part.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 avr. 2001
    Livré le 19 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that the leasehold land and premises situate at and known as init 4, maverton road industrial estate, maverton road, bow, london E3 as the same is demised by a lease dated the 28TH day of november 2000 made between dudley UK limited of the one part and graphic facilities limited of the other part.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 03 avr. 1995
    Livré le 21 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or graphic facilities (advertising) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 mars 1990
    Livré le 14 mars 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 3,2 maveston road, wick lane, london borough of tower hamlets. T/n ngl 421434.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 mars 1990Enregistrement d'une charge
    • 03 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 10 janv. 1990
    Livré le 22 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All rents and other sums payable by the company to the chargee under a lease dated 12/6/81
    Brèves mentions
    £7500 being held in a rent deposit account in the name of grimley J.R. eve, graphic facilities limited, at barclays bank PLC, P. O. box 90, 357/366 the strand london WC22 0NX.
    Personnes ayant droit
    • Sun Life Assurance Company of Canada.
    Transactions
    • 22 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 26 mai 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 02 oct. 1984
    Livré le 11 oct. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 oct. 1984Enregistrement d'une charge
    • 03 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0