PCF CREDIT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPCF CREDIT LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01775045
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PCF CREDIT LIMITED ?

    • Crédit-bail (64910) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe PCF CREDIT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    8th Floor Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PCF CREDIT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THE ASSET MANAGEMENT CORPORATION LIMITED03 juil. 200703 juil. 2007
    PRIVATE AND COMMERCIAL CREDIT CORPORATION LIMITED09 août 199609 août 1996
    AMC INDUSTRIAL FINANCE LIMITED24 mars 199524 mars 1995
    MDFC INDUSTRIAL FINANCE LIMITED 29 déc. 198329 déc. 1983
    MANTLEHAVEN LIMITED02 déc. 198302 déc. 1983

    Quels sont les derniers comptes de PCF CREDIT LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2024
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2024
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2022

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PCF CREDIT LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au23 janv. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation06 févr. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au23 janv. 2024
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour PCF CREDIT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de Garry George Stran en tant que directeur le 17 déc. 2024

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Dashwood House Old Broad Street London EC2M 1QS United Kingdom à 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL le 01 juil. 2024

    3 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 19 juin 2024

    LRESEX

    Déclaration des affaires

    13 pagesLIQ02

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    4 pages600

    Cessation de la nomination de Duncan Francis Mcdonald en tant que secrétaire le 19 juin 2024

    1 pagesTM02

    Deuxième dépôt d'un bilan du capital suite à une émission d'actions au 21 déc. 2023

    • Capital: GBP 150,001
    4 pagesRP04SH01

    Cessation de la nomination de Caroline Jane Richardson en tant que directeur le 07 févr. 2024

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 23 janv. 2024 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    État du capital après une attribution d'actions au 21 déc. 2023

    • Capital: GBP 150,001
    4 pagesSH01
    Annotations
    DateAnnotation
    28 mars 2024Clarification A second filed SH01 was registered on 28/03/2024.

    Nomination de Mr Duncan Francis Mcdonald en tant que secrétaire le 01 oct. 2023

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Jonathan Dolbear en tant que secrétaire le 01 oct. 2023

    1 pagesTM02

    Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2023 au 31 mars 2024

    1 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de Pinners Hall 105-108 Old Broad Street London EC2N 1ER à Dashwood House Old Broad Street London EC2M 1QS le 01 août 2023

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2022

    45 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 27 janv. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Caroline Jane Richardson le 10 août 2022

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2021

    57 pagesAA

    Nomination de Mr Jonathan Dolbear en tant que secrétaire le 01 avr. 2022

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Ldc Nominee Secretary Limited en tant que secrétaire le 01 avr. 2022

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 27 janv. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 30 sept. 2020

    51 pagesAA

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    122 pagesPARENT_ACC

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Qui sont les dirigeants de PCF CREDIT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DOLBEAR, Jonathan
    Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Dashwood House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Dashwood House
    United Kingdom
    294809120001
    JENKINS, Christopher John
    25 Purley Bury Avenue
    CR8 1JF Purley
    Surrey
    Secrétaire
    25 Purley Bury Avenue
    CR8 1JF Purley
    Surrey
    British41492190001
    MCDONALD, Duncan Francis
    Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Dashwood House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Dashwood House
    United Kingdom
    314268410001
    MURRAY, Robert John
    105-108 Old Broad Street
    EC2N 1ER London
    Pinners Hall
    Secrétaire
    105-108 Old Broad Street
    EC2N 1ER London
    Pinners Hall
    British34741140002
    LDC NOMINEE SECRETARY LIMITED
    Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    70
    England
    Secrétaire
    Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    70
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement06040545
    279142160001
    BULL, David Richard
    105-108 Old Broad Street
    EC2N 1ER London
    Pinners Hall
    England
    Administrateur
    105-108 Old Broad Street
    EC2N 1ER London
    Pinners Hall
    England
    EnglandBritishFinance Director200176850001
    FINLAY, James William Eyjolfur
    26 Earls Road
    TN4 8EA Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    26 Earls Road
    TN4 8EA Tunbridge Wells
    Kent
    BritishBanker5699700001
    JENKINS, Christopher John
    25 Purley Bury Avenue
    CR8 1JF Purley
    Surrey
    Administrateur
    25 Purley Bury Avenue
    CR8 1JF Purley
    Surrey
    BritishSolicitor41492190001
    KERSE, Zane Robert
    105-108 Old Broad Street
    EC2N 1ER London
    Pinners Hall
    Administrateur
    105-108 Old Broad Street
    EC2N 1ER London
    Pinners Hall
    EnglandBritishAccountant134375920001
    LAWLOR, Thomas Joseph
    2522 234th Street
    Torrance California Ca 90505
    America
    Administrateur
    2522 234th Street
    Torrance California Ca 90505
    America
    AmericanBusiness Executive5699710001
    MASSEY, Paul
    Two Oaks
    Eversley Road
    GU46 7RH Yateley
    Hampshire
    Administrateur
    Two Oaks
    Eversley Road
    GU46 7RH Yateley
    Hampshire
    BritishDirector70552910001
    MAYBURY, Scott David
    105-108 Old Broad Street
    EC2N 1ER London
    Pinners Hall
    Administrateur
    105-108 Old Broad Street
    EC2N 1ER London
    Pinners Hall
    EnglandAustralianAccountant37924230004
    MOTHERWAY, Thomas John
    10482 Broadview Place
    Santa Ana
    FOREIGN Orange California
    92705 Usa
    Administrateur
    10482 Broadview Place
    Santa Ana
    FOREIGN Orange California
    92705 Usa
    AmericanExecutive39981940001
    MURRAY, Robert John
    105-108 Old Broad Street
    EC2N 1ER London
    Pinners Hall
    Administrateur
    105-108 Old Broad Street
    EC2N 1ER London
    Pinners Hall
    EnglandBritishBanker34741140002
    NELSON, Anthony Noel
    Ascotts
    RH19 2PS Felbridge
    Sussex
    Administrateur
    Ascotts
    RH19 2PS Felbridge
    Sussex
    United KingdomBritishSolicitor5699720001
    RICHARDSON, Caroline Jane
    Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Dashwood House
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Dashwood House
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant281524620001
    ROSEN, George
    32025 Sea Ridge Circle
    Rancho Palo Verdes California Ca90274
    America
    Administrateur
    32025 Sea Ridge Circle
    Rancho Palo Verdes California Ca90274
    America
    AmericanAmercian5699730001
    STEPHEN, John Alexander
    19 Edward Road
    TW12 1LH Hampton Hill
    Middlesex
    Administrateur
    19 Edward Road
    TW12 1LH Hampton Hill
    Middlesex
    EnglandBritishBanker36744470001
    STRAN, Garry George
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    Administrateur
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    EnglandBritishDirector88583590001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PCF CREDIT LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Pcf Group Plc
    105-108 Old Broad Street
    EC2N 1ER London
    Pinners Hall
    England
    06 avr. 2016
    105-108 Old Broad Street
    EC2N 1ER London
    Pinners Hall
    England
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement02863246
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    PCF CREDIT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 24 juil. 2017
    Livré le 25 juil. 2017
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Investec Asset Finance PLC
    Transactions
    • 25 juil. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 déc. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 06 mai 2016
    Livré le 16 mai 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    None.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bermuda Commercial Bank Limited
    Transactions
    • 16 mai 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 déc. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 06 mai 2016
    Livré le 16 mai 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    None.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bermuda Commercial Bank Limited
    Transactions
    • 16 mai 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 déc. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 02 avr. 2015
    Livré le 08 avr. 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • British Business Bank Investments LTD
    Transactions
    • 08 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 déc. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A block discounting master agreement
    Créé le 01 juin 2012
    Livré le 02 juin 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all its right title and interest in and to the unassigned debts and the asset see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aldermore Bank PLC (Purchaser)
    Transactions
    • 02 juin 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 14 déc. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Account assignment
    Créé le 13 oct. 2008
    Livré le 17 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All monies from time to time credited to, and for the time being standing to the credit of the account a/c no. 32155093 sort code 60-40-05 together with all interest from time to time acrued thereon and all other assets of the assignor from time to time assigned.
    Personnes ayant droit
    • Hitachi Capital (UK) PLC
    Transactions
    • 17 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Block discounting agreement
    Créé le 03 oct. 2008
    Livré le 04 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The assets being goods referred to in any agreement, the receivable in respect of which is at such time a purchased receivable see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hitachi Capital (UK) PLC
    Transactions
    • 04 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 déc. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Block discounting agreement
    Créé le 28 avr. 2008
    Livré le 29 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    First floating charge over all of the company's right, title in the debts and goods see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Siemens Financial Services Limited
    Transactions
    • 29 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mai 2008
    • 12 janv. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Amendment and restatement agreement
    Créé le 31 mars 2005
    Livré le 20 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 20 janv. 2003
    Livré le 31 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All estates or interests in any freehold or leasehold property including all real property with all buildings,fixtures,fittings,fixed plant and machinery thereon; the benefit of any covenants for title and any moneys paid or payable thereunder; all shares in any of the company's subsidiaries and all stocks,debentures,bonds or other securities and investments and any dividend or interest payable; any right,money or property accruing or offered at any time; fixed charge over all plant and machinery and all rights in respect of any amount standing to the credit of the proceeds account all book and other debts,all other moneys due and benefit of all rights,securities or guarantees whatsoever; all rights in respect of any contract or policy of insurance and all eligible agreements and any letter of credit,bill of exchange,etc; the goodwill,uncalled capital and floating charge over all assets; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC,as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 31 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security assignment
    Créé le 20 mars 1997
    Livré le 26 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 18TH march 1997
    Brèves mentions
    All right, title and interest in and to the receivables as defined in the facility letter dated 18TH march 1997.
    Personnes ayant droit
    • Riggs Bank Europe Limited
    Transactions
    • 26 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 20 mars 1997
    Livré le 26 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Riggs Bank Europe Limited
    Transactions
    • 26 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Master block discounting agreement
    Créé le 21 mai 1996
    Livré le 24 mai 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the block discounting agreement
    Brèves mentions
    1.1 the company as beneficial owner has (and to the intent that the security so constituted shall be a continuing secuirty in favour of the purchaser) charged with the payment and discharge of the secured liabilities by way of first fixed charge all its right, title and interest in and to the unassigned debts relating to and the equipment the subject of any agreement in existence now or hereafter.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Singer & Friedlander Leasing Limited
    Transactions
    • 24 mai 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Block discounting agreement
    Créé le 04 août 1995
    Livré le 05 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Floating charge over all of the company's right title amd interest in and to the debts and the assets purchased by the chargee under a block discounting agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hitachi Credit (U.K.) PLC
    Transactions
    • 05 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 31 mars 1985
    Livré le 16 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from british caledonian airways (charter) limited to the chargee under the terms of a deed of counter indemnity 29.3.85.
    Brèves mentions
    Fixed chargee over the account remaining in accounts numbered 6013465 and 058483 please see doc for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A
    Transactions
    • 16 avr. 1985Enregistrement d'une charge
    Security agreement
    Créé le 31 mars 1985
    Livré le 16 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a deed of counter indemnity 29.3.85
    Brèves mentions
    All mdfi right title and interest in and to all monies which may become payable please see doc for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A.
    Transactions
    • 16 avr. 1985Enregistrement d'une charge
    Security agreement
    Créé le 31 mars 1985
    Livré le 16 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a deed of counter indemnity 29.3.85
    Brèves mentions
    All mdfi right title and interest in and to all monies which may become payable see doc M24 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A
    Transactions
    • 16 avr. 1985Enregistrement d'une charge
    Security agreement
    Créé le 31 mars 1985
    Livré le 16 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from british caledonian airways (charter) limited to the chargee under the terms of a deed of counter indemnity 29.3.85
    Brèves mentions
    Fixed charge over the amount from time to time standing to accounts numbered 6013473 and 058734 see doc for details.
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A
    Transactions
    • 16 avr. 1985Enregistrement d'une charge
    Security agreement
    Créé le 31 mars 1985
    Livré le 18 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any of the transaction documents as defined in a participation agreement dated 29TH march 1985 relative to the aircraft package
    Brèves mentions
    The amount remaining of the amount from time to time standing to the credit of: (1) the account no 6013473 (2) the account no 058734 model dc-10 series 10 aircraft manufacturer no 46970 registration letters g-bjzd together with the engines spare engine and spare part relative thereto.
    Personnes ayant droit
    • British Caledonian Airways (Charter) Limited
    Transactions
    • 18 avr. 1985Enregistrement d'une charge
    Security agreement
    Créé le 31 mars 1985
    Livré le 18 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any of the transaction documents as defined in a participation agreement dated 29TH march 1985 relative to the aircraft package
    Brèves mentions
    The amount remaining of the amount from time to time standing to the credit of: (1) the account no 6013473 (2) the account no 058734 model dc-10 series 10 aircraft manufacturer no 46970 registration letters g-bjzd together with the engines spare engine and spare parts relative thereto.
    Personnes ayant droit
    • English Electric Leasings Limited
    Transactions
    • 18 avr. 1985Enregistrement d'une charge
    Security agreement
    Créé le 31 mars 1985
    Livré le 18 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any of the transaction documents as defined in a participation agreement dated 29TH march 1985 relative to the aircraft package
    Brèves mentions
    The amount remaining of the amount from time to time standing to the credit of: (1) the account no 6013473 (2) the account no 058734 model dc-10 series 10 aircraft manufacturer no 46970 registration letters g-bjzd together with the engines spare engine and spare parts relative thereto.
    Personnes ayant droit
    • Mitsui & Co. LTD
    Transactions
    • 18 avr. 1985Enregistrement d'une charge
    Security agreement
    Créé le 31 mars 1985
    Livré le 18 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any of the transaction documents as defined in a participation agreement dated 29TH march 1985 relative to the aircraft package
    Brèves mentions
    The amount remaining of the amount from time to time standing to the credit of: (1) the account no 6013473 (2) the account no 058734 model dc-10 series 10 aircraft manufacturer no 46973 registration letters g-bjze together with the engines, spare engine and spares parts relative thereto.
    Personnes ayant droit
    • British Caledonian Airways (Charter) Limited
    Transactions
    • 18 avr. 1985Enregistrement d'une charge
    Security agreement
    Créé le 31 mars 1985
    Livré le 18 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any of the transaction documents as defined in a participation agreement dated 29TH march 1985 relative to the aircraft package
    Brèves mentions
    The amount remaining of the amount from time to time standing to the credit of: (1) the account no 6013473 (2) the account no 058734 model dc-10 series 10 aircraft manufacturer no 46973 registration letters g-bjze together with the engines, spare engine and spare parts relative thereto.
    Personnes ayant droit
    • English Electric Leasings Limited
    Transactions
    • 18 avr. 1985Enregistrement d'une charge
    Security agreement
    Créé le 31 mars 1985
    Livré le 18 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any of the transaction documents as defined in a participation agreement dated 29TH march 1985 relative to the aircraft package
    Brèves mentions
    The amount remaining of the amount from time to time standing to the credit of: (1) the account no 6013473 (2) the account no 058734 model dc-10 series 10 aircraft manufacturer no 46973 registration letters g-bjze together with the engines, spare engine and spare parts relative thereto.
    Personnes ayant droit
    • Mitsui & Co LTD
    Transactions
    • 18 avr. 1985Enregistrement d'une charge

    PCF CREDIT LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 juin 2024Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Peter David Dickens
    1 Hardman Square
    M3 3EB Manchester
    practitioner
    1 Hardman Square
    M3 3EB Manchester
    Edward John Macnamara
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0