INEOS STYRENICS UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéINEOS STYRENICS UK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01780289
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de INEOS STYRENICS UK LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe INEOS STYRENICS UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Interpath Limited 10
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de INEOS STYRENICS UK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INEOS NOVA UK LIMITED01 oct. 200701 oct. 2007
    NOVA INNOVENE UK LIMITED19 oct. 200519 oct. 2005
    NOVA CHEMICALS EUROPE LIMITED22 févr. 199922 févr. 1999
    HUNTSMAN CHEMICAL COMPANY LIMITED22 déc. 198322 déc. 1983

    Quels sont les derniers comptes de INEOS STYRENICS UK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour INEOS STYRENICS UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    18 pagesLIQ13

    Modification des détails de Mr James Arthur Ratcliffe en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 mars 2022

    2 pagesPSC04

    Changement d'adresse du siège social de Anchor House 15-19 Britten Street Chelsea London SW3 3TY United Kingdom à C/O Interpath Limited 10 Fleet Place London EC4M 7RB le 18 juil. 2022

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    4 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 06 juil. 2022

    LRESSP

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Brown le 28 févr. 2022

    2 pagesCH01

    État du capital au 26 mai 2022

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital après une attribution d'actions au 26 mai 2022

    • Capital: GBP 18,553,904
    3 pagesSH01

    Changement d'adresse du siège social de Unit 14 Evenwood Close Runcorn WA7 1LZ United Kingdom à Anchor House 15-19 Britten Street Chelsea London SW33TY le 28 févr. 2022

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    15 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Anthony White en tant que directeur le 03 juin 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Alex Hogan en tant qu'administrateur le 03 juin 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David John Wright Rey en tant que secrétaire le 31 mars 2020

    1 pagesTM02

    Nomination de Paul Maddison en tant que secrétaire le 31 mars 2020

    2 pagesAP03

    Changement d'adresse du siège social de Runcorn Site Hq South Parade P O Box 9 Runcorn Cheshire WA7 4JE à Unit 14 Evenwood Close Runcorn WA7 1LZ le 27 mars 2020

    1 pagesAD01

    Démission de l'auditeur

    7 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de INEOS STYRENICS UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MADDISON, Paul
    Heatherways
    Formby
    L37 7HL Liverpool
    25
    United Kingdom
    Secrétaire
    Heatherways
    Formby
    L37 7HL Liverpool
    25
    United Kingdom
    268585810001
    BROWN, Andrew, Mr.
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Limited 10
    Administrateur
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Limited 10
    United KingdomBritishChartered Accountant192037840002
    HOGAN, Alex
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Limited 10
    Administrateur
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Limited 10
    United KingdomBritishDirector250499700001
    NICOLSON, John Allan
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Limited 10
    Administrateur
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Limited 10
    EnglandBritishHr Director220697430001
    DE LA CAMP, Christoph
    26 Wasserwerksweg
    40489 Dusseldorf
    40489
    Germany
    Secrétaire
    26 Wasserwerksweg
    40489 Dusseldorf
    40489
    Germany
    GermanFinance Director108467120001
    DICKS, Karen Dawn
    Lynfield
    Knutsford Road
    SK9 7RX Alderley Edge
    Cheshire
    Secrétaire
    Lynfield
    Knutsford Road
    SK9 7RX Alderley Edge
    Cheshire
    BritishAccountant86053880001
    MELLING, Timothy James
    Parke House16 Millwood Close
    Withnell Fold
    PR6 8AR Chorley
    Lancashire
    Secrétaire
    Parke House16 Millwood Close
    Withnell Fold
    PR6 8AR Chorley
    Lancashire
    British92709580001
    MULHALL, John Stephen
    33 Pencarrow Close
    West Didsbury
    M20 2PS Manchester
    Secrétaire
    33 Pencarrow Close
    West Didsbury
    M20 2PS Manchester
    BritishChartered Accountant98433420001
    NICHOLS, Paul Frederick
    South Parade
    P O Box 9
    WA7 4JE Runcorn
    Runcorn Site Hq
    Cheshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    South Parade
    P O Box 9
    WA7 4JE Runcorn
    Runcorn Site Hq
    Cheshire
    United Kingdom
    176713610001
    PIZZEY, Andrew James
    South Parade
    P O Box 9
    WA7 4JE Runcorn
    Runcorn Site Hq
    Cheshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    South Parade
    P O Box 9
    WA7 4JE Runcorn
    Runcorn Site Hq
    Cheshire
    United Kingdom
    168280820001
    REY, David John Wright
    Evenwood Close
    WA7 1LZ Runcorn
    Unit 14
    United Kingdom
    Secrétaire
    Evenwood Close
    WA7 1LZ Runcorn
    Unit 14
    United Kingdom
    191075260001
    RIMMER, Matthew
    5 Route De La Chaniaz
    Blonay
    1807
    Switzerland
    Secrétaire
    5 Route De La Chaniaz
    Blonay
    1807
    Switzerland
    BritishDirector163534170001
    BILLINGHAME, Albert Victor Charles
    3 Hamilton Drive
    Sunningdale
    SL5 9PP Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    3 Hamilton Drive
    Sunningdale
    SL5 9PP Ascot
    Berkshire
    BritishBusiness Development Director31591260001
    CLARKE, Adin Lyndon
    21 Buckfast Road
    Ashton On Mersey
    M33 5QB Sale
    Cheshire
    Administrateur
    21 Buckfast Road
    Ashton On Mersey
    M33 5QB Sale
    Cheshire
    BritishPlant Director31591270002
    CRAIG, Thomas Orr, Dr
    21 Church Brow
    Mottram
    SK14 6JJ Hyde
    Cheshire
    Administrateur
    21 Church Brow
    Mottram
    SK14 6JJ Hyde
    Cheshire
    BritishTechnical Director7757020001
    DE LA CAMP, Christoph
    26 Wasserwerksweg
    40489 Dusseldorf
    40489
    Germany
    Administrateur
    26 Wasserwerksweg
    40489 Dusseldorf
    40489
    Germany
    GermanFinance Director108467120001
    DICKS, Karen Dawn
    Lynfield
    Knutsford Road
    SK9 7RX Alderley Edge
    Cheshire
    Administrateur
    Lynfield
    Knutsford Road
    SK9 7RX Alderley Edge
    Cheshire
    BritishAccountant86053880001
    DURHAM, Richard Paulson
    4624 Mount Spting Court
    Salt Lake City Utah 84117
    FOREIGN United States Of America
    Administrateur
    4624 Mount Spting Court
    Salt Lake City Utah 84117
    FOREIGN United States Of America
    AmericanManager Executive38682620004
    FYFE, Ian Mclagan
    South Parade
    P O Box 9
    WA7 4JE Runcorn
    Runcorn Site Hq
    Cheshire
    Administrateur
    South Parade
    P O Box 9
    WA7 4JE Runcorn
    Runcorn Site Hq
    Cheshire
    United KingdomBritishHr Director111920880001
    GERHARD, Franken
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hawkslease
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hawkslease
    Hampshire
    United Kingdom
    SwitzerlandGermanDirector163505670001
    GRAHAM, Peter David
    2 Coniston Close
    SK9 7WD Alderley Edge
    Cheshire
    Administrateur
    2 Coniston Close
    SK9 7WD Alderley Edge
    Cheshire
    CanadianManufacturing Director100987140001
    HOWARD, Raymond
    8 Barnswood Close
    Grappenhall
    WA4 2YJ Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    8 Barnswood Close
    Grappenhall
    WA4 2YJ Warrington
    Cheshire
    EnglandBritishVice President/Managing Dir1470930001
    HUNTSMAN, Jon Meade
    3049 Sherwood Circle
    Salt Lake City
    Utah 84108
    Usa
    Administrateur
    3049 Sherwood Circle
    Salt Lake City
    Utah 84108
    Usa
    UsaAmericanChairman & Chief Executive Officer-Huntsman40885090001
    HUNTSMAN, Peter Riley
    1399 Devonshire Drive
    Salt Lake City
    Utah
    84108
    Usa
    Administrateur
    1399 Devonshire Drive
    Salt Lake City
    Utah
    84108
    Usa
    AmericanManager65184190001
    INGRAM, Robert Michael
    CH-1006 Lausanne
    Avenue De Florimont 18
    Switzerland
    Administrateur
    CH-1006 Lausanne
    Avenue De Florimont 18
    Switzerland
    SwitzerlandBritishBusiness Director176713600001
    JONES, Colin Howard
    Swanwick Close
    Goostrey
    CW4 8NU Crewe
    11
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Swanwick Close
    Goostrey
    CW4 8NU Crewe
    11
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director137584530001
    LUCAS, Wes William
    615 East Drive
    Sewickley
    Pennsylvania 15143
    Usa
    Administrateur
    615 East Drive
    Sewickley
    Pennsylvania 15143
    Usa
    AmericanExecitive62734630001
    MAHER, Michael John
    South Parade
    P O Box 9
    WA7 4JE Runcorn
    Runcorn Site Hq
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    South Parade
    P O Box 9
    WA7 4JE Runcorn
    Runcorn Site Hq
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishManager110531730003
    MELLING, Timothy James
    Parke House16 Millwood Close
    Withnell Fold
    PR6 8AR Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    Parke House16 Millwood Close
    Withnell Fold
    PR6 8AR Chorley
    Lancashire
    EnglandBritishFinancial Director92709580001
    MULHALL, John Stephen
    33 Pencarrow Close
    West Didsbury
    M20 2PS Manchester
    Administrateur
    33 Pencarrow Close
    West Didsbury
    M20 2PS Manchester
    BritishChartered Accountant98433420001
    NELSON, Daniel Aaron
    Le Bioley
    1610 Vuibroye
    Vavd
    Switzerland
    Administrateur
    Le Bioley
    1610 Vuibroye
    Vavd
    Switzerland
    AmericanCompany Director58848730002
    PIZZEY, Andrew James
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hawkslease
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hawkslease
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector181040410001
    POOLE, Albert Terence
    1130 Premier Way Sw
    Calgary
    T2T 1L6 Calgary
    Alberta
    Canada
    Administrateur
    1130 Premier Way Sw
    Calgary
    T2T 1L6 Calgary
    Alberta
    Canada
    CanadianExecutive62734280003
    PUGH, Martin
    7 Chemin Des Vignes
    Pully
    Vaud Canton 1009
    Switzerland
    Administrateur
    7 Chemin Des Vignes
    Pully
    Vaud Canton 1009
    Switzerland
    SwitzerlandBritishManaging Director108467030001
    RASBAND, Ronald A
    Five Shadow Wood Lane
    Sandy
    Utah 84092
    Usa
    Administrateur
    Five Shadow Wood Lane
    Sandy
    Utah 84092
    Usa
    AmericanPresident A Chief Operating Of46214560001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur INEOS STYRENICS UK LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr James Arthur Ratcliffe
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Limited 10
    06 avr. 2016
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Limited 10
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    INEOS STYRENICS UK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental fixed & floating charge.
    Créé le 08 août 1990
    Livré le 14 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 6-12-88.
    Brèves mentions
    See form 395 ref M75L for further details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bankers Trustee Company LTD(As Trustee)
    Transactions
    • 14 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 28 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed & floating charge debenture
    Créé le 06 déc. 1988
    Livré le 09 déc. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as trustee for the agent & other banks defined in the trust deed) under the terms of the security documents (as delivered)
    Brèves mentions
    Land & buildings at carrington works manchester (for full details see form 395 ref: M96). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bankers Trustee Company Limites
    Transactions
    • 09 déc. 1988Enregistrement d'une charge
    • 28 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 juin 1984
    Livré le 06 janv. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Standard Chartered Bank PLC.
    Transactions
    • 06 janv. 1984Enregistrement d'une charge

    INEOS STYRENICS UK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 août 2023Due to be dissolved on
    06 juil. 2022Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Howard Smith
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    practitioner
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Nicholas James Timpson
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    practitioner
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0