INEOS STYRENICS UK LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | INEOS STYRENICS UK LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01780289 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe INEOS STYRENICS UK LIMITED ?
Adresse du siège social | C/O Interpath Limited 10 Fleet Place EC4M 7RB London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de INEOS STYRENICS UK LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour INEOS STYRENICS UK LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 18 pages | LIQ13 | ||||||||||
Modification des détails de Mr James Arthur Ratcliffe en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 mars 2022 | 2 pages | PSC04 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Anchor House 15-19 Britten Street Chelsea London SW3 3TY United Kingdom à C/O Interpath Limited 10 Fleet Place London EC4M 7RB le 18 juil. 2022 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 4 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Brown le 28 févr. 2022 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
État du capital au 26 mai 2022
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 26 mai 2022
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Unit 14 Evenwood Close Runcorn WA7 1LZ United Kingdom à Anchor House 15-19 Britten Street Chelsea London SW33TY le 28 févr. 2022 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Anthony White en tant que directeur le 03 juin 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Alex Hogan en tant qu'administrateur le 03 juin 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David John Wright Rey en tant que secrétaire le 31 mars 2020 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Paul Maddison en tant que secrétaire le 31 mars 2020 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Runcorn Site Hq South Parade P O Box 9 Runcorn Cheshire WA7 4JE à Unit 14 Evenwood Close Runcorn WA7 1LZ le 27 mars 2020 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 7 pages | AUD | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 14 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de INEOS STYRENICS UK LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADDISON, Paul | Secrétaire | Heatherways Formby L37 7HL Liverpool 25 United Kingdom | 268585810001 | |||||||
BROWN, Andrew, Mr. | Administrateur | Fleet Place EC4M 7RB London C/O Interpath Limited 10 | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 192037840002 | ||||
HOGAN, Alex | Administrateur | Fleet Place EC4M 7RB London C/O Interpath Limited 10 | United Kingdom | British | Director | 250499700001 | ||||
NICOLSON, John Allan | Administrateur | Fleet Place EC4M 7RB London C/O Interpath Limited 10 | England | British | Hr Director | 220697430001 | ||||
DE LA CAMP, Christoph | Secrétaire | 26 Wasserwerksweg 40489 Dusseldorf 40489 Germany | German | Finance Director | 108467120001 | |||||
DICKS, Karen Dawn | Secrétaire | Lynfield Knutsford Road SK9 7RX Alderley Edge Cheshire | British | Accountant | 86053880001 | |||||
MELLING, Timothy James | Secrétaire | Parke House16 Millwood Close Withnell Fold PR6 8AR Chorley Lancashire | British | 92709580001 | ||||||
MULHALL, John Stephen | Secrétaire | 33 Pencarrow Close West Didsbury M20 2PS Manchester | British | Chartered Accountant | 98433420001 | |||||
NICHOLS, Paul Frederick | Secrétaire | South Parade P O Box 9 WA7 4JE Runcorn Runcorn Site Hq Cheshire United Kingdom | 176713610001 | |||||||
PIZZEY, Andrew James | Secrétaire | South Parade P O Box 9 WA7 4JE Runcorn Runcorn Site Hq Cheshire United Kingdom | 168280820001 | |||||||
REY, David John Wright | Secrétaire | Evenwood Close WA7 1LZ Runcorn Unit 14 United Kingdom | 191075260001 | |||||||
RIMMER, Matthew | Secrétaire | 5 Route De La Chaniaz Blonay 1807 Switzerland | British | Director | 163534170001 | |||||
BILLINGHAME, Albert Victor Charles | Administrateur | 3 Hamilton Drive Sunningdale SL5 9PP Ascot Berkshire | British | Business Development Director | 31591260001 | |||||
CLARKE, Adin Lyndon | Administrateur | 21 Buckfast Road Ashton On Mersey M33 5QB Sale Cheshire | British | Plant Director | 31591270002 | |||||
CRAIG, Thomas Orr, Dr | Administrateur | 21 Church Brow Mottram SK14 6JJ Hyde Cheshire | British | Technical Director | 7757020001 | |||||
DE LA CAMP, Christoph | Administrateur | 26 Wasserwerksweg 40489 Dusseldorf 40489 Germany | German | Finance Director | 108467120001 | |||||
DICKS, Karen Dawn | Administrateur | Lynfield Knutsford Road SK9 7RX Alderley Edge Cheshire | British | Accountant | 86053880001 | |||||
DURHAM, Richard Paulson | Administrateur | 4624 Mount Spting Court Salt Lake City Utah 84117 FOREIGN United States Of America | American | Manager Executive | 38682620004 | |||||
FYFE, Ian Mclagan | Administrateur | South Parade P O Box 9 WA7 4JE Runcorn Runcorn Site Hq Cheshire | United Kingdom | British | Hr Director | 111920880001 | ||||
GERHARD, Franken | Administrateur | Chapel Lane SO43 7FG Lyndhurst Hawkslease Hampshire United Kingdom | Switzerland | German | Director | 163505670001 | ||||
GRAHAM, Peter David | Administrateur | 2 Coniston Close SK9 7WD Alderley Edge Cheshire | Canadian | Manufacturing Director | 100987140001 | |||||
HOWARD, Raymond | Administrateur | 8 Barnswood Close Grappenhall WA4 2YJ Warrington Cheshire | England | British | Vice President/Managing Dir | 1470930001 | ||||
HUNTSMAN, Jon Meade | Administrateur | 3049 Sherwood Circle Salt Lake City Utah 84108 Usa | Usa | American | Chairman & Chief Executive Officer-Huntsman | 40885090001 | ||||
HUNTSMAN, Peter Riley | Administrateur | 1399 Devonshire Drive Salt Lake City Utah 84108 Usa | American | Manager | 65184190001 | |||||
INGRAM, Robert Michael | Administrateur | CH-1006 Lausanne Avenue De Florimont 18 Switzerland | Switzerland | British | Business Director | 176713600001 | ||||
JONES, Colin Howard | Administrateur | Swanwick Close Goostrey CW4 8NU Crewe 11 Cheshire United Kingdom | England | British | Managing Director | 137584530001 | ||||
LUCAS, Wes William | Administrateur | 615 East Drive Sewickley Pennsylvania 15143 Usa | American | Execitive | 62734630001 | |||||
MAHER, Michael John | Administrateur | South Parade P O Box 9 WA7 4JE Runcorn Runcorn Site Hq Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Manager | 110531730003 | ||||
MELLING, Timothy James | Administrateur | Parke House16 Millwood Close Withnell Fold PR6 8AR Chorley Lancashire | England | British | Financial Director | 92709580001 | ||||
MULHALL, John Stephen | Administrateur | 33 Pencarrow Close West Didsbury M20 2PS Manchester | British | Chartered Accountant | 98433420001 | |||||
NELSON, Daniel Aaron | Administrateur | Le Bioley 1610 Vuibroye Vavd Switzerland | American | Company Director | 58848730002 | |||||
PIZZEY, Andrew James | Administrateur | Chapel Lane SO43 7FG Lyndhurst Hawkslease Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 181040410001 | ||||
POOLE, Albert Terence | Administrateur | 1130 Premier Way Sw Calgary T2T 1L6 Calgary Alberta Canada | Canadian | Executive | 62734280003 | |||||
PUGH, Martin | Administrateur | 7 Chemin Des Vignes Pully Vaud Canton 1009 Switzerland | Switzerland | British | Managing Director | 108467030001 | ||||
RASBAND, Ronald A | Administrateur | Five Shadow Wood Lane Sandy Utah 84092 Usa | American | President A Chief Operating Of | 46214560001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur INEOS STYRENICS UK LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
---|---|---|---|
Mr James Arthur Ratcliffe | 06 avr. 2016 | Fleet Place EC4M 7RB London C/O Interpath Limited 10 | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
|
INEOS STYRENICS UK LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Supplemental fixed & floating charge. | Créé le 08 août 1990 Livré le 14 août 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 6-12-88. | |
Brèves mentions See form 395 ref M75L for further details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed & floating charge debenture | Créé le 06 déc. 1988 Livré le 09 déc. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee (as trustee for the agent & other banks defined in the trust deed) under the terms of the security documents (as delivered) | |
Brèves mentions Land & buildings at carrington works manchester (for full details see form 395 ref: M96). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 04 juin 1984 Livré le 06 janv. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
INEOS STYRENICS UK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0