JBS COMPUTER SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | JBS COMPUTER SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01780696 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe JBS COMPUTER SERVICES LIMITED ?
| Adresse du siège social | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de JBS COMPUTER SERVICES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 28 févr. 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour JBS COMPUTER SERVICES LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour JBS COMPUTER SERVICES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | GAZ2 | |||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 6 pages | 4.71 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2013 | 6 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Ms Vinodka Murria en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Denise Williams en tant que secrétaire | 3 pages | AP03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Booths Park 4 Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8GS England* le 25 mars 2013 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kerry Crompton en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Barbara Ann Firth en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Paul David Gibson en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Neal Roberts en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Neal Roberts en tant que secrétaire | 2 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Preedy en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 30 avr. 2013 au 28 févr. 2013 | 3 pages | AA01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2012 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Richard Ian Preedy le 16 août 2012 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Richard Ian Preedy en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Neal Anthony Roberts le 16 mai 2012 | 2 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Neal Anthony Roberts le 16 mai 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Kerry Jane Crompton le 16 mai 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Riding Court House Riding Court Road Datchet Slough Berkshire SL3 9JT United Kingdom* le 14 mai 2012 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de JBS COMPUTER SERVICES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, Denise | Secrétaire | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | British | 176953510001 | ||||||
| FIRTH, Barbara Ann | Administrateur | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 73934790009 | |||||
| GIBSON, Paul David | Administrateur | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 192439290001 | |||||
| MURRIA, Vinodka | Administrateur | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 57998050002 | |||||
| BAGGS, Michael Vincent | Secrétaire | 23 Brodrick Road SW7 7DX London | British | 25974780001 | ||||||
| CHALLINGER, Sara | Secrétaire | Hollyoak 2a Cricket Hill Finchampstead RG40 3TN Wokingham Berkshire | British | 123713140001 | ||||||
| DEELEY, Graham Hugh | Secrétaire | Crowtrees 30 Snatts Hill RH8 0BN Oxted Surrey | British | 36922530001 | ||||||
| FIRTH, Barbara Ann | Secrétaire | Bryher Cottage Lynx Hill KT24 5AX East Horsley Surrey | British | 73934790001 | ||||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Secrétaire | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | British | 140194900001 | ||||||
| BAGGS, Michael Vincent | Administrateur | 23 Brodrick Road SW7 7DX London | United Kingdom | British | 25974780001 | |||||
| BROWN, Alexander David | Administrateur | Greenhurst 14 Woodmansterne Lane SM7 3ES Banstead Surrey | England | British | 25974770002 | |||||
| CROMPTON, Kerry Jane | Administrateur | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | United Kingdom | British | 158261930001 | |||||
| FIRTH, Barbara Ann | Administrateur | Bryher Cottage Lynx Hill KT24 5AX East Horsley Surrey | England | British | 73934790001 | |||||
| HARDIE, Alistair Peter | Administrateur | Waveney Cottage Hill Grove, Lurgashall GU28 9EW Petworth West Sussex | England | British | 68788350001 | |||||
| LEUW, Martin Philip | Administrateur | Riding Court Road Datchet SL3 9JT Slough Riding Court House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141644370001 | |||||
| MURRIA, Vinodka | Administrateur | Furran 16 Barham Close KT13 9PR Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 57998050002 | |||||
| PINNING, Stephen Peter | Administrateur | 79a Shepherds Hill Highgate N6 5RG London | British | 14848160001 | ||||||
| PREEDY, Richard Ian | Administrateur | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | England | British | 123433610003 | |||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Administrateur | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | England | British | 12470210004 | |||||
| VELUSSI, Luca | Administrateur | 123 Hepworth Court 30 Gatliff Road SW1W 8QP London | United Kingdom | Italian | 113413330003 |
JBS COMPUTER SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 02 oct. 2007 Livré le 15 oct. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 01 déc. 2000 Livré le 07 déc. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating charge | Créé le 10 mai 1999 Livré le 11 mai 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions Fixed charge over 1). 22 off new acerpower 4100 pc units 2). 22 off acerview 17" monitor 3). 1 off acer 9100B server 4). 1 off dell poweredge 6300 5). 22 off microsoft small business edition 6). 1 off royal blue helpdesk software 7). 1 off qms magicolour 2 desklaser printer. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 01 déc. 1986 Livré le 02 déc. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
JBS COMPUTER SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0