HOLDFIELD LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHOLDFIELD LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01788946
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HOLDFIELD LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe HOLDFIELD LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kpmg Llp 15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de HOLDFIELD LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HOLDFIELD LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour HOLDFIELD LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Nomination de Helen Christine Gordon en tant qu'administrateur le 31 déc. 2015

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Rolland Cunningham en tant que directeur le 31 déc. 2015

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mark Greenwood en tant que directeur le 22 déc. 2015

    2 pagesTM01

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB à Kpmg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL le 10 avr. 2015

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Citygate St James' Boulevard Newcastle upon Tyne NE1 4JE à 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB le 02 déc. 2014

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 14 nov. 2014

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 oct. 2014

    État du capital au 24 oct. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2013

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Peter Couch en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 oct. 2013

    État du capital au 08 oct. 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2012

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Peter On le 29 sept. 2012

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mark Greenwood le 13 août 2012

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Rolland Cunningham le 10 août 2012

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2011

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Nicholas Mark Fletcher Jopling le 02 févr. 2012

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Nicholas Peter On le 22 déc. 2011

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Nicholas Peter On le 17 mai 2011

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2010

    12 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de HOLDFIELD LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WINDLE, Michael Patrick
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    Secrétaire
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    British135308530001
    GORDON, Helen Christine
    St. James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Administrateur
    St. James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    EnglandBritish59902650001
    JOPLING, Nicholas Mark Fletcher
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Administrateur
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritish60099210004
    ON, Nicholas Peter
    Saint James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Administrateur
    Saint James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritish135860930002
    GLANVILLE, Marie Louise
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    English86483290001
    MCDONNELL, David Croft
    Burnlea
    18 The Serpentine
    L19 9DT Liverpool
    Merseyside
    Secrétaire
    Burnlea
    18 The Serpentine
    L19 9DT Liverpool
    Merseyside
    British3569220001
    COUCH, Peter Quentin Patrick
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    Follifoot House
    Administrateur
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    Follifoot House
    UkBritish156117090001
    CUNNINGHAM, Andrew Rolland
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Administrateur
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    EnglandBritish74581390003
    DICKINSON, Rupert Jerome
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    Administrateur
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    United KingdomBritish60267600001
    GREENWOOD, Mark
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    Administrateur
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    United KingdomBritish154194730002
    HANLON, Keith
    Rookery Cottage
    Hillock Lane
    WN8 7RJ Dalton Nr Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    Rookery Cottage
    Hillock Lane
    WN8 7RJ Dalton Nr Wigan
    Lancashire
    British32810060001
    MCDONNELL, David Croft
    Burnlea
    18 The Serpentine
    L19 9DT Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    Burnlea
    18 The Serpentine
    L19 9DT Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish3569220001
    WINDLE, Michael Patrick
    High Priar Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    Northumberland
    Administrateur
    High Priar Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritish43646700001

    HOLDFIELD LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 05 févr. 2002
    Livré le 09 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    22 seddon st,st helens,WA10 6NU; t/no ms 236469; all fixtures,fixed plant and machinery thereon; fixed equitable charge over the goodwill of business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC and the Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 22 juin 2001
    Livré le 30 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property being 60 devon street st helens title number LA260454. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 30 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 mai 2001
    Livré le 25 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 18 mai 2001
    Livré le 03 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    49 ireland road, haydock, t/no MS294582. By way of fixed equitable charge the goodwill of any business; floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and other chattel assets.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC and the Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 03 mai 2001
    Livré le 22 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property at 72 borough road st helens WA10 3TA t/n MS290850 by way of fixed equitable charge the goodwill of any business; floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and other chattel assets.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 22 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 27 avr. 2001
    Livré le 02 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    66 lord street st helens. T/no. LA217090 by way of fixed equitable charge the goodwill of any business; floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and other chattel assets.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 02 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 27 avr. 2001
    Livré le 02 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    21 owen street st helens. T/no. LA211067 by way of fixed equitable charge the goodwill of any business; floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and other chattel assets.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 02 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 22 juin 1994
    Livré le 29 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/as 36A island road, garston, liverpool L19 t/no MS328945. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales
    Transactions
    • 29 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 22 juin 1994
    Livré le 29 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales
    Transactions
    • 29 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 02 avr. 1993
    Livré le 06 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property formerly the police station now k/a 108 lawrence road liverpool t/no ms 156577 & all movable plant & machinery implements utensils equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 06 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 02 juin 1992
    Livré le 05 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    51 fern grove liverpool merseyside. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 05 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 23 avr. 1991
    Livré le 14 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    4, grasmere ave st. Helens merseyside. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 14 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 27 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 23 avr. 1991
    Livré le 14 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    3, lynton grove, st. Helens, merseyside. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 14 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 27 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 23 avr. 1991
    Livré le 14 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    262 & 266 bele green lane, wigan grtr manchester. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 14 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 27 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 23 avr. 1991
    Livré le 14 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    58 cornice rd, liverpool, merseyside. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 14 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 27 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 23 avr. 1991
    Livré le 14 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Nos 55,59,65,75,83 & 87 pitt st, st helens, merseyside. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 14 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 27 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 23 avr. 1991
    Livré le 14 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    93, enfield st, lamberhead, green, pemberton wigan grtr manchester. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 14 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 27 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 23 avr. 1991
    Livré le 14 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    34, bentley st, st. Helens, merseyside.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 14 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 27 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 25 nov. 1987
    Livré le 27 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H properties 57 and 59 aughton road birkdale southport merseyside. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC.
    Transactions
    • 27 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 13 juil. 1987
    Livré le 16 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    36, island road, garston liverpool-. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 16 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 24 avr. 1987
    Livré le 15 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    64, whitehedge road, liverpool 19.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 15 mai 1987Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 24 avr. 1987
    Livré le 15 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    22, bonsall road, liverpool 12.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 15 mai 1987Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 24 avr. 1987
    Livré le 15 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    17, windbourne rd, liverpool 14 -. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales PLC
    Transactions
    • 15 mai 1987Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 17 oct. 1984
    Livré le 18 oct. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    & heritable property in scotland (see doc M9).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 18 oct. 1984Enregistrement d'une charge

    HOLDFIELD LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    12 févr. 2016Dissolved on
    14 nov. 2014Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0