IVORY BEVERAGES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéIVORY BEVERAGES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01796736
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de IVORY BEVERAGES LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe IVORY BEVERAGES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    East Wing 14th Floor
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de IVORY BEVERAGES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    COFFEE MAC LIMITED02 mars 198402 mars 1984

    Quels sont les derniers comptes de IVORY BEVERAGES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 mars 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour IVORY BEVERAGES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 15 avr. 2010

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Transactions authorised 09/04/2010
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy Michael Roe le 11 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Wyatt Bristow Aca Bsc(Hons) le 11 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 30 mars 2008

    14 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    8 pages363s

    Comptes annuels établis au 01 avr. 2007

    14 pagesAA

    Comptes annuels établis au 02 avr. 2006

    18 pagesAA

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2005

    21 pagesAA

    legacy

    8 pages363s

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de IVORY BEVERAGES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GREENWOOD, Michael Frank
    Gloucester Road
    Kew
    TW9 3BT Richmond
    51
    Surrey
    Secrétaire
    Gloucester Road
    Kew
    TW9 3BT Richmond
    51
    Surrey
    BritishDirector90910000002
    BRISTOW, Andrew Wyatt
    Garden Road
    BR1 3LX Bromley
    22
    Kent
    Administrateur
    Garden Road
    BR1 3LX Bromley
    22
    Kent
    EnglandBritishDirector8748280008
    ROE, Timothy Michael
    Kenley Road
    SW19 3JQ London
    2a
    Administrateur
    Kenley Road
    SW19 3JQ London
    2a
    EnglandBritishDirector51264250001
    ATKINSON, Richard
    5 Lukins Drive
    CM6 1XQ Dunmow
    Essex
    Secrétaire
    5 Lukins Drive
    CM6 1XQ Dunmow
    Essex
    British60376890001
    HALEY, Paul Stewart
    3 Providential Street
    Flockton
    WF4 4DJ Wakefield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    3 Providential Street
    Flockton
    WF4 4DJ Wakefield
    West Yorkshire
    British101774450001
    LEMPRIERE, Paul John
    20 Bishop Burton Road
    Cherry Burton
    HU17 7RW Beverley
    E Yorkshire
    Secrétaire
    20 Bishop Burton Road
    Cherry Burton
    HU17 7RW Beverley
    E Yorkshire
    BritishCompany Director7658350001
    MCKAY, William Trevor
    1 West Court
    HA0 3QQ North Wembley
    Middlesex
    Secrétaire
    1 West Court
    HA0 3QQ North Wembley
    Middlesex
    BritishSecretary588890001
    ALLAWAY, Michael John
    Grove Cottage
    Blounts Court Road
    RG9 5EU Peppard
    Henley On Thames
    Administrateur
    Grove Cottage
    Blounts Court Road
    RG9 5EU Peppard
    Henley On Thames
    United KingdomBritishCompany Director37618690001
    ATKINSON, Richard
    5 Lukins Drive
    CM6 1XQ Dunmow
    Essex
    Administrateur
    5 Lukins Drive
    CM6 1XQ Dunmow
    Essex
    BritishSolicitor60376890001
    BLAKE, Frank George Bennett
    117 Pannal Ash Road
    HG2 9JL Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    117 Pannal Ash Road
    HG2 9JL Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector3779990001
    CHRISTOPHER, John Martin
    24 Bridge Court
    Morley
    LS27 0BD Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    24 Bridge Court
    Morley
    LS27 0BD Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director18639650001
    DRAUDE, Barry
    20 Chestnut Green
    Monk Fryston
    LS25 5PN Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    20 Chestnut Green
    Monk Fryston
    LS25 5PN Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director112174490001
    DUNNE, Jeremy Robert
    16 Greenhill Road
    Armley
    LS12 3QA Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    16 Greenhill Road
    Armley
    LS12 3QA Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant84111110001
    FIRTH, Michael Roger
    Stamford House
    The Green, Green Hammerton
    YO26 8BQ York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Stamford House
    The Green, Green Hammerton
    YO26 8BQ York
    North Yorkshire
    BritishCompany Director62298980001
    GIDDINGS, Allan
    Rock House Back Lane
    Sicklinghall
    LS22 4BQ Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    Rock House Back Lane
    Sicklinghall
    LS22 4BQ Wetherby
    West Yorkshire
    BritishCompany Director2164900001
    HALEY, Paul Stewart
    3 Providential Street
    Flockton
    WF4 4DJ Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    3 Providential Street
    Flockton
    WF4 4DJ Wakefield
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant101774450001
    IVORY, Christopher Richard
    The Old Mill
    Kirkbridge Crakehall
    DL8 1PN Bedale
    North Yorkshire
    Administrateur
    The Old Mill
    Kirkbridge Crakehall
    DL8 1PN Bedale
    North Yorkshire
    BritishCompany Director12090570001
    LEMPRIERE, Paul John
    20 Bishop Burton Road
    Cherry Burton
    HU17 7RW Beverley
    E Yorkshire
    Administrateur
    20 Bishop Burton Road
    Cherry Burton
    HU17 7RW Beverley
    E Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director7658350001
    LUCK, Gary Darren Michael
    73 De Vigier Avenue
    CB10 2AY Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    73 De Vigier Avenue
    CB10 2AY Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritishDirector92311040001
    MACLACHLAN, Ronald Alan
    Oakcroft 30 The Orchards
    BD16 4AZ Bingley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Oakcroft 30 The Orchards
    BD16 4AZ Bingley
    West Yorkshire
    BritishCompany Director18639640001
    MILLER, Billy David
    96 Green Park Road
    HX3 0SW Halifax
    West Yorkshire
    Administrateur
    96 Green Park Road
    HX3 0SW Halifax
    West Yorkshire
    BritishDirector79550070001
    MORGAN, David Edward
    40 Singingwood Lane
    CA 94563 Orinda
    California
    Usa
    Administrateur
    40 Singingwood Lane
    CA 94563 Orinda
    California
    Usa
    BritishChartered Accountant60419650002
    MURRAY, Steven John
    9 Whiteoak Gardens The Hollies
    DA15 8WE Sidcup
    Kent
    Administrateur
    9 Whiteoak Gardens The Hollies
    DA15 8WE Sidcup
    Kent
    United KingdomBritishDirector21176500001
    WILFORD, Roy
    Hindlea
    Trigfa Estate
    LL72 8LL Moelfre
    Anglesey
    Administrateur
    Hindlea
    Trigfa Estate
    LL72 8LL Moelfre
    Anglesey
    BritishCompany Director76263740001

    IVORY BEVERAGES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 24 déc. 2001
    Livré le 03 janv. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Venture Finance PLC
    Transactions
    • 03 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Chattel mortgage
    Créé le 08 août 2000
    Livré le 10 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Various chattels the insurance policies in relation thereto and all the right title and interest in and to the benefit of all present and future contracts and agreements relating to the chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 23 mars 1998
    Livré le 30 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 11 mars 1997
    Livré le 21 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and all monies due or to become due from northallerton wholesale foods limited and/or land food products limited formerly known as flipchoice limited (the "group companies") except any monies due by the group companies as guarantor for the company
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 11 mars 1997
    Livré le 19 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 19 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 03 févr. 1997
    Livré le 13 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due from the company and northallerton wholesale foods limited (the "group company") to the chargee,except any monies or liabilities due owing or incurred by the group company as guarantor for the company
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 févr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture
    Créé le 09 déc. 1996
    Livré le 24 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each relevant obligor (as defined therein) to the institutions (as defined therein) (or any of them) under each of the financing documents to which that relevant obligor is a party
    Brèves mentions
    L/H property k/a the warehouse and land on the east side of ripley drive normanton t/n WYK555975 k/a carter mills 146 cleckheaton rd bradford units 5 & 6 normanton industrial estate normanton west yorkshire t/no's;- wyk 527220 & WYK531219 l/h property k/a unit 4 westwoods alphin brook road marsh barton exeter unit 29 earith business park fen drove earith huntingdon cambridgeshire. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 03 oct. 1996
    Livré le 10 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities (whether actual or contingient whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each relevant obligor to the chargee as agent and trustee for itself and for each institution (or any of them) as defined therein under each of the financing documents to which that relevant obligor is a party.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 17 mai 1991
    Acquis le 18 oct. 1991
    Livré le 29 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 janv. 1992Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 24 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 oct. 1989
    Livré le 30 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    • 24 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 14 juin 1989
    Livré le 21 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 juin 1989Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0