WMT HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWMT HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01797012
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WMT HOLDINGS LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe WMT HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WMT HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WMT HOLDINGS PLC24 mai 198424 mai 1984
    BADGERBUSH LIMITED05 mars 198405 mars 1984

    Quels sont les derniers comptes de WMT HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2005

    Quels sont les derniers dépôts pour WMT HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 09 mars 2009

    2 pages3.6

    legacy

    2 pages405(2)

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 13 nov. 2008

    2 pages3.6

    Divers

    Statement of affairs
    6 pagesMISC

    Rapport du séquestre administratif

    31 pages3.10

    legacy

    2 pages405(1)

    legacy

    1 pages287

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2005

    8 pagesAA

    Certificat de réimmatriculation de société anonyme à responsabilité limitée

    1 pagesCERT10

    Réenregistrement des statuts

    14 pagesMAR

    legacy

    2 pages53

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de réimmatriculation

    RES02

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages225

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2004

    19 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    8 pages363s

    legacy

    1 pages244

    Qui sont les dirigeants de WMT HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TOMLINSON, Philip Charles Murray
    630 Fulwood Road
    S10 3QJ Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    630 Fulwood Road
    S10 3QJ Sheffield
    South Yorkshire
    British58220340001
    TOMLINSON, Philip Charles Murray
    630 Fulwood Road
    S10 3QJ Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    630 Fulwood Road
    S10 3QJ Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishAccountant58220340001
    TOMLINSON, Simon John Lloyd
    19 Ashfurlong Close
    Dore
    S17 3NN Sheffield
    Administrateur
    19 Ashfurlong Close
    Dore
    S17 3NN Sheffield
    United KingdomBritishAccountant45674390002
    CALDWELL, John Christopher
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    British83552520001
    FOX, George William Damian
    Dickfield Farm
    Little Common Lane
    S11 9NE Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    Dickfield Farm
    Little Common Lane
    S11 9NE Sheffield
    South Yorkshire
    BritishCompany Director36779480002
    BREESE, Charles Jonathon
    Hethe House
    Hethe
    OX6 9ES Bicester
    Oxfordshire
    Administrateur
    Hethe House
    Hethe
    OX6 9ES Bicester
    Oxfordshire
    BritishCompany Director33215780002
    CALDWELL, John Christopher
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director83552520001
    CHARLES, Nigel Alan
    1 Midfields
    School Aycliffe
    DL5 6QJ Newton Aycliffe
    County Durham
    Administrateur
    1 Midfields
    School Aycliffe
    DL5 6QJ Newton Aycliffe
    County Durham
    BritishCompany Director30529170001
    FOX, George William Damian
    Dickfield Farm
    Little Common Lane
    S11 9NE Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    Dickfield Farm
    Little Common Lane
    S11 9NE Sheffield
    South Yorkshire
    BritishCompany Director36779480002
    INGRAM, Stephen
    88 Stumperlowe Hall Road
    S10 3QT Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    88 Stumperlowe Hall Road
    S10 3QT Sheffield
    South Yorkshire
    BritishChartered Accountant2338960001
    LIVERSIDGE, Douglas Brian
    Nicholas Hall
    Thornhill
    S33 0BR Hope Valley
    Administrateur
    Nicholas Hall
    Thornhill
    S33 0BR Hope Valley
    EnglandBritishDirector7267220002
    PULLUM, John Sidney
    9 Fordyce Close
    Emerson Park
    RM11 3LE Hornchurch
    Essex
    Administrateur
    9 Fordyce Close
    Emerson Park
    RM11 3LE Hornchurch
    Essex
    BritishCompany Director1471410001
    REED, Timothy Henry
    Jaggers Keep Bar Road
    Curbar
    S30 1YB Sheffield
    Administrateur
    Jaggers Keep Bar Road
    Curbar
    S30 1YB Sheffield
    EnglandBritishSolicitor39125880001
    TOMLINSON, Walter Murray
    Letterbox Farm
    Pratthall Calthorpe
    S42 7AZ Chesterfield
    Administrateur
    Letterbox Farm
    Pratthall Calthorpe
    S42 7AZ Chesterfield
    BritishCompany Director1961890001

    WMT HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 12 oct. 1998
    Livré le 17 oct. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a land and buildings lying to the south of station road holbrook sheffield t/nos SYK211754 and SYK344532. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    A registered charge
    Créé le 08 janv. 1991
    Livré le 08 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 janv. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 10 janv. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 12 juil. 1989
    Livré le 31 juil. 1989
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from morgan 85 limited and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    Letter of charge
    Créé le 22 sept. 1988
    Livré le 27 sept. 1988
    En cours
    Montant garanti
    All moneys now or at any time hereafter owing the bank by marshall richards barcro limited and/or morgan 85 limited and/or beaver 84 limited and/or rails 84 limited and/or murhan associates limited and/or lubewell limited power control systems limited to the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the banks books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 sept. 1988Enregistrement d'une charge
    Letter of charge
    Créé le 05 mars 1988
    Livré le 23 mars 1988
    En cours
    Montant garanti
    All moneys now or at any time hereafter owing the bank by marshall richards barcro limited and/or morgan 85 limited and/or beaver 84 limited and/or rails 84 limited and/or murhan associates limited and/or lubewell limited power control systems limited to the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the banks books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 mars 1988Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 09 avr. 1987
    Livré le 15 avr. 1987
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the undertaking, property and assets of the company whatsoever and wheresoever present and future.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 avr. 1987Enregistrement d'une charge
    • 18 déc. 2007Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (405 (1))
      • Numéro de dossier 1
    Letter of charge.
    Créé le 09 avr. 1987
    Livré le 15 avr. 1987
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from rails 84 limited and/or mirhan associates limited and/or beaver 84 limited and/or marshall richards barcro limited and/or morgan 85 limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transactions
    • 15 avr. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 17 janv. 1986
    Livré le 22 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 135,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    Leasehold property at station road, halfway, sheffield, title no syk 211754 together with all additions and fixtures.
    Personnes ayant droit
    • United Kingdom Temperence and General Provident Institution.
    Transactions
    • 22 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    • 24 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 08 mai 1985
    Livré le 14 mai 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge on all f/h or l/h properties and the proceeds of sale thereof fixed and floating charge undertaking and all property and assets present and future goodwill & bookdebts and the benefit of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 mai 1985Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 12 juin 1984
    Livré le 20 juin 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • United Kingdom Temperance and General Provident Institution
    Transactions
    • 20 juin 1984Enregistrement d'une charge

    WMT HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 avr. 1987Instrument date
    Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    practitioner
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Jonathon P Sumpton
    Ernst & Young
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    Leeds Ls11 5qr
    practitioner
    Ernst & Young
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    Leeds Ls11 5qr

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0