BROADGATE SQUARE LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBROADGATE SQUARE LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01797326
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BROADGATE SQUARE LTD ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe BROADGATE SQUARE LTD ?

    Adresse du siège social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BROADGATE SQUARE LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WATLING (108) PLC05 mars 198405 mars 1984

    Quels sont les derniers comptes de BROADGATE SQUARE LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour BROADGATE SQUARE LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Charles John Middleton en tant que directeur le 31 mars 2022

    1 pagesTM01

    État du capital au 18 mars 2022

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Bruce Michael James en tant que directeur le 31 déc. 2021

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 22 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2019

    3 pagesAA

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 22 déc. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018

    3 pagesAA

    Nomination de Mr Bruce Michael James en tant qu'administrateur le 27 mars 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Charles John Middleton en tant qu'administrateur le 27 mars 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Jonathan Charles Mcnuff en tant qu'administrateur le 27 mars 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Nigel Mark Webb en tant que directeur le 27 mars 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Sarah Morrell Barzycki en tant que directeur le 27 mars 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Timothy Andrew Roberts en tant que directeur le 27 mars 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Lucinda Margaret Bell en tant que directeur le 19 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de BROADGATE SQUARE LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secrétaire
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement8992198
    187856670001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Administrateur
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant205624050001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78691990001
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secrétaire
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    British1898090001
    HALLAM, Jonathan Paul
    11 Trinity Road
    SW19 8QT London
    Secrétaire
    11 Trinity Road
    SW19 8QT London
    British36631180001
    HUGHES, Paul
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    Secrétaire
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    British23950030001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secrétaire
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    ADAM, Shenol
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    Administrateur
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    BritishCompany Director2068480001
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Administrateur
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritishHead Of Finance58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Administrateur
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050044
    BERRY, David Charles
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant166550001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Administrateur
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    CAMP, David John
    11 Walham Grove
    SW6 London
    Administrateur
    11 Walham Grove
    SW6 London
    BritishNew Business Director4807190002
    CARTER, Simon Geoffrey
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Administrateur
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritishTreasury Executive170891060001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Administrateur
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    DANTZIC, Roy Matthew
    65 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    Administrateur
    65 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    BritishFinancial Director52294450003
    DOYLE, Eugene Francis
    2 Gombards
    AL3 5NW St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Gombards
    AL3 5NW St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomIrishAssociate Director73961570001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    HALLAM, Jonathan Paul
    11 Trinity Road
    SW19 8QT London
    Administrateur
    11 Trinity Road
    SW19 8QT London
    BritishSolicitor36631180001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Administrateur
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    JAMES, Bruce Michael
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishHead Of Secretariat226746900001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Administrateur
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    KALMAN, Stephen Lionel
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishChartered Surveyor1188110001
    LIPTON, Stuart Anthony, Sir
    40 Queens Grove
    NW8 6HH London
    Administrateur
    40 Queens Grove
    NW8 6HH London
    EnglandBritishDirector Of Companies2068540001
    MANNION, Michael John Francis
    32 Acacia Way
    The Hollies
    DA15 8WW Sidcup
    Kent
    Administrateur
    32 Acacia Way
    The Hollies
    DA15 8WW Sidcup
    Kent
    United KingdomBritishCivil Engineer57126040001
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Administrateur
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    BritishChartered Accountant3079600001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Administrateur
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishCorporate Tax Executive79841030002
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    Administrateur
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritishChairman & Md British Land Co41694870001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Administrateur
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritishCompany Director35758050004
    RIVLIN, Paul Denis
    42 Rochester Road
    NW1 9JJ London
    Administrateur
    42 Rochester Road
    NW1 9JJ London
    BritishDirector Of Companies2068550001
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Administrateur
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritishChartered Accountant79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Administrateur
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor63986410004
    ROGERS, Peter William
    10 Marryat Road
    Wimbledon
    SW19 5BD London
    Administrateur
    10 Marryat Road
    Wimbledon
    SW19 5BD London
    EnglandBritishDirector Of Companies118055820001
    SMITH, Stephen Paul
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director148183670001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BROADGATE SQUARE LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Broadgate City Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    14 déc. 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement01769078
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    BROADGATE SQUARE LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge
    Créé le 05 févr. 1993
    Livré le 12 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement as amended by the override agreement
    Brèves mentions
    The benefit of account no.5001 101 4037 with the mortgagee in the name of the company (the rental account). The benefit of account no.5001 101 4038 with the mortgagee in the name of the company (the interest hedging account) (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • The Fuji Bank Limited (As Agent and Trustee for the Banks)
    Transactions
    • 12 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Group debenture
    Créé le 23 nov. 1992
    Livré le 01 déc. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the "overide agreement" dated 23RD november 1992 and this charge
    Brèves mentions
    See doc ref M98 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 déc. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 23 nov. 1992
    Livré le 25 nov. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement (as amended by the override agreement)
    Brèves mentions
    The benefit of each and every interest rate hedging agreement. Interest hedging account no.120588 And all monies standing to the credit thereof. All rents licence fees and other like sums. The benefit of rental account no.65692.
    Personnes ayant droit
    • American Express Bank Limited (As Agent and Trustee for the Banks)
    Transactions
    • 25 nov. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 30 sept. 1988
    Livré le 12 oct. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and as trustee to the banks under the terms of a loan agreement dated 26.9.88 and/or this charge
    Brèves mentions
    All that land lying to the north east of eldon street title no egl 158030 all that land at broad street station title no egl 179443 all that property described in the first schedule to a conveyance dated 25.11.87 and made between british railways board and the company title no egl 208120 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts.
    Personnes ayant droit
    • America Express Bank LTD
    Transactions
    • 12 oct. 1988Enregistrement d'une charge
    • 06 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 25 nov. 1987
    Livré le 09 déc. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a loan agreement dated 1ST july 1987 and under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All that property situate at the site of the former broad street station london EC2 being east of the junction of sun street & appold street forming part of the access to phases 1, 2, 3, 4 & 5 of the broadgate development london EC2 & all plant equipment & materials.
    Personnes ayant droit
    • American Express Bank LTD
    Transactions
    • 09 déc. 1987Enregistrement d'une charge
    • 18 nov. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second legal charge
    Créé le 25 nov. 1987
    Livré le 01 déc. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or rosehaugh stanhope developments PLC to british railways board under the terms of a principal agreement dated 2ND april 1985 and a deed of covenant dated 25.06.85 & the payment of the secured sums (as defined)
    Brèves mentions
    All that property situate to the east of sun street & appold street forming part of the access to phases 1, 2, 3, 4 & 5 of the broadgate development london EC2.
    Personnes ayant droit
    • British Railways Board
    Transactions
    • 01 déc. 1987Enregistrement d'une charge
    Second legal charge
    Créé le 25 nov. 1987
    Livré le 01 déc. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company and/or rosehaugh stanhope developments PLC to british railways board under the terms of a principal agreement dated 2/4/85 and a deed of covenant dated 25/6/85 and the payment of the secured sums (as defined).
    Brèves mentions
    All that property situate to the east of sun street, and appold street forming part of the access to phases 1,2,3,4 & 5 of the broadgate development london EC2.
    Personnes ayant droit
    • British Railways Board
    Transactions
    • 01 déc. 1987Enregistrement d'une charge
    Deed of charge
    Créé le 31 juil. 1986
    Livré le 05 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 25.6.85 and/or this charge
    Brèves mentions
    First legal mortgage over all property situate at broad street, station london E2. Fixed charge on all plant & equipment of the company from time to time upon the property described above and all materials belonging to the company at any time or from time to time situated thereon for the purpose of the development of the said property on behalf of the mortgagee.
    Personnes ayant droit
    • American Express Bank LTD
    Transactions
    • 05 août 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 31 juil. 1986
    Livré le 04 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The performance and observance of the obligations of rosehaugh stanhope developments PLC ("rsd") to the "board" ("british railways board") under the principal agreement dated 2ND april 1985 (as defined) and the chargor's obligations under the deed of covenant dated 25TH june 1985 (as defined) and/or all moneys due to the "board"(the "secured sums" as defined) registered pursuant to chapter 1 part xii of the companies act 1985. on the 14TH august 1986
    Brèves mentions
    Land on the site of the former broad street station london EC2 being part of the land described in the principal agreement as "sub site ii" (see doc for details).
    Personnes ayant droit
    • British Railways Board
    Transactions
    • 04 août 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 25 juin 1985
    Livré le 09 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or rosehaugh stanhope developments PLC. To the chargee pursuant to the principal agreement dated 2ND april, 1985 and a deed of covenant dated 25TH june, 1985.
    Brèves mentions
    Land forming part of the former goods yard to the west of broad street station, london, EC2. (See doc M21).
    Personnes ayant droit
    • British Railways Board
    Transactions
    • 09 juil. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 25 juin 1985
    Livré le 09 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or rosehaugh stanhope developments PLC to the chargee pursuant to a development agreement dated 2ND april, 1985 and a deed of covenant dated 25TH june, 1985.
    Brèves mentions
    The agregate of all monies (including interest) standing to the credit of the account of the company at barclays bank PLC, account no. 21082736. (see doc M20).
    Personnes ayant droit
    • British Railways Board
    Transactions
    • 09 juil. 1985Enregistrement d'une charge
    • 08 févr. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed charge
    Créé le 25 juin 1985
    Livré le 09 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or rosehaugh stanhope developments PLC to the chargee pursuant to the development agreement dated 2ND april, 1985 and a deed of covenant dated 25TH june 1985.
    Brèves mentions
    The principal sum maintained in the account of the company with barclays bank PLC being account no 21082744. (see doc M19).
    Personnes ayant droit
    • British Railways Board
    Transactions
    • 09 juil. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal & equitagle charge
    Créé le 25 juin 1985
    Livré le 27 juin 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Securing all moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 25.6.85 and/or this charge.
    Brèves mentions
    A) first legal mortgage over f/h & l/h property at broad st, station, london EC2 b) first fixed equitable charge over the f/h & l/h property acquired by the company c) first floating charge over the f/h & l/h property acquired by the company and the undertaking of the company and all its other property, assets, rights, present and future. (See doc M18 for details).
    Personnes ayant droit
    • American Express Bank LTD
    Transactions
    • 27 juin 1985Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0