LOYALTY FUSION PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLOYALTY FUSION PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 01800158
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LOYALTY FUSION PLC ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe LOYALTY FUSION PLC ?

    Adresse du siège social
    c/o CAP LLP
    Essex House
    Kelsall Street
    OL9 6HR Oldham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LOYALTY FUSION PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    C R P LEISURE PLC20 mars 199220 mars 1992
    P E KEMP HOLDINGS PLC16 avr. 198416 avr. 1984
    HALLDRAW LIMITED15 mars 198415 mars 1984

    Quels sont les derniers comptes de LOYALTY FUSION PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour LOYALTY FUSION PLC ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour LOYALTY FUSION PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    18 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 mai 2014

    État du capital au 21 mai 2014

    • Capital: GBP 606,390
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de First Floor Suite 17 Salmon Fields Business Village Royton Oldham OL2 6HT England le 20 mai 2014

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Martin Harris Cowen en tant que secrétaire le 01 déc. 2013

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Brian Francis Flannery en tant que secrétaire le 01 déc. 2013

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Martin Harris Cowen en tant que directeur le 11 janv. 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Red Valour Limited en tant qu'administrateur le 11 janv. 2014

    2 pagesAP02

    Cessation de la nomination de Robert Keith Allen en tant que directeur le 01 oct. 2013

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Brian Francis Flannery en tant qu'administrateur le 01 oct. 2013

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Martin Harris Cowen en tant que secrétaire le 08 nov. 2013

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Thomas Anthony Frost en tant que secrétaire le 08 nov. 2013

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    18 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Thomas Anthony Frost en tant que directeur le 06 mars 2013

    2 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    11 pagesAA

    Nomination de Martin Harris Cowen en tant qu'administrateur le 08 août 2012

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Martin Harris Cowen en tant que directeur le 05 juil. 2012

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    16 pagesAR01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed c r p leisure PLC\certificate issued on 14/04/12
    2 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    14 avr. 2012

    NOTICE OF CHANGE OF NAME NM01 - RESOLUTION

    CONNOT

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Changement d'adresse du siège social de 4Th Floor 36 Spital Square London E1 6DY le 27 févr. 2012

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de LOYALTY FUSION PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FLANNERY, Brian Francis
    c/o Cap Llp
    Kelsall Street
    OL9 6HR Oldham
    Essex House
    England
    Secrétaire
    c/o Cap Llp
    Kelsall Street
    OL9 6HR Oldham
    Essex House
    England
    184244010001
    FLANNERY, Brian Francis
    c/o Cap Llp
    Kelsall Street
    OL9 6HR Oldham
    Essex House
    England
    Administrateur
    c/o Cap Llp
    Kelsall Street
    OL9 6HR Oldham
    Essex House
    England
    United KingdomBritishCompany Director174869890001
    RED VALOUR LIMITED
    Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    22-25
    England
    Administrateur
    Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    22-25
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement08840843
    184211040001
    CHALMERS, John Gerald William
    3 Falcon Way
    Clippers Quay
    E14 9UP London
    Secrétaire
    3 Falcon Way
    Clippers Quay
    E14 9UP London
    British14302990001
    COWEN, Martin Harris
    Heywood Road
    Prestwich
    M25 1LB Manchester
    203
    England
    Secrétaire
    Heywood Road
    Prestwich
    M25 1LB Manchester
    203
    England
    183367200001
    COX, Michael Neill
    44 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Secrétaire
    44 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    British10600400003
    FRANKS, Harold
    4 Highwood
    Sunset Avenue
    IG8 0SZ Woodford Green
    Essex
    Secrétaire
    4 Highwood
    Sunset Avenue
    IG8 0SZ Woodford Green
    Essex
    British3930080001
    FROST, Thomas Anthony
    Salmon Fields Business Village
    Royton
    OL2 6HT Oldham
    First Floor Suite 17
    England
    Secrétaire
    Salmon Fields Business Village
    Royton
    OL2 6HT Oldham
    First Floor Suite 17
    England
    167042400001
    GRAY, George Douglas
    26 Green Street
    Lower Sunbury
    Middlesex
    Secrétaire
    26 Green Street
    Lower Sunbury
    Middlesex
    British66555340001
    JOHNSON, Luke Oliver
    28 Monmouth Road
    W2 4UT London
    Secrétaire
    28 Monmouth Road
    W2 4UT London
    British56699270001
    LYNN, Robert
    160 Pembroke Close
    SM7 2BH Banstead
    Surrey
    Secrétaire
    160 Pembroke Close
    SM7 2BH Banstead
    Surrey
    BritishChartered Accountant34423930001
    MAY, Graham Philip
    13 Penningtons
    CM23 4LE Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    13 Penningtons
    CM23 4LE Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British24814370002
    SOUTH, Richard Dawson
    Mill Bank 2 Cornmill Lane
    Bardsey
    LS17 9EQ Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Mill Bank 2 Cornmill Lane
    Bardsey
    LS17 9EQ Leeds
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant23327810001
    ALLEN, Robert Keith
    66 Arthur Road
    Wimbledon
    SW19 7DS London
    Administrateur
    66 Arthur Road
    Wimbledon
    SW19 7DS London
    EnglandEnglishCompany Director44871030002
    BATEMAN, Jeffrey Robert
    27-29 Ashley Road
    WA4 4TD Altrincham
    Fairbank House
    Cheshire
    Administrateur
    27-29 Ashley Road
    WA4 4TD Altrincham
    Fairbank House
    Cheshire
    EnglandEnglishDirector94879080001
    CHALMERS, John Gerald William
    3 Falcon Way
    Clippers Quay
    E14 9UP London
    Administrateur
    3 Falcon Way
    Clippers Quay
    E14 9UP London
    BritishManagement Consultant14302990001
    COWEN, Martin Harris
    Heywood Road
    M25 1LB Prestwich
    203
    Manchester
    England
    Administrateur
    Heywood Road
    M25 1LB Prestwich
    203
    Manchester
    England
    United KingdomBritishNone53320150001
    COWEN, Martin Harris
    Salmon Fields Business Village
    Royton
    OL2 6HT Oldham
    First Floor Suite 17
    England
    Administrateur
    Salmon Fields Business Village
    Royton
    OL2 6HT Oldham
    First Floor Suite 17
    England
    United KingdomBritishBusinessman53320150001
    CUNNINGHAM, David James Coulter
    904 Hood House
    Dolphin Square
    SW1V 3NL London
    Administrateur
    904 Hood House
    Dolphin Square
    SW1V 3NL London
    ScottishStockbroker26205070001
    DUFFY, Martin Bartlett
    5 Helding Close
    Broomfield
    CT6 7EF Herne Bay
    Kent
    Administrateur
    5 Helding Close
    Broomfield
    CT6 7EF Herne Bay
    Kent
    BritishCorporate Financier34997260001
    FRANKS, Harold
    4 Highwood
    Sunset Avenue
    IG8 0SZ Woodford Green
    Essex
    Administrateur
    4 Highwood
    Sunset Avenue
    IG8 0SZ Woodford Green
    Essex
    United KingdomBritishDirector3930080001
    FROST, Thomas Anthony
    Salmon Fields Business Village
    Royton
    OL2 6HT Oldham
    First Floor Suite 17
    England
    Administrateur
    Salmon Fields Business Village
    Royton
    OL2 6HT Oldham
    First Floor Suite 17
    England
    EnglandBritishBusinessman50114650001
    GRAY, George Douglas
    26 Green Street
    Lower Sunbury
    Middlesex
    Administrateur
    26 Green Street
    Lower Sunbury
    Middlesex
    BritishAccountant66555340001
    GREEN, Michael Hewitt, Dr
    4th Floor
    36 Spital Square
    E1 6DY London
    Administrateur
    4th Floor
    36 Spital Square
    E1 6DY London
    EnglandBritishBusinessman133440810002
    HOPE, Juliet
    Manor Cottage
    North Lane, South Harting
    GU31 5NW Petersfield
    Hampshire
    Administrateur
    Manor Cottage
    North Lane, South Harting
    GU31 5NW Petersfield
    Hampshire
    BritishInvestment Banker71047240001
    HORSMAN, Malcolm
    Jungmannova 14
    111 25 Praha 1
    Czech Republic
    Administrateur
    Jungmannova 14
    111 25 Praha 1
    Czech Republic
    BritishTrader47877020001
    JOHNSON, Luke Oliver
    28 Monmouth Road
    W2 4UT London
    Administrateur
    28 Monmouth Road
    W2 4UT London
    BritishDirector56699270001
    LEE, Dennis Harold
    10 The Spinney
    HP9 1SB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    10 The Spinney
    HP9 1SB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishDirector9771290001
    LOTTO, Giuliano Lorenzo
    Flat 2
    26 Harrington Gardens
    SW7 4LS London
    Administrateur
    Flat 2
    26 Harrington Gardens
    SW7 4LS London
    EnglandItalianCompany Director35366960002
    LOTTO, Giuliano Lorenzo
    48 Albeharle Street
    W1X 3FE London
    Administrateur
    48 Albeharle Street
    W1X 3FE London
    ItalianStockbroker35366960001
    LYNN, Robert
    160 Pembroke Close
    SM7 2BH Banstead
    Surrey
    Administrateur
    160 Pembroke Close
    SM7 2BH Banstead
    Surrey
    BritishChartered Accountant34423930001
    MILTON, Alan Christopher
    Melbury Cottage
    2 Melbury Road
    W14 8LP London
    Administrateur
    Melbury Cottage
    2 Melbury Road
    W14 8LP London
    United KingdomBritishDirector8892060001
    POPE, Martin Edward
    104 Woodsford Square
    W14 8DT London
    Administrateur
    104 Woodsford Square
    W14 8DT London
    BritishChartered Accountant24269840001
    PRICKETT, John Esmond
    55 Halkingcroft
    SL3 7BB Slough
    Berkshire
    Administrateur
    55 Halkingcroft
    SL3 7BB Slough
    Berkshire
    BritishElectrical Contractor8892070001
    PRIOR, William Frederick
    Lark Hill
    Parsons Road
    Heaton Bradford
    West Yorkshire
    Administrateur
    Lark Hill
    Parsons Road
    Heaton Bradford
    West Yorkshire
    United KingdomBritishPublisher32693180001

    LOYALTY FUSION PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 20 oct. 1995
    Livré le 09 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the £100,000.00 8% (gross) secured loan stock 1995
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • R a Coleman (North Wales) Limitedk)Stock Holders from Time to Time of the Loan Stoc(as Trustee for Itself and the Other Registered
    Transactions
    • 09 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Agreement
    Créé le 16 mars 1993
    Livré le 19 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £17,896.90 under the terms of the agreement
    Brèves mentions
    All rights title interest in and to all sums due under the insurances.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 19 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Credit agreement
    Créé le 06 déc. 1991
    Livré le 13 déc. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £19443.37 due or to become due from the company to the charge under the terms ofthe agreement
    Brèves mentions
    All sums payable under the insurance details as below policy traders comb insurers hallmark from 1/11/91 premium £18623.85.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 13 déc. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture and guarantee
    Créé le 08 nov. 1991
    Livré le 28 nov. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Gatedene Limited
    • Luke Johnson
    • Surrey Management Services Limited
    • Commandfield Properties Limited
    • United Properties Limited
    Transactions
    • 28 nov. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite debenture & guarantee
    Créé le 10 oct. 1991
    Livré le 26 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (See doc M395 for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Commenfield Properties Limited
    • Surrey Management Services Limited
    • United Properties Limited
    • Luke Johnson
    Transactions
    • 26 oct. 1991Enregistrement d'une charge
    • 28 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 19 avr. 1990
    Livré le 27 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 24 mars 1994Enregistrement d'une charge
    • 06 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 08 juin 1987
    Livré le 22 juin 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 1987Enregistrement d'une charge
    • 24 mars 1994Enregistrement d'une charge
    • 06 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 mai 1984
    Livré le 11 mai 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery see doc M14 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Houston Financila Services Limited.
    Transactions
    • 11 mai 1984Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 08 mai 1984
    Livré le 23 mai 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 mai 1984Enregistrement d'une charge
    • 24 mars 1994Enregistrement d'une charge
    • 07 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    LOYALTY FUSION PLC a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    11 juin 1998Date of meeting to approve CVA
    17 janv. 2000Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Lee Antony Manning
    Deloitte & Touche Llp
    180 Strand
    WC2R 1WL London
    practitioner
    Deloitte & Touche Llp
    180 Strand
    WC2R 1WL London
    Gary Peter Squires
    84 Grosvenor Street
    London
    W1X 9DF
    practitioner
    84 Grosvenor Street
    London
    W1X 9DF

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0