SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED

SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01809366
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED ?

    • Fabrication de cidre et d'autres vins de fruits (11030) / Industries manufacturières

    Où se situe SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Elsley Court
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BASKMIST LIMITED17 avr. 198417 avr. 1984

    Quels sont les derniers comptes de SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 08 déc. 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Nomination de Mr Josephus Petrus Adrianus Van Der Burg en tant qu'administrateur le 06 oct. 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Malcolm Dunn en tant qu'administrateur le 06 oct. 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr David Michael Forde en tant qu'administrateur le 06 oct. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Anne Louise Oliver en tant que directeur le 06 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Sean Michael Paterson en tant que directeur le 08 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Anne Louise Oliver en tant que secrétaire le 06 oct. 2014

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Anne Louise Oliver le 01 avr. 2014

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Sean Michael Paterson le 01 avr. 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Kelly Taylor-Welsh le 01 avr. 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Anne Louise Oliver le 01 avr. 2014

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Kelly Taylor-Welsh le 01 août 2012

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de John Charles Low en tant que directeur le 31 mars 2012

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DUNN, Malcolm James Shiel
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Administrateur
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    ScotlandBritish191401290001
    FORDE, David Michael
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Administrateur
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    IrelandIrish178655370001
    TAYLOR-WELSH, Kelly
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Administrateur
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    United KingdomBritish167915590003
    VAN DER BURG, Josephus Petrus Adrianus
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Administrateur
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    ScotlandDutch167853370002
    AVES, Simon Howard
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    Secrétaire
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    British132259650001
    OLIVER, Anne Louise
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Secrétaire
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    British132910690001
    STEBBINGS, William George
    Burghill
    HR4 7RX Hereford
    The Forge
    Herefordshire
    Secrétaire
    Burghill
    HR4 7RX Hereford
    The Forge
    Herefordshire
    British129413480001
    STEVENS, Mark
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    Secrétaire
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    British80951870003
    AITCHISON, Nicholas Martin Leslie
    Lower Barn
    Llancloudy
    HR2 8QR Hereford
    Herefordshire
    Administrateur
    Lower Barn
    Llancloudy
    HR2 8QR Hereford
    Herefordshire
    British6195750001
    AVES, Simon Howard
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    Administrateur
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    ScotlandBritish132259650001
    BOND, Denis Joseph Christopher
    Cricket Cottage
    Churchfield Cradley
    Malvern
    Worcestershire
    Administrateur
    Cricket Cottage
    Churchfield Cradley
    Malvern
    Worcestershire
    British26007550001
    BROWN, Colin Carlyle Campbell
    Little Bower
    10 Nuns Walk
    GU25 4RT Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    Little Bower
    10 Nuns Walk
    GU25 4RT Virginia Water
    Surrey
    British61755350001
    CRAWSHAY, William John Julian
    The Old Vicarage
    NE41 8AT Wylam
    Northumberland
    Administrateur
    The Old Vicarage
    NE41 8AT Wylam
    Northumberland
    United KingdomBritish79182280001
    DOOBAR, Mark Simon
    105 Canada Way
    Lower Wick
    WR2 4DG Worcester
    Administrateur
    105 Canada Way
    Lower Wick
    WR2 4DG Worcester
    British34501450002
    EGGLETON, Jonathan Philip
    Court Leet
    Church Road
    GL17 0LL Longhope
    Gloucestershire
    Administrateur
    Court Leet
    Church Road
    GL17 0LL Longhope
    Gloucestershire
    British83396140001
    FREER, Nigel
    Stoneham House
    Maund Common Bodenham
    HR1 3JB Hereford
    Herefordshire
    Administrateur
    Stoneham House
    Maund Common Bodenham
    HR1 3JB Hereford
    Herefordshire
    British59149820001
    FURSE, Timothy Machin
    Rock House
    Fownhope
    HR1 4NT Herefordshire
    Administrateur
    Rock House
    Fownhope
    HR1 4NT Herefordshire
    British32520640003
    GREGORY, Trevor John
    The Hollies
    HR2 8JE Llanwarne
    Herefordshire
    Administrateur
    The Hollies
    HR2 8JE Llanwarne
    Herefordshire
    United KingdomBritish106240790001
    HARRINGTON, Robert Arthur
    The Field House
    Back Lane Beckford
    GL20 7AF Tewkesbury
    Gloucestershire
    Administrateur
    The Field House
    Back Lane Beckford
    GL20 7AF Tewkesbury
    Gloucestershire
    British9899150004
    HITCHINER, Christopher David
    Dunan House
    Clehonger
    HR2 9SF Hereford
    Herefordshire
    Administrateur
    Dunan House
    Clehonger
    HR2 9SF Hereford
    Herefordshire
    United KingdomBritish71528270003
    HODDER, Anthony Mark
    New End Cottage
    Canon Pyon
    HR4 8NY Hereford
    Administrateur
    New End Cottage
    Canon Pyon
    HR4 8NY Hereford
    British60326120001
    HUGHES, Michael John
    3 Ailsa Road
    TW1 1QJ Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    3 Ailsa Road
    TW1 1QJ Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish101949350001
    JAMET, Jean Francois
    3 Sion Hill Place
    BA1 5SJ Bath
    Administrateur
    3 Sion Hill Place
    BA1 5SJ Bath
    EnglandFrench83396080001
    KIRKHOPE, Ian
    Vineyard Hill House
    34 Vineyard Road
    HR1 1TT Hereford
    Administrateur
    Vineyard Hill House
    34 Vineyard Road
    HR1 1TT Hereford
    British37450060001
    LOW, John Charles
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    Administrateur
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    United KingdomBritish162758370001
    OLIVER, Anne Louise
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Administrateur
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    United KingdomBritish132910690001
    PATERSON, Sean Michael
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Administrateur
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    ScotlandBritish141021760002
    PAYNE, William John
    Ashby House
    1 Bridge Street
    TW18 4TP Staines
    Middlesex
    Administrateur
    Ashby House
    1 Bridge Street
    TW18 4TP Staines
    Middlesex
    ScotlandBritish136005370001
    PENNYCOOK, Richard John
    Sherington Place
    MK16 9PD Sherington
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Sherington Place
    MK16 9PD Sherington
    Buckinghamshire
    British87825540001
    RUDGARD, John Kennish
    Claremont Court
    Swainshill
    HR4 7PU Hereford
    Herefordshire
    Administrateur
    Claremont Court
    Swainshill
    HR4 7PU Hereford
    Herefordshire
    British17349320001
    STEBBINGS, William George
    Burghill
    HR4 7RX Hereford
    The Forge
    Herefordshire
    Administrateur
    Burghill
    HR4 7RX Hereford
    The Forge
    Herefordshire
    British129413480001
    STEVENS, Mark
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    Administrateur
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    British80951870003
    SYMONDS, Neville Richard
    Drakewell
    Stoke Lacy
    HR7 4HG Bromyard
    Herefordshire
    Administrateur
    Drakewell
    Stoke Lacy
    HR7 4HG Bromyard
    Herefordshire
    United KingdomBritish9899170001
    TEDFORD, Craig
    Ashby House
    1 Bridge Street
    TW18 4TP Staines
    Middlesex
    Administrateur
    Ashby House
    1 Bridge Street
    TW18 4TP Staines
    Middlesex
    United KingdomBritish106867030001
    TEMPLEMAN, Miles Howard
    Whitmore Farm Church Road
    GU20 6BH Windlesham
    Surrey
    Administrateur
    Whitmore Farm Church Road
    GU20 6BH Windlesham
    Surrey
    United KingdomBritish15411870001

    SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security agreement
    Créé le 15 janv. 2003
    Livré le 22 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the group or any member or the group to any creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that f/h land k/a the land and buildings lying to the north of eign street, land at the junction of whitecross street and plough lane in the parish of all saints within the city of hereford numbered 111 and 111A, land k/a kings acre sports ground pentland gardens hereford and wells t/n HE9350 (for further properties charged refer to the form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Intercreditor Agent
    Transactions
    • 22 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 sept. 1986
    Livré le 08 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property at stoke comprising factory premises adjoining land the plough garage and public house. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Greenhall Whitley PLC
    Transactions
    • 08 oct. 1986Enregistrement d'une charge
    • 25 août 1988Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0