LEASECONTRACTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLEASECONTRACTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01810100
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LEASECONTRACTS LIMITED ?

    • Vente de voitures neuves et de véhicules légers (45111) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe LEASECONTRACTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LEASECONTRACTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    JORDANS 160 PUBLIC LIMITED COMPANY18 avr. 198418 avr. 1984

    Quels sont les derniers comptes de LEASECONTRACTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour LEASECONTRACTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 sept. 2023

    9 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 sept. 2022

    9 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 sept. 2021

    9 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 sept. 2020

    9 pagesLIQ03

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ United Kingdom à Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT United Kingdom à 1 More London Place London SE1 2AF le 17 oct. 2019

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 26 sept. 2019

    LRESSP

    Nomination de Oakwood Corporate Secretary Limited en tant que secrétaire le 23 juil. 2019

    2 pagesAP04

    Notification de Key Leasing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 juil. 2019

    2 pagesPSC02

    Cessation de Ige Usa Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 juil. 2019

    1 pagesPSC07

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Norris Andrew Geldard le 04 févr. 2019

    2 pagesCH01

    Modification des détails de Ige Usa Investments en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 nov. 2018

    2 pagesPSC05

    Cessation de la nomination de Anthony William Greenway en tant que directeur le 30 sept. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Norris Andrew Geldard en tant qu'administrateur le 10 sept. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Paul Stewart Girling en tant qu'administrateur le 10 sept. 2018

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    20 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ United Kingdom à 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT le 17 août 2018

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2018 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Notification de Ige Usa Investments en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Qui sont les dirigeants de LEASECONTRACTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement7038430
    146358090001
    GELDARD, Norris Andrew
    Century Way, Thorpe Park Business Park
    Colton
    LS15 8ZA Leeds
    1200
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Century Way, Thorpe Park Business Park
    Colton
    LS15 8ZA Leeds
    1200
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish244576750001
    GIRLING, Paul Stewart
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Administrateur
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish225432580001
    ABBOTT, Courtenay
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    Secrétaire
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    172560620001
    COOK, Michael Frederick
    Cracknut Hill House Haye Lane
    Mappleborough Green
    B80 7DS Studley
    Warwickshire
    Secrétaire
    Cracknut Hill House Haye Lane
    Mappleborough Green
    B80 7DS Studley
    Warwickshire
    British45103500001
    ESSEX, Alicia
    Old Hall Road
    Sale
    M33 2GZ Cheshire
    Secrétaire
    Old Hall Road
    Sale
    M33 2GZ Cheshire
    British55569560002
    FRENCH, Ann
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Secrétaire
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    161504050001
    JOHNSON, Paul Robert
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    Secrétaire
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    British106143590001
    KERSHAW, Simon John
    40 Sandacre Road
    M23 1AP Manchester
    Lancashire
    Secrétaire
    40 Sandacre Road
    M23 1AP Manchester
    Lancashire
    British106236300001
    PATMORE, Ian Robert
    Spring Bank Farm
    Lodge Lane
    OL13 0BJ Bacup
    Lancashire
    Secrétaire
    Spring Bank Farm
    Lodge Lane
    OL13 0BJ Bacup
    Lancashire
    British64498630002
    PEERMOHAMED, Zahra
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    Secrétaire
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    192967230001
    RYLATT, Diane
    Little Bouts Farmhouse Bouts Lane
    Inkberrow
    WR7 4HP Worcester
    Worcestershire
    Secrétaire
    Little Bouts Farmhouse Bouts Lane
    Inkberrow
    WR7 4HP Worcester
    Worcestershire
    British46068950001
    TAYLOR, Timothy John
    4 Thorngrove Road
    SK9 1DD Wilmslow
    Cheshire
    Secrétaire
    4 Thorngrove Road
    SK9 1DD Wilmslow
    Cheshire
    British42497260001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    COBBETTS (SECRETARIAL) LIMITED
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    Secrétaire
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    86546820001
    ANDERSON, Roger
    12 Blueberry Road
    Bowdon
    WA14 3LT Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    12 Blueberry Road
    Bowdon
    WA14 3LT Altrincham
    Cheshire
    British60138290001
    BECQUE, Geoffrey Frederick
    Clayfield House
    Danzey-Green Tanworth In Arden
    B94 5BG Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Clayfield House
    Danzey-Green Tanworth In Arden
    B94 5BG Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish14428770001
    BURR, Jonathan Charles
    15 Leicester Road
    Hale
    WA15 9QA Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    15 Leicester Road
    Hale
    WA15 9QA Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish49902210001
    CHAPMAN, Mark Andrew
    3 Fern Bank
    WA11 8DZ Rainford
    Merseyside
    Administrateur
    3 Fern Bank
    WA11 8DZ Rainford
    Merseyside
    British54283410002
    CHAPMAN, Mark Andrew
    16 Harrison Drive
    WA11 8HZ Rainford
    Merseyside
    Administrateur
    16 Harrison Drive
    WA11 8HZ Rainford
    Merseyside
    British54283410001
    COOK, Michael Frederick
    Cracknut Hill House Haye Lane
    Mappleborough Green
    B80 7DS Studley
    Warwickshire
    Administrateur
    Cracknut Hill House Haye Lane
    Mappleborough Green
    B80 7DS Studley
    Warwickshire
    EnglandBritish45103500001
    D'ADDA, Alessandro Pietro
    Thatched Lodge Bell Bank
    High St Welford On Avon
    CV37 8EA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    Thatched Lodge Bell Bank
    High St Welford On Avon
    CV37 8EA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritish47772540001
    DOWLING, Christopher Bruce
    Rutland House
    Rutland Gardens
    SW7 1BX Knightsbridge
    London
    Administrateur
    Rutland House
    Rutland Gardens
    SW7 1BX Knightsbridge
    London
    Australian28868820001
    DUFF, Paul Anthony
    6 Newby Drive
    Gatley
    SK8 4EJ Cheadle
    Cheshire
    Administrateur
    6 Newby Drive
    Gatley
    SK8 4EJ Cheadle
    Cheshire
    British122035530001
    FARRAR, Daniel
    The Coach House Gravel Lane
    SK9 6EG Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    The Coach House Gravel Lane
    SK9 6EG Wilmslow
    Cheshire
    British42497200001
    FITZPATRICK, Hugh Alan Taylor
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    United KingdomBritish139406230001
    FORD, Toby Duncan
    Trinity Square
    23-59 Staines Road
    TW3 3HF Hounslow
    Meridian
    Middlesex
    Administrateur
    Trinity Square
    23-59 Staines Road
    TW3 3HF Hounslow
    Meridian
    Middlesex
    United KingdomBritish148654320001
    GREEN, Richard William
    Richborough House
    Sandy Lane Sunningdale
    SL5 0ND Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Richborough House
    Sandy Lane Sunningdale
    SL5 0ND Ascot
    Berkshire
    British121346530001
    GREENWAY, Anthony William
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish202871130001
    HUDDART, Steven John
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    Administrateur
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    EnglandEnglish191546760001
    JEANS, Roderick Manning
    1 Penelope Gardens
    Wickhamford
    WR11 6SG Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    1 Penelope Gardens
    Wickhamford
    WR11 6SG Evesham
    Worcestershire
    British50601570001
    JENKINS, John Michael
    Trinity Square
    23/59 Staines Road
    TW3 3HF Hounslow
    Meridian
    Middlesex
    England
    Administrateur
    Trinity Square
    23/59 Staines Road
    TW3 3HF Hounslow
    Meridian
    Middlesex
    England
    EnglandBritish115008010001
    KILLEEN, Gary Francis Paul
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    EnglandEnglish81330540001
    LANGDON, Michael Robert Finch
    29 Sumner Place
    SW7 3NT London
    Administrateur
    29 Sumner Place
    SW7 3NT London
    EnglandBritish1483050001
    LOMAS, Paul John
    12 Burwardsley Way
    Kingsmead
    CW9 8WN Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    12 Burwardsley Way
    Kingsmead
    CW9 8WN Northwich
    Cheshire
    United KingdomBritish127596100001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LEASECONTRACTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    23 juil. 2019
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement1500252
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Oui
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement3255766
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    LEASECONTRACTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge agreement
    Créé le 02 août 1995
    Livré le 08 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £404,822.57 and all other monies due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge agreement
    Brèves mentions
    All the rights and interests of the company under the agreements date 7/6/95 contract no 1030474 vehicle hire agreement model vauxhall brava 2.5I a/c no 34. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 08 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 02 août 1995
    Livré le 08 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £45,553.63 and all other monies due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge agreement
    Brèves mentions
    All the rights and interests of the company under the agreements :- date 2.6.95 contract no 1030728 vehicle hire agreement model ford transit 2.5 regn no M289 yhj a/c/no 22. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 08 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 02 août 1995
    Livré le 08 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £160,099.17 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    Brèves mentions
    All the rights and interests of the company under the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 08 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 02 août 1995
    Livré le 08 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £349,787.92 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    Brèves mentions
    All the rights title and interests of the company under the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 08 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 02 août 1995
    Livré le 08 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £87,116.29 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    Brèves mentions
    All the rights and interests of the company under the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 08 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 02 août 1995
    Livré le 08 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £13,933.14 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    Brèves mentions
    All the rights of the company under the agreements specified. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 08 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 02 août 1995
    Livré le 08 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £27,772.02 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    Brèves mentions
    All the rights and interests of the company under the agreements specified. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 08 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    First charge
    Créé le 28 juin 1995
    Livré le 12 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 12TH december 1994 and/or this charge
    Brèves mentions
    The company assigns and charges to the bank by way of first fixed legal charge:- (I) all the benefits rights and title of the company in the contracts; and (ii) each and every motor vehicle from time to time subject of the contracts (the "motor vehicles"). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Singer & Friedlander Limited
    Transactions
    • 12 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Certificate of assignment
    Créé le 26 juin 1995
    Livré le 01 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a hire purchase agreement dated 3/11/94
    Brèves mentions
    All rights benefits and interest present and future in and to the sub-hire agreements :- sub-hirer sony united kingdom limited ford mondeo 2OI glx h/back regn no M301 mpd. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sovereign Finances PLC
    Transactions
    • 01 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Certificate of assignment
    Créé le 04 mai 1995
    Livré le 09 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a hire purchase agreement dated 3/11/94
    Brèves mentions
    All rights benefits and interest present and future in and to sub-hire agreements made between various sub-hirers. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sovereign Finance PLC
    Transactions
    • 09 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Certificate of assignment
    Créé le 19 avr. 1995
    Livré le 26 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreemnts
    Brèves mentions
    All monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements the benefit of all guarantees :- customer no 021766 schedule no 000015 agreement no 01/308/01/513884 reg no M29 eea rover 214SE1 41 customer ref 1028472. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nws Bank PLC
    Transactions
    • 26 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 23 mars 1995
    Livré le 08 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £222,479.54 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Brèves mentions
    All the rights title and interest of the company in the attached schedule contract no 1027675 agreement vehicle contract purchase reg no M217 odp make rover 2.0I. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 08 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 23 mars 1995
    Livré le 29 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £221,528.88 and all other moneys due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under the terms of the agreement
    Brèves mentions
    All the rights title and interest of the company in and under the agreements ,as specified in the schedule. All monies now or hereafter to become payable under the said agreements, the vehicles comprised in and the subject of the said agreements,all monies from time to time payable under any insurance payable in respect of the said vehicles. Please see doc for further details,.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 29 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 23 mars 1995
    Livré le 29 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £75,555.25 and all other monies due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under or pursuant to the terms of the agreement
    Brèves mentions
    All rights title and interest in and under the said agreements ,all monies now or hereafter to become payable under the agreements, the vehicles comprised in and the subject of the said agreements, all monies from time to time payable under the insurance in respect of the said vehicles. Please see doc for further details,.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 29 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 23 mars 1995
    Livré le 29 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £229,169.13 together with all other monies due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under the terms of the agreement
    Brèves mentions
    Specific charge over all the rights and interests of the company under the agreements specified in the schedule, all monies now or hereafter to become payable under the said agreements , the vehicles comprised in and the subject of the said agreements, all insurances payable in respect of the said vehicles. Please see doc for further details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 29 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Certificate of assignment
    Créé le 09 déc. 1994
    Livré le 22 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreements
    Brèves mentions
    All monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nws Bank PLC
    Transactions
    • 22 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Master assignment
    Créé le 05 déc. 1994
    Livré le 22 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agrements
    Brèves mentions
    All monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedules attached to the form 395 entered into pursuant to the master assignment.
    Personnes ayant droit
    • Nws Bank PLC
    Transactions
    • 22 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 25 nov. 1994
    Livré le 02 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £359,353.33 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Brèves mentions
    All the rights and interests of the company under the agreements date-22.9.94, Contract no.-1025575, Type of agreement-vehicle contract purchase, period of agt-48, reg no-M113 xow, make/model-honda civic. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 02 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 25 nov. 1994
    Livré le 02 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £135,919.45 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All the rights and interests of the company under the agreements date-8.11.94, Contract no-1025865, type of agreement-vehicle contract purchase, period of agt-42, reg no-M108 njb, make/model-renault 19. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 02 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 25 nov. 1994
    Livré le 02 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £36,467.67 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Brèves mentions
    All the rights and interests of the company under the agreements date-25.10.94, Contract no.-1026204, Type of agreement-schedule to master agreement, period of agt-12, reg no.-M791 jpf, make/model-rover 200 1.4I. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 02 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 25 nov. 1994
    Livré le 02 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £58,680.10 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Brèves mentions
    All the rights and interests of the company under the agreements date-28.9.94, Contract no.-1026224, Type of agreement-vehicle hire agreement, period of agt-24, reg no.-L416 kto, make/model-vw passat. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 02 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 25 nov. 1994
    Livré le 02 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £47,047.49 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Brèves mentions
    All the rights and interests of the company under the agreements date-18.10.94, Contract no-1026870, type of agreement-vehicle hire agreement, period of agt-28, reg no.-L753JCF, make/model-vauxhall frontera. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 02 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 25 nov. 1994
    Livré le 02 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £270,688.25 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Brèves mentions
    All the rights and interests of the company under the agreements date-9.11.94, Contract no.-1027231, Type of agreement-vehicle hire agreement, period of agt-36, reg no.-L688 sav, make/model-rover 600 2.01. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 02 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Master assignment and certificte of assignment
    Créé le 03 nov. 1994
    Livré le 04 nov. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement of even date
    Brèves mentions
    All rights benefit and interest present and future in and 70 sub-hiring agreements :- ford granada 2.01 scorpio 4 dr saloon sin auto. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sovereign Finance PLC
    Transactions
    • 04 nov. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 13 juil. 1994
    Livré le 16 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £107,344.53 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement.
    Brèves mentions
    All the rights and interests of the company under the agreements specified in the attached schedule. All monies now or hereafter to become payable under the said agreements. The vehicles comprised in and the subject of the said agreements as specified in the said schedule, and all monies from time to time payable under any insurance in respect of the said vehicles. The terms applicable to the charge agreement restrict the creation of any other charge whatsoever over the charged property.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 16 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    LEASECONTRACTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    11 juin 2024Due to be dissolved on
    26 sept. 2019Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0