RALPH CUTHBERT (STOCKPORT) LIMITED

RALPH CUTHBERT (STOCKPORT) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRALPH CUTHBERT (STOCKPORT) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01810534
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RALPH CUTHBERT (STOCKPORT) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe RALPH CUTHBERT (STOCKPORT) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de RALPH CUTHBERT (STOCKPORT) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour RALPH CUTHBERT (STOCKPORT) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 déc. 2011

    État du capital au 22 déc. 2011

    • Capital: GBP 15
    SH01

    Cessation de la nomination de Peter Smerdon en tant que directeur le 01 août 2011

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr William Shepherd en tant qu'administrateur le 01 août 2011

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    3 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Jennifer Anne Brierley le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    3 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    3 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    3 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Qui sont les dirigeants de RALPH CUTHBERT (STOCKPORT) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRIERLEY, Jennifer Anne
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Secrétaire
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    British118563210001
    SHEPHERD, William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Great BritainBritish162873980001
    WILLETTS, Andrew John
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish120451550002
    BEV DAVID, Vivienne
    11 Ingledene Avenue
    Broughton Park
    M7 4GX Salford 7
    Greater Manchester
    Secrétaire
    11 Ingledene Avenue
    Broughton Park
    M7 4GX Salford 7
    Greater Manchester
    British38325410001
    BUCKELL, Stephen William
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    Secrétaire
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    British20341960001
    DAVIES, John Richard Bridge
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    Secrétaire
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    British51554100001
    HEATON, Janet Ruth
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    Secrétaire
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    British81228260001
    LITTMAN, Geoffrey
    13 Dunham Rise
    WA14 2BB Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    13 Dunham Rise
    WA14 2BB Altrincham
    Cheshire
    British75360670001
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    Secrétaire
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    SADLER, John Michael
    12 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midland
    Secrétaire
    12 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midland
    British44018260001
    SMERDON, Peter
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    Secrétaire
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    British16898700002
    BEN-DAVID, Vivienne
    Inglefield Avenue
    Salford 7
    Administrateur
    Inglefield Avenue
    Salford 7
    British24874830002
    BUCKELL, Stephen William
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    Administrateur
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    British20341960001
    FELLOWS, Jonathan
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish118296490001
    HARDY, Martyn James
    The Corner House
    Preston Bagott
    B95 5EH Henley-In-Arden
    Warwickshire
    Administrateur
    The Corner House
    Preston Bagott
    B95 5EH Henley-In-Arden
    Warwickshire
    British74148120001
    HOOD, John
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    Administrateur
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    British39644740002
    KERSHAW, Graham Anthony
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    Administrateur
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    United KingdomBritish8991780003
    LLOYD, Allen John
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    Administrateur
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    British2270630001
    LLOYD, Peter Edward
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    British35546210001
    MEISTER, Stefan Mario
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Administrateur
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Swiss43550520003
    MISCHKE, Gerhard Viktor
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Germany62107000001
    MOORE, Dean
    Bleak House
    Oaks Road
    LE67 5UP Whitwick
    Leicestershire
    Administrateur
    Bleak House
    Oaks Road
    LE67 5UP Whitwick
    Leicestershire
    British94541520001
    OGILVIE, Alison Turner
    163 Broadstone Road
    Heaton Chapel
    SK4 5HS Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    163 Broadstone Road
    Heaton Chapel
    SK4 5HS Stockport
    Cheshire
    British40592900001
    SMERDON, Peter
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish16898700002
    TURNER, Richard Gill
    The Old Coach House Mill Lane
    Sheepy Parva
    CV9 3RL Atherstone
    Warwickshire
    Administrateur
    The Old Coach House Mill Lane
    Sheepy Parva
    CV9 3RL Atherstone
    Warwickshire
    British51796560002
    VIZARD, Ronald Charles, Harold
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    British122881190001
    WARD, Michael Ashley
    Flat 603 Shad Thames
    SE1 2YL London
    Administrateur
    Flat 603 Shad Thames
    SE1 2YL London
    EnglandBritish114711020001
    WAXMAN, Alison Lesley
    973 Manchester Road
    BL9 8DN Bury
    Lancashire
    Administrateur
    973 Manchester Road
    BL9 8DN Bury
    Lancashire
    British29894990001
    WAXMAN, David Philip
    12 Grosvenor House Mews
    Crumpsall
    M8 4WL Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    12 Grosvenor House Mews
    Crumpsall
    M8 4WL Manchester
    Lancashire
    British5570190001
    WAXMAN, Judith
    973 Manchester Road
    BL9 8DN Bury
    Lancashire
    Administrateur
    973 Manchester Road
    BL9 8DN Bury
    Lancashire
    British24874820001
    WAXMAN, Michael Richard
    98 Druids Cross Road
    Woolton
    L18 3HN Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    98 Druids Cross Road
    Woolton
    L18 3HN Liverpool
    Merseyside
    British68905180001

    RALPH CUTHBERT (STOCKPORT) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 18 oct. 1988
    Livré le 26 oct. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 oct. 1988Enregistrement d'une charge
    • 05 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0