WHITE PROPERTY SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | WHITE PROPERTY SERVICES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01811737 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe WHITE PROPERTY SERVICES LIMITED ?
Adresse du siège social | Suite 6c, The Plaza 100 Old Hall Street L3 9QJ Liverpool England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de WHITE PROPERTY SERVICES LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour WHITE PROPERTY SERVICES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2022 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 2nd Floor, Exchange Court 1 Dale Street Liverpool Merseyside L2 2PP England à Suite 6C, the Plaza 100 Old Hall Street Liverpool L3 9QJ le 03 août 2022 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2021 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2020 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2019 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2018 | 5 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Lisa Greenhalgh en tant que directeur le 17 mai 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Jeffrey Colin Cummins en tant qu'administrateur le 14 juin 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Changement d'adresse du siège social de C/O Bdo Llp 6th Floor 3 Hardman Street Spinningfields Manchester M3 3AT à 2nd Floor, Exchange Court 1 Dale Street Liverpool Merseyside L2 2PP le 03 janv. 2019 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2017 | 4 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mrs Lisa Greenhalgh en tant qu'administrateur le 15 janv. 2018 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Raymond Leslie Hardman en tant que directeur le 08 oct. 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Anthony Robert Blagbrough en tant que directeur le 08 oct. 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Stewart Bonnette en tant que directeur le 08 oct. 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Afm Merseyside Mezzanine Ltd en tant qu'administrateur le 08 oct. 2017 | 2 pages | AP02 | ||
Qui sont les dirigeants de WHITE PROPERTY SERVICES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUMMINS, Jeffrey Colin | Administrateur | 100 Old Hall Street L3 9QJ Liverpool Suite 6c, The Plaza England | England | British | Portfolio Manager | 259490720001 | ||||||||
AFM MERSEYSIDE MEZZANINE LTD | Administrateur | 1 Dale Street L2 2PP Liverpool 2nd Floor Exchange Court United Kingdom |
| 238747770001 | ||||||||||
AFM MERSEYSIDE VENTURES LTD | Administrateur | 1 Dale Street L2 2PP Liverpool 2nd Floor Exchange Court United Kingdom |
| 238747760001 | ||||||||||
BLAGBROUGH, Anthony Robert | Secrétaire | 65 Shaw Road SK4 4AL Stockport Cheshire | British | Director | 65700160001 | |||||||||
BONNETTE, Stewart | Secrétaire | 7 Bracknel Way L39 3RQ Aughton Lancashire | British | Director | 78254910003 | |||||||||
HOPKINS-COMAN, Neil | Secrétaire | 10 The Belfry FY8 4NW Lytham Lancashire | British | 78074970001 | ||||||||||
ROBINSON, Alan | Secrétaire | 303 Manchester Road West Worsley M38 9XH Manchester Lancashire | British | 2431460001 | ||||||||||
BARKER, John | Administrateur | 1 Ash Grove Rainford WA11 8DU St Helens Merseyside | British | Director | 37235870001 | |||||||||
BLAGBROUGH, Anthony Robert | Administrateur | 65 Shaw Road SK4 4AL Stockport Cheshire | England | British | Director | 65700160001 | ||||||||
BONNETTE, Stewart | Administrateur | 7 Bracknel Way L39 3RQ Aughton Lancashire | England | British | Director | 78254910003 | ||||||||
FISHER, Geoffrey Arthur | Administrateur | 106 Kenyon Lane Croft WA3 4AY Warrington Cheshire | British | Director | 3028990001 | |||||||||
GARNER, John | Administrateur | 250 Dentons Green Lane WA10 6RY St Helens Merseyside | British | Director | 2431470001 | |||||||||
GREENHALGH, Lisa | Administrateur | 1 Dale Street L2 2PP Liverpool 2nd Floor, Exchange Court Merseyside England | England | British | Director | 102373230001 | ||||||||
HARDMAN, Raymond Leslie | Administrateur | 85 Seal Road Bramhall SK7 2LE Stockport Cheshire | England | British | Director | 2431510001 | ||||||||
HOPKINS-COMAN, Neil | Administrateur | 10 The Belfry FY8 4NW Lytham Lancashire | England | British | Finance Director | 78074970001 | ||||||||
KILROE, Cassie Marie | Administrateur | 5 Kings Acre Bowdon WA14 3SE Altrincham Cheshire | British | Director | 57217510001 | |||||||||
KILROE, Timothy Anthony | Administrateur | 5 Kings Acre Bowdon WA14 3SE Altrincham Cheshire | British | Director | 17402130002 | |||||||||
MOORE, Colin | Administrateur | Windy Bank House Silverdale Road WA12 0JT Newton Le Willows Merseyside | British | Director | 2431530002 | |||||||||
TILBROOK, Allan Stephen | Administrateur | Radnor Drive PL9 9LR Southport 26 Merseyside | England | British | Director | 129684760001 | ||||||||
WHITE, Terence Gerald | Administrateur | 12 Kings Close Bramhall SK7 3BN Stockport Cheshire | British | Accountant | 812440002 | |||||||||
WHITE, Terence Stanley | Administrateur | High Trees Ballabodie Drive Quarterbridge ISLE MAN Douglas Isle Of Man | British | Director | 2431500001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WHITE PROPERTY SERVICES LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brabco 316 Ltd | 06 avr. 2016 | 6th Floor 3 Hardman Street M3 3AT Manchester Bdo England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
WHITE PROPERTY SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Charge | Créé le 01 juin 2009 Livré le 04 juin 2009 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge all amounts recoverable or receivable pursuant to a joint venture agreement see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Supplemental deed to a debenture dated 28 june 2006 and | Créé le 30 juil. 2007 Livré le 15 août 2007 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital copyrights chattels stocks shares. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 28 juin 2006 Livré le 01 juil. 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of first fixed charge all future f/h and l/h property the goodwill and its uncalled capital all receivables by way of first floating charge all its undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever situates, both present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 08 juil. 2005 Livré le 14 juil. 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 08 juil. 2005 Livré le 13 juil. 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture containing fixed and floating charges | Créé le 04 juil. 2003 Livré le 16 juil. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 18 déc. 2000 Livré le 19 déc. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 24 janv. 2000 Livré le 27 janv. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 21 juin 1991 Livré le 09 juil. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or f & f s white limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions (See doc M809 c for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0