WHITE PROPERTY SERVICES LIMITED

WHITE PROPERTY SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWHITE PROPERTY SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01811737
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WHITE PROPERTY SERVICES LIMITED ?

    • Construction de bâtiments commerciaux (41201) / Construction

    Où se situe WHITE PROPERTY SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Suite 6c, The Plaza
    100 Old Hall Street
    L3 9QJ Liverpool
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WHITE PROPERTY SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BETHELL PROPERTY SERVICES LIMITED23 oct. 200123 oct. 2001
    BETHELL-WHITE BUILDING SERVICES LIMITED30 juil. 199830 juil. 1998
    WHITE BUILDING SERVICES LIMITED 27 avr. 198427 avr. 1984

    Quels sont les derniers comptes de WHITE PROPERTY SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour WHITE PROPERTY SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2022

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 2nd Floor, Exchange Court 1 Dale Street Liverpool Merseyside L2 2PP England à Suite 6C, the Plaza 100 Old Hall Street Liverpool L3 9QJ le 03 août 2022

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2021

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2020

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2019

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2018

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Lisa Greenhalgh en tant que directeur le 17 mai 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Jeffrey Colin Cummins en tant qu'administrateur le 14 juin 2019

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Bdo Llp 6th Floor 3 Hardman Street Spinningfields Manchester M3 3AT à 2nd Floor, Exchange Court 1 Dale Street Liverpool Merseyside L2 2PP le 03 janv. 2019

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2017

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mrs Lisa Greenhalgh en tant qu'administrateur le 15 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Raymond Leslie Hardman en tant que directeur le 08 oct. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Anthony Robert Blagbrough en tant que directeur le 08 oct. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Stewart Bonnette en tant que directeur le 08 oct. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Afm Merseyside Mezzanine Ltd en tant qu'administrateur le 08 oct. 2017

    2 pagesAP02

    Qui sont les dirigeants de WHITE PROPERTY SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CUMMINS, Jeffrey Colin
    100 Old Hall Street
    L3 9QJ Liverpool
    Suite 6c, The Plaza
    England
    Administrateur
    100 Old Hall Street
    L3 9QJ Liverpool
    Suite 6c, The Plaza
    England
    EnglandBritishPortfolio Manager259490720001
    AFM MERSEYSIDE MEZZANINE LTD
    1 Dale Street
    L2 2PP Liverpool
    2nd Floor Exchange Court
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Dale Street
    L2 2PP Liverpool
    2nd Floor Exchange Court
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement04274732
    238747770001
    AFM MERSEYSIDE VENTURES LTD
    1 Dale Street
    L2 2PP Liverpool
    2nd Floor Exchange Court
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Dale Street
    L2 2PP Liverpool
    2nd Floor Exchange Court
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement04274737
    238747760001
    BLAGBROUGH, Anthony Robert
    65 Shaw Road
    SK4 4AL Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    65 Shaw Road
    SK4 4AL Stockport
    Cheshire
    BritishDirector65700160001
    BONNETTE, Stewart
    7 Bracknel Way
    L39 3RQ Aughton
    Lancashire
    Secrétaire
    7 Bracknel Way
    L39 3RQ Aughton
    Lancashire
    BritishDirector78254910003
    HOPKINS-COMAN, Neil
    10 The Belfry
    FY8 4NW Lytham
    Lancashire
    Secrétaire
    10 The Belfry
    FY8 4NW Lytham
    Lancashire
    British78074970001
    ROBINSON, Alan
    303 Manchester Road West
    Worsley
    M38 9XH Manchester
    Lancashire
    Secrétaire
    303 Manchester Road West
    Worsley
    M38 9XH Manchester
    Lancashire
    British2431460001
    BARKER, John
    1 Ash Grove
    Rainford
    WA11 8DU St Helens
    Merseyside
    Administrateur
    1 Ash Grove
    Rainford
    WA11 8DU St Helens
    Merseyside
    BritishDirector37235870001
    BLAGBROUGH, Anthony Robert
    65 Shaw Road
    SK4 4AL Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    65 Shaw Road
    SK4 4AL Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishDirector65700160001
    BONNETTE, Stewart
    7 Bracknel Way
    L39 3RQ Aughton
    Lancashire
    Administrateur
    7 Bracknel Way
    L39 3RQ Aughton
    Lancashire
    EnglandBritishDirector78254910003
    FISHER, Geoffrey Arthur
    106 Kenyon Lane
    Croft
    WA3 4AY Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    106 Kenyon Lane
    Croft
    WA3 4AY Warrington
    Cheshire
    BritishDirector3028990001
    GARNER, John
    250 Dentons Green Lane
    WA10 6RY St Helens
    Merseyside
    Administrateur
    250 Dentons Green Lane
    WA10 6RY St Helens
    Merseyside
    BritishDirector2431470001
    GREENHALGH, Lisa
    1 Dale Street
    L2 2PP Liverpool
    2nd Floor, Exchange Court
    Merseyside
    England
    Administrateur
    1 Dale Street
    L2 2PP Liverpool
    2nd Floor, Exchange Court
    Merseyside
    England
    EnglandBritishDirector102373230001
    HARDMAN, Raymond Leslie
    85 Seal Road
    Bramhall
    SK7 2LE Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    85 Seal Road
    Bramhall
    SK7 2LE Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishDirector2431510001
    HOPKINS-COMAN, Neil
    10 The Belfry
    FY8 4NW Lytham
    Lancashire
    Administrateur
    10 The Belfry
    FY8 4NW Lytham
    Lancashire
    EnglandBritishFinance Director78074970001
    KILROE, Cassie Marie
    5 Kings Acre
    Bowdon
    WA14 3SE Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    5 Kings Acre
    Bowdon
    WA14 3SE Altrincham
    Cheshire
    BritishDirector57217510001
    KILROE, Timothy Anthony
    5 Kings Acre
    Bowdon
    WA14 3SE Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    5 Kings Acre
    Bowdon
    WA14 3SE Altrincham
    Cheshire
    BritishDirector17402130002
    MOORE, Colin
    Windy Bank House Silverdale Road
    WA12 0JT Newton Le Willows
    Merseyside
    Administrateur
    Windy Bank House Silverdale Road
    WA12 0JT Newton Le Willows
    Merseyside
    BritishDirector2431530002
    TILBROOK, Allan Stephen
    Radnor Drive
    PL9 9LR Southport
    26
    Merseyside
    Administrateur
    Radnor Drive
    PL9 9LR Southport
    26
    Merseyside
    EnglandBritishDirector129684760001
    WHITE, Terence Gerald
    12 Kings Close
    Bramhall
    SK7 3BN Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    12 Kings Close
    Bramhall
    SK7 3BN Stockport
    Cheshire
    BritishAccountant812440002
    WHITE, Terence Stanley
    High Trees Ballabodie Drive
    Quarterbridge
    ISLE MAN Douglas
    Isle Of Man
    Administrateur
    High Trees Ballabodie Drive
    Quarterbridge
    ISLE MAN Douglas
    Isle Of Man
    BritishDirector2431500001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WHITE PROPERTY SERVICES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Brabco 316 Ltd
    6th Floor 3 Hardman Street
    M3 3AT Manchester
    Bdo
    England
    06 avr. 2016
    6th Floor 3 Hardman Street
    M3 3AT Manchester
    Bdo
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland & Wales
    Lieu d'enregistrementLondon
    Numéro d'enregistrement04715222
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    WHITE PROPERTY SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge
    Créé le 01 juin 2009
    Livré le 04 juin 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge all amounts recoverable or receivable pursuant to a joint venture agreement see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Merseyside Special Investment Mezzanine Fund No.2
    Transactions
    • 04 juin 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental deed to a debenture dated 28 june 2006 and
    Créé le 30 juil. 2007
    Livré le 15 août 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital copyrights chattels stocks shares. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Merseyside Special Investment Venture Fund No 3 Acting by Its General Partner Afm Merseysideventures Limited and Alliance Fund Managers Nominees Limited
    Transactions
    • 15 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 28 juin 2006
    Livré le 01 juil. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all future f/h and l/h property the goodwill and its uncalled capital all receivables by way of first floating charge all its undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever situates, both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Merseyside Special Investment Venture Fund No 3, a Limited Liability Partnership, Acting by Its General Partner, Afm Merseyside Ventures Limite
    • Merseyside Special Investment Venture Fund No 3, a Limited Liability Partnership, Acting by Itsd
    Transactions
    • 01 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 08 juil. 2005
    Livré le 14 juil. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 08 juil. 2005
    Livré le 13 juil. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Merseyside Special Investment Mezzanine Fund No.2
    Transactions
    • 13 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture containing fixed and floating charges
    Créé le 04 juil. 2003
    Livré le 16 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 16 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 déc. 2000
    Livré le 19 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 janv. 2000
    Livré le 27 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 21 juin 1991
    Livré le 09 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or f & f s white limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    (See doc M809 c for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 20 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0