ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED

ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01817913
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED ?

    • Autres activités de services informatiques (62090) / Information et communication

    Où se situe ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Royal Pavilion
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Hampshire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TOREX RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED12 juin 200212 juin 2002
    AMERSHAM MEDICAL SYSTEMS LIMITED21 mai 198421 mai 1984

    Quels sont les derniers comptes de ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Période comptable précédente prolongée du 31 mars 2013 au 30 sept. 2013

    3 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Andrew Thomson en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 août 2013

    État du capital au 27 août 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    État du capital au 24 juin 2013

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Company business 29/03/2013
    RES13

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Nomination de David William Hart Gray en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Gareth Wilson en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    15 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    34 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré

    1 pagesAD04

    Cessation de la nomination de Adrian Stevens en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2011

    17 pagesAA

    Période comptable actuelle raccourcie du 30 juin 2012 au 31 mars 2012

    1 pagesAA01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Adrian Charles Stevens le 12 sept. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew James Edward Thomson le 12 sept. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Gareth Antony Wilson le 12 sept. 2011

    2 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrea Fiumicelli le 12 sept. 2011

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Csc Computer Sciences International Ltd Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ United Kingdom* le 18 août 2011

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Isoft Group Plc Daventry Road Banbury Oxfordshire OX16 3JT* le 05 août 2011

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GRAY, David William Hart
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    British177357740001
    FIUMICELLI, Andrea
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    ItalyItalianCompany Director135619020001
    CRABTREE, Nicholas Patrick
    Sherwood 11 Green Lane
    Chesham Bois
    HP6 5LN Amersham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Sherwood 11 Green Lane
    Chesham Bois
    HP6 5LN Amersham
    Buckinghamshire
    BritishComputer Consultant17678130002
    EDELMAN, Howard Todd
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    Secrétaire
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    AustralianCompany Secretary126124430005
    HILL, Teifion Mark
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    British100105520001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    British109926660001
    MEIRE, Hylton Bruce
    30 Durham Avenue
    BR2 0QB Bromley
    Kent
    Secrétaire
    30 Durham Avenue
    BR2 0QB Bromley
    Kent
    British5361780001
    WILSON, Gareth Antony
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    162045740001
    CLARKE, Robert Samuel
    4 Lyne Way
    Warners End
    HP1 3PL Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Administrateur
    4 Lyne Way
    Warners End
    HP1 3PL Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    BritishSales & Marketing44712370001
    COHEN, Gary Michael
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    Administrateur
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    AustraliaAustralianCompany Director125992970001
    COWLES, Neil
    37 Oldborough Drive
    CV35 9HQ Loxley
    Warwickshire
    Administrateur
    37 Oldborough Drive
    CV35 9HQ Loxley
    Warwickshire
    BritishDirector79753520001
    CRABTREE, Nicholas Patrick
    Sherwood 11 Green Lane
    Chesham Bois
    HP6 5LN Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Sherwood 11 Green Lane
    Chesham Bois
    HP6 5LN Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director17678130002
    DAY, Robert William
    Weathertop
    Blackmires Lane, Silverstone
    NN12 8UZ Towcester
    Northamptonshire
    Administrateur
    Weathertop
    Blackmires Lane, Silverstone
    NN12 8UZ Towcester
    Northamptonshire
    BritishDirector66520250001
    EALES, Gillian Margaret
    20 Woodside Road
    Bickley
    BR1 2ES Bromley
    Kent
    Administrateur
    20 Woodside Road
    Bickley
    BR1 2ES Bromley
    Kent
    BritishBusiness Administrator16296060001
    FRANKS, Nigel
    8 Herston Close
    HP21 9UR Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    8 Herston Close
    HP21 9UR Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishOperations Director39004110002
    GARRINGTON, Stephen John
    15 Chesterton Close
    Hunt End
    B97 5XS Redditch
    Worcestershire
    Administrateur
    15 Chesterton Close
    Hunt End
    B97 5XS Redditch
    Worcestershire
    BritishDirector45513680001
    GRAHAM, Stephen Paul
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    Administrateur
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector97528710001
    HENRY, William Patrick
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandAmericanCompany Director119049370001
    JAMES, Gavin Keith, Mr.
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    Administrateur
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritishFinance Director44173560008
    KUMAR, Ravi
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    BritishCompany Director101025710001
    MACKAY, James Gordon
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director178097680001
    MACKAY, James Gordon
    Pogles Wood
    Widmoor
    HP10 0JG Wooburn Green
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Pogles Wood
    Widmoor
    HP10 0JG Wooburn Green
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Accountant178097680001
    MEIRE, Hylton Bruce
    30 Durham Avenue
    BR2 0QB Bromley
    Kent
    Administrateur
    30 Durham Avenue
    BR2 0QB Bromley
    Kent
    BritishDoctor5361780001
    MORRIS, Eamonn
    25 Coppinger Wood
    IRISH Blackrock
    Co Dublin
    Ireland
    Administrateur
    25 Coppinger Wood
    IRISH Blackrock
    Co Dublin
    Ireland
    IrelandIrishDirector65876940001
    PEARMAN, Mark Chalice
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector57516220003
    RAWCLIFFE, Richard William
    113 Towngate
    Eccleston
    PR7 5QS Chorley
    Lancashire
    England
    Administrateur
    113 Towngate
    Eccleston
    PR7 5QS Chorley
    Lancashire
    England
    BritishDirector86831530001
    RICHARDS, Paul
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    Administrateur
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    United KingdomBritishCompany Director126777780001
    RICHARDS, Paul
    The New Barn Grange Farm
    South Newington
    OX15 4JW Banbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    The New Barn Grange Farm
    South Newington
    OX15 4JW Banbury
    Oxfordshire
    BritishDirector82595090001
    STEVENS, Adrian Charles
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director76964750002
    THOMSON, Andrew James Edward
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant147270780001
    WATSON, Robert John
    Holly House Felden Lane
    Felden
    HP3 0BF Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Administrateur
    Holly House Felden Lane
    Felden
    HP3 0BF Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    EnglandBritishManaging Director16296070002
    WHELAN, John
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    Administrateur
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    UkBritishDirector105872500001
    WHISTON, Timothy Andrew
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    Administrateur
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    EnglandBritishDirector69575560002
    WOODBRIDGE, Mark Gavin
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    BritishFinance Director74738270002

    ISOFT RADIOLOGY SYSTEMS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security agreement
    Créé le 30 déc. 2009
    Livré le 13 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 13 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 01 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of accession
    Créé le 27 nov. 2007
    Livré le 13 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each borrower as a borrower and from each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch, as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Securityagent)
    Transactions
    • 13 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental guarantee and debenture
    Créé le 24 août 2006
    Livré le 31 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the principal borrower, each chargor and each other member of the group to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H suite 304 spirella building bridge road letchworth garden city herts. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Trustee and Agent for the Lenders as Defined in the Facility Agreement)(the Security Trustee)
    Transactions
    • 31 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 avr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 24 août 2006
    Livré le 31 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 31 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 30TH january 2003
    Créé le 13 avr. 2006
    Livré le 28 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 28 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 7TH april 1998
    Créé le 08 août 2002
    Livré le 16 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account to the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 16 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 avr. 2001
    Livré le 07 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 07 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0