GROSVENOR SPORTING CLUB LIMITED

GROSVENOR SPORTING CLUB LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGROSVENOR SPORTING CLUB LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01820848
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GROSVENOR SPORTING CLUB LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe GROSVENOR SPORTING CLUB LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de GROSVENOR SPORTING CLUB LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 sept. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour GROSVENOR SPORTING CLUB LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    10 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de New Castle House Castle Boulevard Nottingham Nottinghamshire NG7 1FT England le 01 juil. 2013

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolution d'insolvabilité

    Resolution INSOLVENCY:Extraordinary Resolution ;- "In Specie"
    1 pagesLIQ MISC RES

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 20 juin 2013

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Comptes pour une société dormante établis au 29 sept. 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    État du capital au 23 mai 2013

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Harry Willits le 19 févr. 2013

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de 71 Queensway London W2 4QH England le 15 févr. 2013

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 24 sept. 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 25 sept. 2010

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Diane Penfold en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Harry Willits en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 26 sept. 2009

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de GROSVENOR SPORTING CLUB LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GALA CORAL SECRETARIES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Secrétaire
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    69240850005
    WILLITS, Harry Andrew
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    Administrateur
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish175965490001
    GALA CORAL NOMINEES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Administrateur
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    76454320002
    CHEATLE, Martyn David
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    Secrétaire
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    British149874460001
    DIXON, Annie
    23 Mansfield Court
    NE36 0PL West Boldon
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    23 Mansfield Court
    NE36 0PL West Boldon
    Tyne & Wear
    British56380250001
    DIXON, Hedley Marsham
    Flat C 24 St Bedes Terrace
    Christchurch
    Sunderland
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    Flat C 24 St Bedes Terrace
    Christchurch
    Sunderland
    Tyne & Wear
    British22402950002
    FAGAN, Joyce Helen
    4 Falmouth Close
    SR7 8HE Seaham
    County Durham
    Secrétaire
    4 Falmouth Close
    SR7 8HE Seaham
    County Durham
    British22402970001
    NOBLE, Michael Jeremy
    Goathill Farm Well Hill Lane
    Well Hill
    BR6 7QJ Chelsfield
    Kent
    Secrétaire
    Goathill Farm Well Hill Lane
    Well Hill
    BR6 7QJ Chelsfield
    Kent
    British32786810004
    SINTON, Charles Blair Ritchie
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    Secrétaire
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    British52292450003
    SMERDON, Leigh
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Secrétaire
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Other89075910001
    CRONK, John Julian Tristam
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Administrateur
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    British6422100001
    DIXON, Hedley Marsham
    Flat C 24 St Bedes Terrace
    Christchurch
    Sunderland
    Tyne & Wear
    Administrateur
    Flat C 24 St Bedes Terrace
    Christchurch
    Sunderland
    Tyne & Wear
    British22402950002
    FAGAN, Joyce Helen
    4 Falmouth Close
    SR7 8HE Seaham
    County Durham
    Administrateur
    4 Falmouth Close
    SR7 8HE Seaham
    County Durham
    British22402970001
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish21686380006
    GRIFFITHS, Jonathan
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    Administrateur
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    British73691620003
    HARLEY, Susan Boyle
    Threeways Gills Hill Lane
    WD7 8DD Radlett
    Hertfordshire
    Administrateur
    Threeways Gills Hill Lane
    WD7 8DD Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish41384040001
    KELLY, John Michael
    Prospect House
    The Green Finchingfield
    CB7 4JZ Braintree
    Essex
    Administrateur
    Prospect House
    The Green Finchingfield
    CB7 4JZ Braintree
    Essex
    British56474600002
    MATTINGLEY, Brian Roger
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    British22417130001
    PAYNE, Ian Timothy
    The Elms 56 Avenue Road
    Dorridge
    B93 8JZ Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    The Elms 56 Avenue Road
    Dorridge
    B93 8JZ Solihull
    West Midlands
    British78974110002
    PENFOLD, Diane June
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Administrateur
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    United KingdomBritish59962430002
    SOWERBY, Richard Thomas Neville
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish47734920003
    STANLEY, Kate Emma
    5 The Barns
    West Leith
    HP23 6JJ Tring
    Hertfordshire
    Administrateur
    5 The Barns
    West Leith
    HP23 6JJ Tring
    Hertfordshire
    British66637240001
    WAGGETT, Colin
    41 Spring Grove
    W4 3NH London
    Administrateur
    41 Spring Grove
    W4 3NH London
    British62266600001

    GROSVENOR SPORTING CLUB LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed and floating security document
    Créé le 11 mai 2006
    Livré le 24 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transactions
    • 24 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating security document
    Créé le 27 oct. 2005
    Livré le 09 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    For details of properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transactions
    • 09 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating security document
    Créé le 01 sept. 2005
    Livré le 20 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H high street acton london t/no AGL114684, f/h high street aldershot hants t/no HP517737, f/h anchor road aldridge walsall t/no WM167521 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Transactions
    • 20 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating security document
    Créé le 11 févr. 2005
    Livré le 18 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Senior Financeparties and the Mezzanine Finance Parties
    Transactions
    • 18 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating security document
    Créé le 17 mars 2003
    Livré le 03 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party or any mezzanine finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Including 1-1A north bridge st,monkwearmouth,sunderland SR5 1AD; TY316249; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston,London Branch,as Security Trustee for the Finance Parties and Themezzanine Finance Parties
    Transactions
    • 03 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fifth supplemental and accession deed
    Créé le 21 déc. 2000
    Livré le 11 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys and liabilities (whether actual or contingent) which are at the date of the debenture or thereafter due owing or payable or expressed to be due owing or payable to any creditor (as defined) from or by any obligor (as defined) under or in connection with the facilities agreement,a hedging contract,the deposit agreement and charge on cash deposits or the debenture as such deeds and agreements may be amended or restated in the future
    Brèves mentions
    High street london W3 8BR,the ritz high street aldershot hants,essoldo milburn r oad nothumberland the real property (as defined) all plant machinery and equipment all right title and interest in the investments described in the continuation to form 395,goodwill,book debts.policies of insurance and by way of first floating charge all property and assets of the company for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guaranty Trust Company of New Yorkas Security Agent and Trustee
    Transactions
    • 11 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 sept. 1995
    Livré le 16 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fittings fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 sept. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 sept. 1995
    Livré le 13 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a 1/1A north bridge street monkwearmouth sunderland tyne & wear and A. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 sept. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 21 févr. 1986
    Livré le 27 févr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a 1 and 1A north bridge street monk wearmouth sunderland tyne and wear and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 27 févr. 1986Enregistrement d'une charge
    • 01 déc. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    GROSVENOR SPORTING CLUB LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    24 déc. 2013Dissolved on
    20 juin 2013Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Jill Sandford
    Rivermead Court 7 Lewis Court Grove Park
    Enderby
    LE19 1SD Leicester
    practitioner
    Rivermead Court 7 Lewis Court Grove Park
    Enderby
    LE19 1SD Leicester
    Patrick B Ellward
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    practitioner
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0