PARNELL FISHER CHILD & CO. LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | PARNELL FISHER CHILD & CO. LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01825105 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PARNELL FISHER CHILD & CO. LIMITED ?
Adresse du siège social | 280 Bishopsgate EC2M 4AG London United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PARNELL FISHER CHILD & CO. LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour PARNELL FISHER CHILD & CO. LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 juil. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des détails de Parnell Fisher Child Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 déc. 2022 | 2 pages | PSC05 | ||
Changement d'adresse du siège social de Bow Bells House 1 Bread Street London EC4M 9HH United Kingdom à 280 Bishopsgate London EC2M 4AG le 05 déc. 2022 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 7 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de Parnell Fisher Child Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 1 pages | PSC07 | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Sla Corporate Secretary Limited le 26 nov. 2021 | 1 pages | CH04 | ||
Cessation de la nomination de Neil James Messenger en tant que directeur le 30 sept. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mrs Karen Louise Clews en tant qu'administrateur le 14 sept. 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Julie Frances Scott en tant que directeur le 26 févr. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Neil James Messenger le 10 févr. 2021 | 2 pages | CH01 | ||
Nomination de Sla Corporate Secretary Limited en tant que secrétaire le 14 déc. 2020 | 2 pages | AP04 | ||
Cessation de la nomination de Paul Bernard Mckenna en tant que secrétaire le 14 déc. 2020 | 1 pages | TM02 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 6 pages | AA | ||
Nomination de Mr Neil James Messenger en tant qu'administrateur le 30 oct. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Colin Mccracken Dyer en tant qu'administrateur le 30 oct. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Julie Agnes Russell en tant que directeur le 30 oct. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 14th Floor 30 st Mary Axe London EC3A 8BF England à Bow Bells House 1 Bread Street London EC4M 9HH le 27 oct. 2020 | 1 pages | AD01 | ||
Modification des détails de Parnell Fisher Child Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 oct. 2020 | 2 pages | PSC05 | ||
Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Qui sont les dirigeants de PARNELL FISHER CHILD & CO. LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRDN CORPORATE SECRETARY LIMITED | Secrétaire | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 United Kingdom |
| 268172630002 | ||||||||||
CLEWS, Karen Louise | Administrateur | Bishopsgate EC2M 4AG London 280 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 248214210001 | ||||||||
DYER, Colin Mccracken | Administrateur | Bishopsgate EC2M 4AG London 280 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 135770980002 | ||||||||
CHILD, Joan Lesley | Secrétaire | Old Pond Cottage Kings Lane Cookham Dean SL6 9AY Maidenhead Berkshire | British | 31078770001 | ||||||||||
DAVIDSON, Gillian Mary | Secrétaire | The Bailey Skipton BD23 1DN North Yorkshire | British | 116222880001 | ||||||||||
GIBSON, John Joseph | Secrétaire | BD23 1DN Skipton The Bailey North Yorkshire | British | 158006670001 | ||||||||||
MCKENNA, Paul Bernard | Secrétaire | 1 Bread Street EC4M 9HH London Bow Bells House United Kingdom | 198151340001 | |||||||||||
RUTTER, John Arthur | Secrétaire | 17 Bredward Close SL1 7DL Slough Berkshire | British | Accountant | 103514100001 | |||||||||
WOOLVEN, Nigel David John | Secrétaire | Barnfield House Medmenham SL7 2ES Marlow Buckinghamshire | British | Company Director | 12607220001 | |||||||||
CHILD, Joan Lesley | Administrateur | Old Pond Cottage Kings Lane Cookham Dean SL6 9AY Maidenhead Berkshire | British | Indenpendent Financial Adviser | 31078770001 | |||||||||
CRADDOCK, Peter Martin | Administrateur | The Bailey Skipton BD23 1DN North Yorkshire | England | British | Group Commercial Director | 149361360001 | ||||||||
CUTTER, David John | Administrateur | The Bailey Skipton BD23 1DN North Yorkshire | England | British | Building Society Director | 70434220001 | ||||||||
DUNNE, Jeremy Robert | Administrateur | 30 St Mary Axe EC3A 8BF London 14th Floor England | United Kingdom | British | Director | 84111110001 | ||||||||
FISHER, Grahame Robert | Administrateur | Bramleigh Shoppenhangers Road SL6 2PZ Maidenhead Berkshire | Uk | British | Financial Advisor | 1934200002 | ||||||||
FISHER, Grahame Robert | Administrateur | Bramleigh Shoppenhangers Road SL6 2PZ Maidenhead Berkshire | Uk | British | Independent Financial Adviser | 1934200002 | ||||||||
FLEET, Mark Russell | Administrateur | Skipton BD23 1DN North Yorkshire The Bailey United Kingdom | England | British | Director | 273343060001 | ||||||||
GOODFELLOW, John Graham | Administrateur | 3 White Hills Croft BD23 1LW Skipton North Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 9666980007 | ||||||||
JONES, Duncan Ainsley | Administrateur | 30 St Mary Axe EC3A 8BF London 14th Floor England | England | British | Financial Advisor | 43536770002 | ||||||||
LAW, Elizabeth Norrie | Administrateur | The Bailey Skipton BD23 1DN North Yorkshire | England | British | Director | 135673600001 | ||||||||
MESSENGER, Neil James | Administrateur | 1 Bread Street EC4M 9HH London Bow Bells House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 276111950001 | ||||||||
PARNELL, John David | Administrateur | Willingdon Worster Road SL6 9JG Cookham Berkshire | British | Indenpendent Financial Adviser | 1934190002 | |||||||||
PREECE, Ian James | Administrateur | 31 Mandeville Close Tilehurst RG30 4JT Reading Berkshire | British | Financial Adviser | 74038330001 | |||||||||
PURCHASE, Diane Carol | Administrateur | The Anchorage Riverside TW18 3NJ Staines Middlesex | British | Financial Adviser | 43536830002 | |||||||||
RAPLEY, Perry | Administrateur | 30 St Mary Axe EC3A 8BF London 14th Floor England | United Kingdom | British | Financial Planning | 77057750001 | ||||||||
ROBINSON, Alexander Charles | Administrateur | Skipton BD23 1DN North Yorkshire The Bailey United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 75636850004 | ||||||||
RUSSELL, Julie Agnes | Administrateur | 1 Bread Street EC4M 9HH London Bow Bells House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 198455230001 | ||||||||
SAUNDERS, Judith Ann | Administrateur | 58 Cadwell Drive SL6 3YR Maidenhead Berkshire | British | Office Services Director | 48943380001 | |||||||||
SCOTT, Julie Frances | Administrateur | 1 Bread Street EC4M 9HH London Bow Bells House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 204533660001 | ||||||||
STROOMER, David Jeremy | Administrateur | 16 The Brow HP8 4JD Chalfont St. Giles Buckinghamshire | British | Independent Financial Advisor | 43536670002 | |||||||||
TWIGG, Richard John | Administrateur | BD23 1DN Skipton The Bailey North Yorkshire | England | British | Director | 47283360005 | ||||||||
WOOLVEN, Nigel David John | Administrateur | Barnfield House Medmenham SL7 2ES Marlow Buckinghamshire | England | British | Independent Financial Adviser | 12607220001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PARNELL FISHER CHILD & CO. LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parnell Fisher Child Holdings Limited | 06 avr. 2016 | 30 St. Mary Axe EC3A 8BF London 14th Floor England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Parnell Fisher Child Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Bishopsgate EC2M 4AG London 280 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
PARNELL FISHER CHILD & CO. LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 28 nov. 2005 Livré le 03 déc. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 23 mars 2001 Livré le 10 avr. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 13 juil. 1995 Livré le 02 août 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignment | Créé le 05 août 1993 Livré le 23 août 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date | |
Brèves mentions All sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0