HBV ENTERPRISE

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHBV ENTERPRISE
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited'
    Numéro de société 01825391
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HBV ENTERPRISE ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe HBV ENTERPRISE ?

    Adresse du siège social
    Moore (South) R&I Llp The Quay 30 Channel Way
    Ocean Village
    SO14 3TG Southampton
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HBV ENTERPRISE ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HACKNEY BUSINESS VENTURE18 avr. 198518 avr. 1985
    BONDSPELL LIMITED18 juin 198418 juin 1984

    Quels sont les derniers comptes de HBV ENTERPRISE ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour HBV ENTERPRISE ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de Enfield Business Centre Enfield Hub 201 Hertford Road Enfield EN3 5JH England à Moore (South) R&I Llp the Quay 30 Channel Way Ocean Village Southampton Hampshire SO14 3TG le 02 juin 2020

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 11 mai 2020

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    7 pagesLIQ01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Dipesh Santilale le 23 mars 2020

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 18 mars 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Vivian Abbott le 28 févr. 2018

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2019

    15 pagesAA

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de The London Small Business Centre 206 Whitechapel Road London E1 1AA England à Enfield Enterprise Centre 201 Hertford Road Enfield EN3 5JH

    1 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de The London Small Business Centre 206 Whitechapel Road London E1 1AA England à Enfield Business Centre Enfield Hub 201 Hertford Road Enfield EN3 5JH le 27 juin 2019

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 18 mars 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2018

    15 pagesAA

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2017

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    17 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Co business 28/02/2018
    RES13
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Changement d'adresse du siège social de Universal House London Small Business Centre Universal House, 88-94 Wentworth Street London E1 7SA à The London Small Business Centre 206 Whitechapel Road London E1 1AA le 24 nov. 2017

    1 pagesAD01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à The London Small Business Centre 206 Whitechapel Road London E1 1AA

    1 pagesAD02

    Déclaration de confirmation établie le 18 mars 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2016

    18 pagesAA

    Cessation de la nomination de Brian Neville Marsh en tant que directeur le 01 juil. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Charmaine Pollard en tant que directeur le 24 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Hbv Enterprise Centre 34-38 Dalston Lane London E8 3AZ à Universal House London Small Business Centre Universal House, 88-94 Wentworth Street London E1 7SA E1 7SA le 23 mars 2016

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 mars 2016 sans liste des membres

    4 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de HBV ENTERPRISE ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ABBOTT, Viv
    The Quay 30 Channel Way
    Ocean Village
    SO14 3TG Southampton
    Moore (South) R&I Llp
    Hampshire
    Secrétaire
    The Quay 30 Channel Way
    Ocean Village
    SO14 3TG Southampton
    Moore (South) R&I Llp
    Hampshire
    166069490001
    ABBOTT, Vivian
    Enfield Hub
    201 Hertford Road
    EN3 5JH Enfield
    Enfield Business Centre
    England
    Administrateur
    Enfield Hub
    201 Hertford Road
    EN3 5JH Enfield
    Enfield Business Centre
    England
    EnglandBritishVolunteer202289940001
    HAXBY, Adrian John
    The Quay 30 Channel Way
    Ocean Village
    SO14 3TG Southampton
    Moore (South) R&I Llp
    Hampshire
    Administrateur
    The Quay 30 Channel Way
    Ocean Village
    SO14 3TG Southampton
    Moore (South) R&I Llp
    Hampshire
    EnglandBritishInvestment Banker109623620001
    SANTILALE, Dipesh
    The Quay 30 Channel Way
    Ocean Village
    SO14 3TG Southampton
    Moore (South) R&I Llp
    Hampshire
    Administrateur
    The Quay 30 Channel Way
    Ocean Village
    SO14 3TG Southampton
    Moore (South) R&I Llp
    Hampshire
    EnglandBritishSolicitor129946240002
    FISHER, Ayesha
    Hbv Enterprise Centre
    34-38 Dalston Lane
    E8 3AZ London
    Secrétaire
    Hbv Enterprise Centre
    34-38 Dalston Lane
    E8 3AZ London
    153487970002
    KELLY, Michael Samuel
    59 Northchurch Road
    N1 4EE London
    Secrétaire
    59 Northchurch Road
    N1 4EE London
    British12409900001
    PILLING, Stephen Marsden
    41 College Gardens
    Chingford
    E4 7LN London
    Secrétaire
    41 College Gardens
    Chingford
    E4 7LN London
    BritishLocal Fund Manager14955510001
    PYATT, David
    28 Moss Bank
    Meesons Lane
    RM17 5EF Grays
    Essex
    Secrétaire
    28 Moss Bank
    Meesons Lane
    RM17 5EF Grays
    Essex
    BritishRetired District Operations Ma49627110001
    ABBOTT, Richard
    Hbv Enterprise Centre
    34-38 Dalston Lane
    E8 3AZ London
    Administrateur
    Hbv Enterprise Centre
    34-38 Dalston Lane
    E8 3AZ London
    EnglandBritishChief Executive119893530001
    AGASS, Sally Margaret
    163 The Circle
    Queen Elizabeth Street
    SE1 2JL London
    Administrateur
    163 The Circle
    Queen Elizabeth Street
    SE1 2JL London
    EnglandBritishChief Executive38645560003
    ANDERSON, Ian Scott
    The Firs
    11 Grassy Lane
    TN13 1PN Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    The Firs
    11 Grassy Lane
    TN13 1PN Sevenoaks
    Kent
    BritishManager37544830001
    BALGARNIE, Andrew James
    Hbv Enterprise Centre
    34-38 Dalston Lane
    E8 3AZ London
    Administrateur
    Hbv Enterprise Centre
    34-38 Dalston Lane
    E8 3AZ London
    EnglandUnited KingdomFinance142317610001
    BEDFORD, Peter Wyatt
    Elderfield House
    Herriard
    RG25 2PY Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Elderfield House
    Herriard
    RG25 2PY Basingstoke
    Hampshire
    BritishLloyds Insurance Broker1771230001
    CHADWICK, Mary Elizabeth Jane, Dr
    5 De Beauvoir Square
    N1 4LG London
    Administrateur
    5 De Beauvoir Square
    N1 4LG London
    United KingdomBritishNone31762300001
    CHAPLIN, Paul Robert Golding
    4 & 5 Manor Cottages
    Old Wolverton Road
    MK12 5NN Old Wolverton
    Milton Keynes
    Administrateur
    4 & 5 Manor Cottages
    Old Wolverton Road
    MK12 5NN Old Wolverton
    Milton Keynes
    BritishExecutive Director75612360001
    COLE, Ernest Francis
    Bitwood Farm
    Charlton Musgrove
    BA9 8EZ Wincanton
    Somerset
    Administrateur
    Bitwood Farm
    Charlton Musgrove
    BA9 8EZ Wincanton
    Somerset
    BritishBanker17799560002
    COX, Charles
    41 Wingletye Lane
    RM11 3SU Hornchurch
    Essex
    Administrateur
    41 Wingletye Lane
    RM11 3SU Hornchurch
    Essex
    EnglandBritishChartered Accountant141692810001
    DEUTZ, Martin Peter
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Administrateur
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    BritishFinancial Adviser63074080004
    EVANS, Stuart John
    Old House
    5 Canonbury Place
    N1 2NQ London
    Administrateur
    Old House
    5 Canonbury Place
    N1 2NQ London
    United KingdomBritishSolicitor42622730001
    GRIFFITH-JONES, John Guthrie
    17 Fitzwilliam Road
    SW4 0BN London
    Administrateur
    17 Fitzwilliam Road
    SW4 0BN London
    BritishCorporate Financier50304000001
    HAINES, Michael Geoffrey Minton
    82a Mortimer Road
    N1 4LH London
    Administrateur
    82a Mortimer Road
    N1 4LH London
    BritishChartered Accountant3266390001
    HARWOOD, Margaret Gillian
    41 Old Town
    Clapham
    SW4 0JL London
    Administrateur
    41 Old Town
    Clapham
    SW4 0JL London
    United KingdomBritishManaged Workspace & Catering6164980002
    KAMAIE, Hannah
    15 Swinburne Road
    Putney
    SW15 5ED London
    Administrateur
    15 Swinburne Road
    Putney
    SW15 5ED London
    BritishSolicitor109446500001
    KAZEMPOUR, Tayebeth
    St Stephens Court
    10 Mayfield Road
    N8 9NQ London
    13
    United Kingdom
    Administrateur
    St Stephens Court
    10 Mayfield Road
    N8 9NQ London
    13
    United Kingdom
    United KingdomBritishManager- Education135412770001
    KAZEMPOUR, Tayebeth
    St Stephens Court
    10 Mailfield Road
    N8 9NG London
    Flat 13
    Administrateur
    St Stephens Court
    10 Mailfield Road
    N8 9NG London
    Flat 13
    United KingdomBritishManager-Education135412770001
    LUTHRA, Rahul
    Hbv Enterprise Centre
    34-38 Dalston Lane
    E8 3AZ London
    Administrateur
    Hbv Enterprise Centre
    34-38 Dalston Lane
    E8 3AZ London
    EnglandBritishInvestment Banker168649560002
    MARSH, Brian Neville
    London Small Business Centre
    Universal House, 88-94 Wentworth Street
    E1 7SA London
    Universal House
    Administrateur
    London Small Business Centre
    Universal House, 88-94 Wentworth Street
    E1 7SA London
    Universal House
    Great BritainBritishTechnical Officer15930200001
    MISTLIN, Gail
    4 Bostonthorpe Road
    W7 2HA Hanwell
    Ealing
    Administrateur
    4 Bostonthorpe Road
    W7 2HA Hanwell
    Ealing
    United KingdomBritishDirector124230510001
    PARMAR, Grishma
    Hbv Enterprise Centre
    34-38 Dalston Lane
    E8 3AZ London
    Administrateur
    Hbv Enterprise Centre
    34-38 Dalston Lane
    E8 3AZ London
    EnglandBritishRisk Change Management129946200001
    POLLARD, Charmaine
    London Small Business Centre
    Universal House, 88-94 Wentworth Street
    E1 7SA London
    Universal House
    Administrateur
    London Small Business Centre
    Universal House, 88-94 Wentworth Street
    E1 7SA London
    Universal House
    EnglandBritishCounsellor149553620001
    PYATT, David
    28 Moss Bank
    Meesons Lane
    RM17 5EF Grays
    Essex
    Administrateur
    28 Moss Bank
    Meesons Lane
    RM17 5EF Grays
    Essex
    BritishNone49627110001
    RICHARDSON, Hugh
    Flat 56
    30 Vincent Square
    SW1P 2NW London
    Administrateur
    Flat 56
    30 Vincent Square
    SW1P 2NW London
    EnglandBritishBanker118658380001
    SASSOON, James Meyer, Sir
    Chelsea Park Gardens
    SW3 6AA London
    4
    Administrateur
    Chelsea Park Gardens
    SW3 6AA London
    4
    BritishBanker30112680002
    SIDDIQUI, Mohammad Saleem
    3 Overbury Street
    E5 0AN London
    Administrateur
    3 Overbury Street
    E5 0AN London
    England UkBritishBusiness Executive61445440001
    SMITH, Noel Bryn
    4 Lambert Jones Mews
    Barbican
    EC2Y 8DP London
    Administrateur
    4 Lambert Jones Mews
    Barbican
    EC2Y 8DP London
    BritishPersonnel Director4613650001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour HBV ENTERPRISE ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    18 mars 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    HBV ENTERPRISE a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    11 mai 2020Commencement of winding up
    19 avr. 2021Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Christopher Tate
    The Quay 30 Channel Way
    Ocean Village
    SO14 3TG Southampton
    Hampshire
    practitioner
    The Quay 30 Channel Way
    Ocean Village
    SO14 3TG Southampton
    Hampshire
    Duncan Kenric Swift
    The Quay 30 Channel Way
    Ocean Village
    SO14 3TG Southampton
    Hampshire
    practitioner
    The Quay 30 Channel Way
    Ocean Village
    SO14 3TG Southampton
    Hampshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0