CONTRACTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCONTRACTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01825819
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CONTRACTS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CONTRACTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    First Floor Centro One
    39 Plender Street
    NW1 0DT London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CONTRACTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DOMEGROOM LIMITED19 juin 198419 juin 1984

    Quels sont les derniers comptes de CONTRACTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour CONTRACTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2022 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Amarjit Singh Grewal le 25 avr. 2022

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Apinder Singh Ghura le 25 avr. 2022

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Lee James Williams en tant que directeur le 28 févr. 2022

    1 pagesTM01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 janv. 2022 au 30 juin 2022

    1 pagesAA01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Inscription de la charge 018258190005, créée le 17 nov. 2021

    80 pagesMR01

    Modification des détails de French Connection Group Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 nov. 2021

    2 pagesPSC05

    Cessation de la nomination de Stephen Anthony Solomon Marks en tant que directeur le 08 nov. 2021

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Apinder Singh Ghura en tant qu'administrateur le 08 nov. 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Amarjit Singh Grewal en tant qu'administrateur le 08 nov. 2021

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2021

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2020

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2020 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Lee James Williams le 15 août 2019

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2019

    13 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2018

    13 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de French Connection Group Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 août 2017

    2 pagesPSC05

    Cessation de la nomination de Dinesh Raichand Shah en tant que secrétaire le 26 janv. 2018

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de CONTRACTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GHURA, Apinder Singh
    Centro One
    39 Plender Street
    NW1 0DT London
    First Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Centro One
    39 Plender Street
    NW1 0DT London
    First Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector25051130007
    GREWAL, Amarjit Singh
    Centro One
    39 Plender Street
    NW1 0DT London
    First Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Centro One
    39 Plender Street
    NW1 0DT London
    First Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector289215270001
    WILLIAMS, Neil Pryce
    Tyrrells Wood
    KT22 8QJ Leatherhead
    Beech Hurst
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Tyrrells Wood
    KT22 8QJ Leatherhead
    Beech Hurst
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Operations Director38954490003
    MALME, Stephen Edward Charles
    51 Mornington Road
    Chingford
    E4 7DT London
    Secrétaire
    51 Mornington Road
    Chingford
    E4 7DT London
    British35508390001
    SHAH, Dinesh Raichand
    4 Chantry Close
    HA3 9QZ Harrow
    Middlesex
    Secrétaire
    4 Chantry Close
    HA3 9QZ Harrow
    Middlesex
    British30148750001
    CASTLETON, Adam
    Bedford Row
    WC1R 4JS London
    20-22
    United Kingdom
    Administrateur
    Bedford Row
    WC1R 4JS London
    20-22
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Finance Director181962100001
    MARKS, Stephen Anthony Solomon
    Egerton Terrace
    SW3 2BU London
    39-41
    Administrateur
    Egerton Terrace
    SW3 2BU London
    39-41
    United KingdomBritishChairman And Managing Director27361560005
    MATHER, Nicholas Charles Holt
    Woodmancote House
    Woodmancote
    PO10 8QD Emsworth
    Hampshire
    Administrateur
    Woodmancote House
    Woodmancote
    PO10 8QD Emsworth
    Hampshire
    BritishFinance Director40266770002
    NAISMITH, Roy Cameron
    The Corn Store
    Manor Farm Barns
    SO24 9DH Old Alresford
    Hampshire
    Administrateur
    The Corn Store
    Manor Farm Barns
    SO24 9DH Old Alresford
    Hampshire
    EnglandBritishFinance Director50349450001
    WILLIAMS, Lee James
    Unit B, Dolphin Way
    RM19 1NZ Purfleet
    French Connection
    Essex
    England
    Administrateur
    Unit B, Dolphin Way
    RM19 1NZ Purfleet
    French Connection
    Essex
    England
    EnglandBritishGroup Finance Director153658880004

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CONTRACTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Centro One
    39 Plender Street
    NW1 0DT London
    First Floor
    06 avr. 2016
    Centro One
    39 Plender Street
    NW1 0DT London
    First Floor
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement01410568
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CONTRACTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 17 nov. 2021
    Livré le 19 nov. 2021
    En cours
    Brève description
    Trade marks of fcuk, french connection, ymc, fc by french connection, fc:baby&device, great plains, UK style by french connection, nicole farhi initial, youtique in various countries. For further details, please refer to the charge document.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • GB Europe Management Services Limited (As Security Agent)
    Transactions
    • 19 nov. 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    Deed of accession and supplemental charge
    Créé le 01 mai 1996
    Livré le 16 mai 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from french connection (hong kong) limited to the chargee and to the lenders and each of them on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 mai 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 01 déc. 1989
    Livré le 11 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Trade marks (see form 395 - ref M170 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC.(As Agent and Trustee for the Banks)
    Transactions
    • 11 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    • 30 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 01 déc. 1989
    Livré le 11 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (See form 395-ref M150 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    • 30 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    General letter of pledge & hypothecation
    Créé le 30 juin 1987
    Livré le 20 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All goods bills of lading warrants, delivery orders documents of title to goods and all property and other rights, all proceeds of sale or other disposition of the goods.
    Personnes ayant droit
    • Banque Internaionale a Luxemburg.
    Transactions
    • 20 juil. 1987Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0