ARLE CENTRE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ARLE CENTRE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01833700 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ARLE CENTRE LIMITED ?
| Adresse du siège social | c/o BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL) LLP 41 Castle Way SO14 2BW Southampton Hampshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ARLE CENTRE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2009 |
Quels sont les derniers dépôts pour ARLE CENTRE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 3 pages | 4.71 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de The Zurich Centre 3000 Parkway Whiteley Fareham Hampshire PO15 7JZ le 06 oct. 2010 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes modifiés pour une société dormante jusqu'au 31 déc. 2009 | 7 pages | AAMD | ||||||||||
Cessation de la nomination de Philip Lampshire en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Roman Stein en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Stuart Diffey en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Patrick Colm Peter Tiernan en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2009 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires | 14 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Roman Stein en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Philip John Lampshire en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Philip John Lampshire en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lindsey Stevens en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lindsey Stevens en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy Grant en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2008 | 7 pages | AA | ||||||||||
legacy | 5 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2007 | 7 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ARLE CENTRE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMPSHIRE, Philip John | Secrétaire | 3000 Parkway Whiteley PO15 7JZ Fareham The Zurich Centre Hampshire | British | 145998830001 | ||||||
| DIFFEY, Stuart, Mr. | Administrateur | 3000 Parkway Whiteley PO15 7JZ Fareham The Zurich Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 145998150001 | |||||
| TIERNAN, Patrick Colm Peter | Administrateur | 3000 Parkway Whiteley PO15 7JZ Fareham The Zurich Centre United Kingdom | United Kingdom | Irish | 152392550001 | |||||
| ATKINSON, Joanne Claire | Secrétaire | 23 Eastways Bishops Waltham SO32 1EX Southampton Hampshire | British | 88944200003 | ||||||
| CHANDLER, Michael John | Secrétaire | 9 Chestnut Rise Droxford SO32 3NY Southampton Hampshire | British | 12203710001 | ||||||
| HALLGATE-HILLS, Claire Rosamund | Secrétaire | Flat 1 Cranley Wellington Square GL50 4JX Cheltenham Gloucestershire | British | 19215530003 | ||||||
| HALLING, Teresa Kathleen | Secrétaire | 68 Primrose Way GL15 5SQ Lydney Gloucestershire | British | 19387880001 | ||||||
| PORTER, Margaret Ann | Secrétaire | The Zurich Centre 3000 Parkway, Whiteley PO15 7JZ Fareham Hampshire | British | 63664390003 | ||||||
| STEVENS, Lindsey Anne | Secrétaire | 3000 Parkway Whiteley PO15 7JZ Fareham The Zurich Centre Hampshire | British | 138509020001 | ||||||
| WILTSHIRE, James Anthony | Secrétaire | Wellington House Stroud Road GL6 6UT Painswick Gloucestershire | British | 461140002 | ||||||
| WORTHINGTON, Paul Frank | Secrétaire | 7 Victoria Close SO31 9NT Locks Heath Hampshire | British | 99470290001 | ||||||
| AMES, Norman Joseph Deryck | Administrateur | Ashton House Ashton Keynes SN6 6NX Swindon | British | 72952560001 | ||||||
| ATKINSON, Joanne Claire | Administrateur | 23 Eastways Bishops Waltham SO32 1EX Southampton Hampshire | British | 88944200003 | ||||||
| CHANDLER, Michael John | Administrateur | 9 Chestnut Rise Droxford SO32 3NY Southampton Hampshire | British | 12203710001 | ||||||
| CHESSHER, Mark Christopher | Administrateur | 16 Denmark Villas BN3 3TE Hove East Sussex | British | 81345500002 | ||||||
| CULMER, Mark George | Administrateur | SO21 | England | British | 98008120001 | |||||
| EVANS, Michael Robert | Administrateur | 8 Little Lancarridge GL2 8EN Highnham Gloucestershire | British | 72798390001 | ||||||
| GRANT, Timothy James | Administrateur | The Zurich Centre 3000 Parkway, Whiteley PO15 7JZ Fareham Hampshire | United Kingdom | British | 106395820002 | |||||
| HANKS, Brian Paul | Administrateur | 1 Lancaster Drive Little Rissington GL54 2QZ Cheltenham Gloucestershire | British | 60770390002 | ||||||
| HAYES, Christopher | Administrateur | The Green Guiting Power GL54 5UR Cheltenham Gloucestershire | England | British | 95945270001 | |||||
| JAMES, Ian Humphries | Administrateur | 55 The Willows Highworth SN6 7PH Swindon | British | 27415830001 | ||||||
| JAMES, Ian Humphries | Administrateur | 55 The Willows Highworth SN6 7PH Swindon | British | 27415830001 | ||||||
| JAMES, Penelope Jane | Administrateur | The Zurich Centre 3000 Parkway, Whiteley PO15 7JZ Fareham Hampshire | British | 96276790005 | ||||||
| LAMPSHIRE, Philip John | Administrateur | 3000 Parkway Whiteley PO15 7JZ Fareham The Zurich Centre Hampshire | British | 145998830001 | ||||||
| NICHOLAS, John Stuart | Administrateur | Twistells Wood Road GU26 6PX Hindhead Surrey | British | 62665770001 | ||||||
| PORTER, Margaret Ann | Administrateur | The Zurich Centre 3000 Parkway, Whiteley PO15 7JZ Fareham Hampshire | British | 63664390003 | ||||||
| SEWARD, Ian Graham | Administrateur | The Limes Town Pond Lane Southmoor OX13 5HS Abingdon Oxfordshire | British | 21934200001 | ||||||
| SMITH, Andrew Mark | Administrateur | Grove Cottage 15 The Strand Attenborough NG9 6AU Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | 26977900001 | |||||
| STEIN, Roman | Administrateur | 3000 Parkway Whiteley PO15 7JZ Fareham The Zurich Centre Hampshire | British | 146178090001 | ||||||
| STEVENS, Lindsey Anne | Administrateur | 3000 Parkway Whiteley PO15 7JZ Fareham The Zurich Centre Hampshire | British | 138509020001 | ||||||
| WILLIAMS, Brian | Administrateur | 14 Shirley Avenue Cheam SM2 7QR Sutton Surrey | British | 9303850001 | ||||||
| WORTHINGTON, Paul Frank | Administrateur | 7 Victoria Close SO31 9NT Locks Heath Hampshire | British | 99470290001 |
ARLE CENTRE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Créé le 31 déc. 1993 Livré le 20 janv. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of an agreement dated 31ST december 1991 and the security documents (as defined therein) | |
Brèves mentions F/H land on the south side of hayden lane cheltenham gloucestershire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 31 déc. 1991 Livré le 20 janv. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti £100,000,000 and all other monies due or to become due from eagle star holdings PLC to eagle star loans limited under the loan agreement dated 31ST december 1991 and/or under this legal mortgage | |
Brèves mentions Freehold land on the south side of hayden lane,cheltenham,gloucestershire together with all buildings and other erections fixed plant machinery and fixtures (other than tenants' or trade fixtures) thereon.benefit of all agreements,leases,tenancies,rights,licences,covenants and conditions. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
ARLE CENTRE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0