ARLE CENTRE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéARLE CENTRE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01833700
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ARLE CENTRE LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe ARLE CENTRE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL) LLP
    41 Castle Way
    SO14 2BW Southampton
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ARLE CENTRE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ARLE FARM LIMITED16 août 198516 août 1985
    FLEETLANCE LIMITED18 juil. 198418 juil. 1984

    Quels sont les derniers comptes de ARLE CENTRE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour ARLE CENTRE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 28 sept. 2010

    LRESSP

    Changement d'adresse du siège social de The Zurich Centre 3000 Parkway Whiteley Fareham Hampshire PO15 7JZ le 06 oct. 2010

    2 pagesAD01

    Comptes modifiés pour une société dormante jusqu'au 31 déc. 2009

    7 pagesAAMD

    Cessation de la nomination de Philip Lampshire en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Roman Stein en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Stuart Diffey en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Patrick Colm Peter Tiernan en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2009

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 mai 2010

    État du capital au 05 mai 2010

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nomination de Roman Stein en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Philip John Lampshire en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Nomination de Philip John Lampshire en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Lindsey Stevens en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Lindsey Stevens en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Timothy Grant en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    7 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    7 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ARLE CENTRE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LAMPSHIRE, Philip John
    3000 Parkway
    Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    The Zurich Centre
    Hampshire
    Secrétaire
    3000 Parkway
    Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    The Zurich Centre
    Hampshire
    British145998830001
    DIFFEY, Stuart, Mr.
    3000 Parkway
    Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    The Zurich Centre
    United Kingdom
    Administrateur
    3000 Parkway
    Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    The Zurich Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish145998150001
    TIERNAN, Patrick Colm Peter
    3000 Parkway
    Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    The Zurich Centre
    United Kingdom
    Administrateur
    3000 Parkway
    Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    The Zurich Centre
    United Kingdom
    United KingdomIrish152392550001
    ATKINSON, Joanne Claire
    23 Eastways
    Bishops Waltham
    SO32 1EX Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    23 Eastways
    Bishops Waltham
    SO32 1EX Southampton
    Hampshire
    British88944200003
    CHANDLER, Michael John
    9 Chestnut Rise
    Droxford
    SO32 3NY Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    9 Chestnut Rise
    Droxford
    SO32 3NY Southampton
    Hampshire
    British12203710001
    HALLGATE-HILLS, Claire Rosamund
    Flat 1 Cranley
    Wellington Square
    GL50 4JX Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Flat 1 Cranley
    Wellington Square
    GL50 4JX Cheltenham
    Gloucestershire
    British19215530003
    HALLING, Teresa Kathleen
    68 Primrose Way
    GL15 5SQ Lydney
    Gloucestershire
    Secrétaire
    68 Primrose Way
    GL15 5SQ Lydney
    Gloucestershire
    British19387880001
    PORTER, Margaret Ann
    The Zurich Centre
    3000 Parkway, Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    Hampshire
    Secrétaire
    The Zurich Centre
    3000 Parkway, Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    Hampshire
    British63664390003
    STEVENS, Lindsey Anne
    3000 Parkway
    Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    The Zurich Centre
    Hampshire
    Secrétaire
    3000 Parkway
    Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    The Zurich Centre
    Hampshire
    British138509020001
    WILTSHIRE, James Anthony
    Wellington House
    Stroud Road
    GL6 6UT Painswick
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Wellington House
    Stroud Road
    GL6 6UT Painswick
    Gloucestershire
    British461140002
    WORTHINGTON, Paul Frank
    7 Victoria Close
    SO31 9NT Locks Heath
    Hampshire
    Secrétaire
    7 Victoria Close
    SO31 9NT Locks Heath
    Hampshire
    British99470290001
    AMES, Norman Joseph Deryck
    Ashton House
    Ashton Keynes
    SN6 6NX Swindon
    Administrateur
    Ashton House
    Ashton Keynes
    SN6 6NX Swindon
    British72952560001
    ATKINSON, Joanne Claire
    23 Eastways
    Bishops Waltham
    SO32 1EX Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    23 Eastways
    Bishops Waltham
    SO32 1EX Southampton
    Hampshire
    British88944200003
    CHANDLER, Michael John
    9 Chestnut Rise
    Droxford
    SO32 3NY Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    9 Chestnut Rise
    Droxford
    SO32 3NY Southampton
    Hampshire
    British12203710001
    CHESSHER, Mark Christopher
    16 Denmark Villas
    BN3 3TE Hove
    East Sussex
    Administrateur
    16 Denmark Villas
    BN3 3TE Hove
    East Sussex
    British81345500002
    CULMER, Mark George
    SO21
    Administrateur
    SO21
    EnglandBritish98008120001
    EVANS, Michael Robert
    8 Little Lancarridge
    GL2 8EN Highnham
    Gloucestershire
    Administrateur
    8 Little Lancarridge
    GL2 8EN Highnham
    Gloucestershire
    British72798390001
    GRANT, Timothy James
    The Zurich Centre
    3000 Parkway, Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    Hampshire
    Administrateur
    The Zurich Centre
    3000 Parkway, Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    Hampshire
    United KingdomBritish106395820002
    HANKS, Brian Paul
    1 Lancaster Drive
    Little Rissington
    GL54 2QZ Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    1 Lancaster Drive
    Little Rissington
    GL54 2QZ Cheltenham
    Gloucestershire
    British60770390002
    HAYES, Christopher
    The Green
    Guiting Power
    GL54 5UR Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    The Green
    Guiting Power
    GL54 5UR Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish95945270001
    JAMES, Ian Humphries
    55 The Willows
    Highworth
    SN6 7PH Swindon
    Administrateur
    55 The Willows
    Highworth
    SN6 7PH Swindon
    British27415830001
    JAMES, Ian Humphries
    55 The Willows
    Highworth
    SN6 7PH Swindon
    Administrateur
    55 The Willows
    Highworth
    SN6 7PH Swindon
    British27415830001
    JAMES, Penelope Jane
    The Zurich Centre
    3000 Parkway, Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    Hampshire
    Administrateur
    The Zurich Centre
    3000 Parkway, Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    Hampshire
    British96276790005
    LAMPSHIRE, Philip John
    3000 Parkway
    Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    The Zurich Centre
    Hampshire
    Administrateur
    3000 Parkway
    Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    The Zurich Centre
    Hampshire
    British145998830001
    NICHOLAS, John Stuart
    Twistells Wood Road
    GU26 6PX Hindhead
    Surrey
    Administrateur
    Twistells Wood Road
    GU26 6PX Hindhead
    Surrey
    British62665770001
    PORTER, Margaret Ann
    The Zurich Centre
    3000 Parkway, Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    Hampshire
    Administrateur
    The Zurich Centre
    3000 Parkway, Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    Hampshire
    British63664390003
    SEWARD, Ian Graham
    The Limes Town Pond Lane
    Southmoor
    OX13 5HS Abingdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Limes Town Pond Lane
    Southmoor
    OX13 5HS Abingdon
    Oxfordshire
    British21934200001
    SMITH, Andrew Mark
    Grove Cottage 15 The Strand
    Attenborough
    NG9 6AU Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Grove Cottage 15 The Strand
    Attenborough
    NG9 6AU Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish26977900001
    STEIN, Roman
    3000 Parkway
    Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    The Zurich Centre
    Hampshire
    Administrateur
    3000 Parkway
    Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    The Zurich Centre
    Hampshire
    British146178090001
    STEVENS, Lindsey Anne
    3000 Parkway
    Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    The Zurich Centre
    Hampshire
    Administrateur
    3000 Parkway
    Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    The Zurich Centre
    Hampshire
    British138509020001
    WILLIAMS, Brian
    14 Shirley Avenue
    Cheam
    SM2 7QR Sutton
    Surrey
    Administrateur
    14 Shirley Avenue
    Cheam
    SM2 7QR Sutton
    Surrey
    British9303850001
    WORTHINGTON, Paul Frank
    7 Victoria Close
    SO31 9NT Locks Heath
    Hampshire
    Administrateur
    7 Victoria Close
    SO31 9NT Locks Heath
    Hampshire
    British99470290001

    ARLE CENTRE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage
    Créé le 31 déc. 1993
    Livré le 20 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of an agreement dated 31ST december 1991 and the security documents (as defined therein)
    Brèves mentions
    F/H land on the south side of hayden lane cheltenham gloucestershire.
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Loans Limited
    Transactions
    • 20 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 31 déc. 1991
    Livré le 20 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £100,000,000 and all other monies due or to become due from eagle star holdings PLC to eagle star loans limited under the loan agreement dated 31ST december 1991 and/or under this legal mortgage
    Brèves mentions
    Freehold land on the south side of hayden lane,cheltenham,gloucestershire together with all buildings and other erections fixed plant machinery and fixtures (other than tenants' or trade fixtures) thereon.benefit of all agreements,leases,tenancies,rights,licences,covenants and conditions.
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Loans Limited
    Transactions
    • 20 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ARLE CENTRE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 sept. 2010Commencement of winding up
    17 mars 2011Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Anthony R Fanshawe
    41 Castle Way
    SO14 2BW Southampton
    practitioner
    41 Castle Way
    SO14 2BW Southampton
    Julie Anne Palmer
    41 Castle Way
    SO14 2BW Southampton
    Hampshire
    practitioner
    41 Castle Way
    SO14 2BW Southampton
    Hampshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0