HARBOUR PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHARBOUR PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01833719
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HARBOUR PROPERTIES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe HARBOUR PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Cornwall House Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    West Midlands
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HARBOUR PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FLAMELINK LIMITED18 juil. 198418 juil. 1984

    Quels sont les derniers comptes de HARBOUR PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour HARBOUR PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Notification de Dollplace Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 juin 2023

    2 pagesPSC02

    Cessation de Goodman Real Estate Services (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 juin 2023

    1 pagesPSC07

    Statuts

    26 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Conflict of interest 07/06/2023
    RES13
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    État du capital après une attribution d'actions au 07 juin 2023

    • Capital: GBP 3
    3 pagesSH01

    État du capital au 08 juin 2023

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 23 avr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Peter Christopher Ralston le 20 sept. 2021

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Paul Reed le 20 sept. 2021

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Martin Cornell le 20 sept. 2021

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2022

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 avr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2021

    8 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Ancosec Limited le 20 sept. 2021

    1 pagesCH04

    Modification des détails de Goodman Real Estate Services (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 sept. 2021

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de Nelson House Central Boulevard, Blythe Valley Park Solihull West Midlands B90 8BG à Cornwall House Blythe Gate Blythe Valley Park Solihull West Midlands B90 8AF le 20 sept. 2021

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 avr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 23 avr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de HARBOUR PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ANCOSEC LIMITED
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    West Midlands
    United Kingdom
    Secrétaire
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    West Midlands
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement3611403
    111724450001
    CORNELL, James Martin
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    Administrateur
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    EnglandBritish148803950001
    RALSTON, Peter Christopher
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    Administrateur
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    United KingdomBritish110237280002
    REED, Robert Paul
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    Administrateur
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    United KingdomBritish148032280006
    DUFFIELD, David Mark Johnston
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    British49654480002
    EVANS, David Malcolm
    Springdale
    Shobley
    BH24 3HT Ringwood
    Hampshire
    Secrétaire
    Springdale
    Shobley
    BH24 3HT Ringwood
    Hampshire
    British27482710001
    FERGUSON, Iain Donald
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Secrétaire
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    British10297860001
    LYNE, Sarah Jane
    11 Abelia Close
    West End
    GU24 9PG Woking
    Surrey
    Secrétaire
    11 Abelia Close
    West End
    GU24 9PG Woking
    Surrey
    British49635520003
    READ, Jonathan David
    179 Tanworth Lane
    Shirley
    B90 4BZ Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    179 Tanworth Lane
    Shirley
    B90 4BZ Solihull
    West Midlands
    British77460610002
    SWAIN, John Kenneth
    77 Grosvenor Street
    W1A 2BT London
    Secrétaire
    77 Grosvenor Street
    W1A 2BT London
    British33262350001
    AUSTEN, Jonathan Martin
    Lygon Croft
    Sandy Way
    KT11 2EY Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Lygon Croft
    Sandy Way
    KT11 2EY Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish51921200001
    CHATER, Beth Salena
    Langham Lodge
    Bucklebury Alley
    RG18 9NH Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Langham Lodge
    Bucklebury Alley
    RG18 9NH Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish60464290003
    DEIGMAN, Patrick
    Frith Hill House
    Frith Hill
    HP16 0QR Great Missenden
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Frith Hill House
    Frith Hill
    HP16 0QR Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish37099910001
    DIGBY, Michael Essex
    Hillier Parker May & Rowden
    77 Grosvenor Street
    W1A 2BT London
    Administrateur
    Hillier Parker May & Rowden
    77 Grosvenor Street
    W1A 2BT London
    British12476600001
    DUFFIELD, David Mark Johnston
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    Administrateur
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    EnglandBritish49654480002
    FERGUSON, Iain Donald
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish10297860001
    FLETCHER, David Jonathan Richard
    Stratton House
    Stratton Street
    W1X 5FE London
    Administrateur
    Stratton House
    Stratton Street
    W1X 5FE London
    United KingdomBritish10597290001
    JOHNSTON, Andrew James
    Central Boulevard, Blythe Valley Park
    B90 8BG Solihull
    Nelson House
    West Midlands
    England
    Administrateur
    Central Boulevard, Blythe Valley Park
    B90 8BG Solihull
    Nelson House
    West Midlands
    England
    United KingdomBritish131001620001
    LYALL, Stephen Charles
    77 Grosvenor Street
    W1A 2BT London
    Administrateur
    77 Grosvenor Street
    W1A 2BT London
    British44917590001
    MOHANLAL, Satish
    21 Mostyn Gardens
    NW10 5QU London
    Administrateur
    21 Mostyn Gardens
    NW10 5QU London
    British51579180001
    MURRAY, Nicholas Stuart Granville
    Oak House
    51 Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Oak House
    51 Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish29664370001
    O'SULLIVAN, Michael James
    Greenlawns
    21 Broad Highway
    KT11 2RR Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Greenlawns
    21 Broad Highway
    KT11 2RR Cobham
    Surrey
    Australian109785090002
    PILGRIM, Simon Richard Ellis
    Maytrees 27 Portmore Park Road
    KT13 8ET Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    Maytrees 27 Portmore Park Road
    KT13 8ET Weybridge
    Surrey
    British16398280001
    POPE, Nigel Howard
    Hawthorne Road
    BR1 2HN Bromley
    17
    Kent
    Administrateur
    Hawthorne Road
    BR1 2HN Bromley
    17
    Kent
    EnglandBritish29583660002
    PULSFORD, Jeffrey Mark
    Denesfield
    16 Lytton Park
    KT11 2HB Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Denesfield
    16 Lytton Park
    KT11 2HB Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish49776690004
    ROGERS, Hugh Edward
    24 Sonning Meadows
    RG4 6XB Sonning
    Berkshire
    Administrateur
    24 Sonning Meadows
    RG4 6XB Sonning
    Berkshire
    British13156340003
    SADLER, Nicholas James
    Clivia Windmill Hill
    Coleshill
    HP7 0LZ Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Clivia Windmill Hill
    Coleshill
    HP7 0LZ Amersham
    Buckinghamshire
    British38200390001
    SMITH, Oliver
    48 Redcliffe Gardens
    SW10 9HB London
    Administrateur
    48 Redcliffe Gardens
    SW10 9HB London
    British83475590003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HARBOUR PROPERTIES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    13 juin 2023
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement5595895
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    West Midlands
    United Kingdom
    23 avr. 2018
    Blythe Gate
    Blythe Valley Park
    B90 8AF Solihull
    Cornwall House
    West Midlands
    United Kingdom
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement3608348
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Central Boulevard
    Blythe Valley Park
    B90 8BG Solihull
    Nelson House
    West Midlands
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Central Boulevard
    Blythe Valley Park
    B90 8BG Solihull
    Nelson House
    West Midlands
    United Kingdom
    Oui
    Forme juridiqueUnlimited With Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement1464587
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    HARBOUR PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 16 nov. 1999
    Livré le 19 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 16TH november 1999 and on any account whatsoever and other sums due under the legal charge dated 16TH november 1999
    Brèves mentions
    F/H property at western avenue uxbridge t/no BM110852 & BM85925 with all buildings erections fixtures and fittings fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Gamma Holding (UK) Limited
    Transactions
    • 19 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 oct. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deposit of title deeds
    Créé le 29 mai 1985
    Livré le 11 juin 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £73,000 under the terms of a sale and purchase agreement d/d 30/4/85.
    Brèves mentions
    Part of land k/a oak view 3 gull copse park gate t/n:- hp 202570.
    Personnes ayant droit
    • Jazzman Limited
    Transactions
    • 11 juin 1985Enregistrement d'une charge
    • 20 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deposit of deeds w/i
    Créé le 30 avr. 1985
    Livré le 04 mai 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £66,000 under the terms of an agreement of even date
    Brèves mentions
    Land to the north of little park farm, little park farm road, titchfield and the land to the east of hazelgrove foreham T.nos. Hp 95290 & hp 118180.
    Personnes ayant droit
    • Cay Builders (Wight) Limited
    Transactions
    • 04 mai 1985Enregistrement d'une charge
    • 20 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deposit of deeds w/i
    Créé le 30 avr. 1985
    Livré le 04 mai 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £21,000 under the terms of an agreement to even date
    Brèves mentions
    Land to the north west at hill coppice road. T.N. hp 1083149.
    Personnes ayant droit
    • Cay Builders (Wight) Limited
    Transactions
    • 04 mai 1985Enregistrement d'une charge
    • 20 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deposit of deeds w/i
    Créé le 30 avr. 1985
    Livré le 03 mai 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £108,000 under the terms of an agreement of even date
    Brèves mentions
    Land at ashley little park gull coppice titchfield T.N. hp 210763.
    Personnes ayant droit
    • Blue Sparkle Investments Limited
    Transactions
    • 03 mai 1985Enregistrement d'une charge
    • 20 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deposit of deeds w/i
    Créé le 30 avr. 1985
    Livré le 03 mai 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £50,000 under the terms of an agreement of even date.
    Brèves mentions
    Land at ashley little park gull coppice, titchfield T.N. hp 210762.
    Personnes ayant droit
    • Middle East Management Limited
    Transactions
    • 03 mai 1985Enregistrement d'une charge
    • 20 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deposit of deeds w/i
    Créé le 30 avr. 1985
    Livré le 03 mai 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee not cxceeding £103,000 under the terms of an agreement of even date.
    Brèves mentions
    Land at gull copse park gate. T.N.hp 262278.
    Personnes ayant droit
    • Jazzman Limited
    Transactions
    • 03 mai 1985Enregistrement d'une charge
    • 20 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 févr. 1985
    Livré le 05 févr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement d/d 21 december 1984 or this charge.
    Brèves mentions
    Land at park gate titchfield hampshire (see doc M18).
    Personnes ayant droit
    • A. J. Peat
    • B. C. Hobbs
    • A. Pascoe Sherlock.
    Transactions
    • 05 févr. 1985Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0