HARBOUR PROPERTIES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | HARBOUR PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01833719 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HARBOUR PROPERTIES LIMITED ?
| Adresse du siège social | Cornwall House Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AF Solihull West Midlands United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HARBOUR PROPERTIES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour HARBOUR PROPERTIES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||||||||||
Notification de Dollplace Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 juin 2023 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||||||||||
Cessation de Goodman Real Estate Services (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 juin 2023 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||||||||||
Statuts | 26 pages | MA | ||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 07 juin 2023
| 3 pages | SH01 | ||||||||||||||||||
État du capital au 08 juin 2023
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||||||
legacy | 2 pages | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 avr. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Peter Christopher Ralston le 20 sept. 2021 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Paul Reed le 20 sept. 2021 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Martin Cornell le 20 sept. 2021 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2022 | 8 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 avr. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2021 | 8 pages | AA | ||||||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Ancosec Limited le 20 sept. 2021 | 1 pages | CH04 | ||||||||||||||||||
Modification des détails de Goodman Real Estate Services (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 sept. 2021 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Nelson House Central Boulevard, Blythe Valley Park Solihull West Midlands B90 8BG à Cornwall House Blythe Gate Blythe Valley Park Solihull West Midlands B90 8AF le 20 sept. 2021 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020 | 8 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 avr. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 avr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de HARBOUR PROPERTIES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCOSEC LIMITED | Secrétaire | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AF Solihull Cornwall House West Midlands United Kingdom |
| 111724450001 | ||||||||||
| CORNELL, James Martin | Administrateur | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AF Solihull Cornwall House United Kingdom | England | British | 148803950001 | |||||||||
| RALSTON, Peter Christopher | Administrateur | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AF Solihull Cornwall House United Kingdom | United Kingdom | British | 110237280002 | |||||||||
| REED, Robert Paul | Administrateur | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AF Solihull Cornwall House United Kingdom | United Kingdom | British | 148032280006 | |||||||||
| DUFFIELD, David Mark Johnston | Secrétaire | 58 West Chiltern Woodcote RG8 0SG Reading Berkshire | British | 49654480002 | ||||||||||
| EVANS, David Malcolm | Secrétaire | Springdale Shobley BH24 3HT Ringwood Hampshire | British | 27482710001 | ||||||||||
| FERGUSON, Iain Donald | Secrétaire | 2 Chalet Close Shootersway Lane HP4 3NR Berkhamsted Hertfordshire | British | 10297860001 | ||||||||||
| LYNE, Sarah Jane | Secrétaire | 11 Abelia Close West End GU24 9PG Woking Surrey | British | 49635520003 | ||||||||||
| READ, Jonathan David | Secrétaire | 179 Tanworth Lane Shirley B90 4BZ Solihull West Midlands | British | 77460610002 | ||||||||||
| SWAIN, John Kenneth | Secrétaire | 77 Grosvenor Street W1A 2BT London | British | 33262350001 | ||||||||||
| AUSTEN, Jonathan Martin | Administrateur | Lygon Croft Sandy Way KT11 2EY Cobham Surrey | United Kingdom | British | 51921200001 | |||||||||
| CHATER, Beth Salena | Administrateur | Langham Lodge Bucklebury Alley RG18 9NH Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 60464290003 | |||||||||
| DEIGMAN, Patrick | Administrateur | Frith Hill House Frith Hill HP16 0QR Great Missenden Buckinghamshire | United Kingdom | British | 37099910001 | |||||||||
| DIGBY, Michael Essex | Administrateur | Hillier Parker May & Rowden 77 Grosvenor Street W1A 2BT London | British | 12476600001 | ||||||||||
| DUFFIELD, David Mark Johnston | Administrateur | 58 West Chiltern Woodcote RG8 0SG Reading Berkshire | England | British | 49654480002 | |||||||||
| FERGUSON, Iain Donald | Administrateur | 2 Chalet Close Shootersway Lane HP4 3NR Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 10297860001 | |||||||||
| FLETCHER, David Jonathan Richard | Administrateur | Stratton House Stratton Street W1X 5FE London | United Kingdom | British | 10597290001 | |||||||||
| JOHNSTON, Andrew James | Administrateur | Central Boulevard, Blythe Valley Park B90 8BG Solihull Nelson House West Midlands England | United Kingdom | British | 131001620001 | |||||||||
| LYALL, Stephen Charles | Administrateur | 77 Grosvenor Street W1A 2BT London | British | 44917590001 | ||||||||||
| MOHANLAL, Satish | Administrateur | 21 Mostyn Gardens NW10 5QU London | British | 51579180001 | ||||||||||
| MURRAY, Nicholas Stuart Granville | Administrateur | Oak House 51 Oxshott Way KT11 2RU Cobham Surrey | United Kingdom | British | 29664370001 | |||||||||
| O'SULLIVAN, Michael James | Administrateur | Greenlawns 21 Broad Highway KT11 2RR Cobham Surrey | Australian | 109785090002 | ||||||||||
| PILGRIM, Simon Richard Ellis | Administrateur | Maytrees 27 Portmore Park Road KT13 8ET Weybridge Surrey | British | 16398280001 | ||||||||||
| POPE, Nigel Howard | Administrateur | Hawthorne Road BR1 2HN Bromley 17 Kent | England | British | 29583660002 | |||||||||
| PULSFORD, Jeffrey Mark | Administrateur | Denesfield 16 Lytton Park KT11 2HB Cobham Surrey | United Kingdom | British | 49776690004 | |||||||||
| ROGERS, Hugh Edward | Administrateur | 24 Sonning Meadows RG4 6XB Sonning Berkshire | British | 13156340003 | ||||||||||
| SADLER, Nicholas James | Administrateur | Clivia Windmill Hill Coleshill HP7 0LZ Amersham Buckinghamshire | British | 38200390001 | ||||||||||
| SMITH, Oliver | Administrateur | 48 Redcliffe Gardens SW10 9HB London | British | 83475590003 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HARBOUR PROPERTIES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollplace Limited | 13 juin 2023 | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AF Solihull Cornwall House United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Goodman Real Estate Services (Uk) Limited | 23 avr. 2018 | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AF Solihull Cornwall House West Midlands United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Goodman Real Estate Developments (2003) | 06 avr. 2016 | Central Boulevard Blythe Valley Park B90 8BG Solihull Nelson House West Midlands United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
HARBOUR PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Créé le 16 nov. 1999 Livré le 19 nov. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 16TH november 1999 and on any account whatsoever and other sums due under the legal charge dated 16TH november 1999 | |
Brèves mentions F/H property at western avenue uxbridge t/no BM110852 & BM85925 with all buildings erections fixtures and fittings fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deposit of title deeds | Créé le 29 mai 1985 Livré le 11 juin 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £73,000 under the terms of a sale and purchase agreement d/d 30/4/85. | |
Brèves mentions Part of land k/a oak view 3 gull copse park gate t/n:- hp 202570. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deposit of deeds w/i | Créé le 30 avr. 1985 Livré le 04 mai 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £66,000 under the terms of an agreement of even date | |
Brèves mentions Land to the north of little park farm, little park farm road, titchfield and the land to the east of hazelgrove foreham T.nos. Hp 95290 & hp 118180. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deposit of deeds w/i | Créé le 30 avr. 1985 Livré le 04 mai 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £21,000 under the terms of an agreement to even date | |
Brèves mentions Land to the north west at hill coppice road. T.N. hp 1083149. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deposit of deeds w/i | Créé le 30 avr. 1985 Livré le 03 mai 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £108,000 under the terms of an agreement of even date | |
Brèves mentions Land at ashley little park gull coppice titchfield T.N. hp 210763. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deposit of deeds w/i | Créé le 30 avr. 1985 Livré le 03 mai 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £50,000 under the terms of an agreement of even date. | |
Brèves mentions Land at ashley little park gull coppice, titchfield T.N. hp 210762. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deposit of deeds w/i | Créé le 30 avr. 1985 Livré le 03 mai 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee not cxceeding £103,000 under the terms of an agreement of even date. | |
Brèves mentions Land at gull copse park gate. T.N.hp 262278. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 05 févr. 1985 Livré le 05 févr. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement d/d 21 december 1984 or this charge. | |
Brèves mentions Land at park gate titchfield hampshire (see doc M18). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0