APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAPPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01836659
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SHAMROCK LEASING LIMITED29 déc. 199729 déc. 1997
    APPOLD LEASING LIMITED09 janv. 199509 janv. 1995
    APPOLD SECURITIES LIMITED06 avr. 199206 avr. 1992
    HOARE GOVETT SECURITIES LIMITED 13 oct. 198613 oct. 1986
    HOARE GOVETT MARKET MAKERS LIMITED22 juil. 198622 juil. 1986
    CHARLES T. PULLEY LIMITED27 juil. 198427 juil. 1984

    Quels sont les derniers comptes de APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de 2 King Edward Street London EC1A 1HQ à 30 Finsbury Square London EC2P 2YU le 30 mai 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 03 mai 2017

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 15 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    6 pagesMR04

    Nomination de Jonathan Howard Redvers Lee en tant qu'administrateur le 26 oct. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard Ian Jones en tant que directeur le 19 oct. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    270 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 avr. 2016

    État du capital au 06 avr. 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2014

    21 pagesAA

    Nomination de Philip John Wood en tant qu'administrateur le 09 juin 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jacob Dutry Van Haeften en tant que directeur le 07 mai 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 avr. 2015

    État du capital au 29 avr. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Jacob Dutry Van Haeften le 28 févr. 2014

    2 pagesCH01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 16 oct. 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Share premium account reduced to zero 15/10/2014
    RES13

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2013

    20 pagesAA

    Cessation de la nomination de Kerry Eamonn O'connell en tant que directeur le 04 août 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 avr. 2014

    État du capital au 15 avr. 2014

    • Capital: GBP 73,575,500
    SH01

    Qui sont les dirigeants de APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MERRILL LYNCH CORPORATE SERVICES LIMITED
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    Secrétaire
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement4929251
    93977210001
    LEE, Jonathan Howard Redvers
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    Administrateur
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    EnglandBritish156416990001
    WOOD, Philip John
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    Administrateur
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    United KingdomBritish173550830001
    CHURCH, Fiona
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    Secrétaire
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    British116911130001
    CLOWES, Stephen Bernard
    Hartsridge
    Harts Lane, South Godstone
    RH9 8LZ Godstone
    Surrey
    Secrétaire
    Hartsridge
    Harts Lane, South Godstone
    RH9 8LZ Godstone
    Surrey
    British40195710004
    LI, Helene Yuk Hing
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    Secrétaire
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    British147657130001
    STEVENS, Robert Brian
    139 Rusthall Avenue
    Chiswick
    W4 1BL London
    Secrétaire
    139 Rusthall Avenue
    Chiswick
    W4 1BL London
    British28371200001
    STEVINSON, Jenny
    95 Stradella Road
    SE24 9HL London
    Secrétaire
    95 Stradella Road
    SE24 9HL London
    British16404200002
    TILGNER, Tracy K
    Flat 8
    55 Queensgate
    SW7 5JW London
    Secrétaire
    Flat 8
    55 Queensgate
    SW7 5JW London
    American36015120001
    ARNUM, Dennis
    Fairacres
    1 Downs Way
    KT20 5DH Tadworth
    Surrey
    Administrateur
    Fairacres
    1 Downs Way
    KT20 5DH Tadworth
    Surrey
    British37241020001
    CLEGG, Simon John
    Hill Cottage
    Reading Road Heckfield
    RG27 0JY Hook
    Hampshire
    Administrateur
    Hill Cottage
    Reading Road Heckfield
    RG27 0JY Hook
    Hampshire
    British61950010001
    CLOWES, Stephen Bernard
    Hartsridge
    Harts Lane, South Godstone
    RH9 8LZ Godstone
    Surrey
    Administrateur
    Hartsridge
    Harts Lane, South Godstone
    RH9 8LZ Godstone
    Surrey
    United KingdomBritish40195710004
    DEYONG, Jacqueline Susan
    Hayes Cottage 192 Old Woking Road
    GU22 8HR Woking
    Surrey
    Administrateur
    Hayes Cottage 192 Old Woking Road
    GU22 8HR Woking
    Surrey
    EnglandBritish25974390001
    DUTRY VAN HAEFTEN, Jacob
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    England
    Administrateur
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    England
    United KingdomDutch172432560002
    DUTTON, Godfrey Thomas
    58 Willingale Way
    SS1 3SN Thorpe Bay
    Essex
    Administrateur
    58 Willingale Way
    SS1 3SN Thorpe Bay
    Essex
    United KingdomBritish42461110001
    HOFFMAN, Mark Thomas
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    Administrateur
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    United KingdomAmerican87065070002
    HOUSTON, Geoffrey Alan
    Ashley House Chiltern Road
    Chesham Bois
    HP6 5PG Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Ashley House Chiltern Road
    Chesham Bois
    HP6 5PG Amersham
    Buckinghamshire
    British62886570001
    JONES, Richard Ian
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    Administrateur
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United KingdomBritish159225600001
    MAZZOLA, Stefano Antonio
    23 Westmoreland Terrace
    SW1V 4AG London
    Administrateur
    23 Westmoreland Terrace
    SW1V 4AG London
    United KingdomBritish8890420001
    O'CONNELL, Kerry Eamonn
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    Administrateur
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United KingdomBritish69128130002
    PITHIA, Kantilal Girdharlal
    Canada Square
    E14 5AQ London
    5
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5AQ London
    5
    British68481610001
    SHEALY, Thomas Theodore
    1 Alie Street
    E1 8DE London
    Administrateur
    1 Alie Street
    E1 8DE London
    American88998990001
    SMITH, Mark Simon Martin
    5 Canada Square
    E14 5AQ London
    Administrateur
    5 Canada Square
    E14 5AQ London
    British121952750001
    STEVENS, Robert Brian
    139 Rusthall Avenue
    Chiswick
    W4 1BL London
    Administrateur
    139 Rusthall Avenue
    Chiswick
    W4 1BL London
    British28371200001
    TETZLAFF, John Stefan Ashby
    5 Canada Square
    E14 5AQ London
    Administrateur
    5 Canada Square
    E14 5AQ London
    British116726040001
    THOMSON, David Fraser
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    Administrateur
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    United KingdomBritish74549300002
    TILGNER, Tracy K
    Flat 8
    55 Queensgate
    SW7 5JW London
    Administrateur
    Flat 8
    55 Queensgate
    SW7 5JW London
    American36015120001
    WESTBROOK, Robert William
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    Administrateur
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United KingdomBritish169811350001
    WHITAKER, Robert Anthony Mattievich
    38 Florin Court
    6/9 Charterhouse Square
    EC1M 6EY London
    Administrateur
    38 Florin Court
    6/9 Charterhouse Square
    EC1M 6EY London
    British66770990001
    WITHAM, Geoffrey Alan
    215 Hanging Hill Lane
    Hutton
    CM13 2QG Brentwood
    Essex
    Administrateur
    215 Hanging Hill Lane
    Hutton
    CM13 2QG Brentwood
    Essex
    British7752430001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Bank Of America Corporation
    1209 Orange Street
    Wilmington
    The Corporation Trust Center
    De 19801
    Usa
    06 avr. 2016
    1209 Orange Street
    Wilmington
    The Corporation Trust Center
    De 19801
    Usa
    Non
    Forme juridiqueCorporation
    Pays d'enregistrementUnited States Of America / Delaware
    Autorité légaleDelaware General Corporation Law
    Lieu d'enregistrementDelaware Secretary Of State
    Numéro d'enregistrementNot Applicable
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of charge
    Créé le 28 févr. 1991
    Livré le 01 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all sums floating charge over stock and other securities (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 01 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 09 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed
    Créé le 22 juin 1990
    Livré le 28 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge over all sums from time to time deposited by the company or for the company's accounts with and held by the mortgagees (see form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transactions
    • 28 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 07 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral agreement
    Créé le 24 févr. 1989
    Livré le 01 mars 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All "collateral" including in particular cash and securities clearance accounts opened in connection with the euro-clear system by the brussels office of morgan guaranty on its books in the name of the company (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transactions
    • 01 mars 1989Enregistrement d'une charge
    • 31 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Letter agreement
    Créé le 28 juil. 1987
    Livré le 12 août 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    See form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A.
    Transactions
    • 12 août 1987Enregistrement d'une charge
    • 31 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 21 juil. 1987
    Livré le 28 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All adrs which were at the date of the security agreement in possession of the chargee and held for the account of the company (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transactions
    • 28 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    • 07 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed
    Créé le 21 juil. 1987
    Livré le 28 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    First fixed charge over all sums from time to time deposited by the company or for the company's account with & held by morgan guaranty trust company in the account (s) in the name of the company denominated "adr pre-release collateral account(s) together with the debts arising therefrom or in respect thereof.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transactions
    • 28 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    • 07 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 23 oct. 1986
    Livré le 04 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the company's rights interest & property present and future in all securities transferred to national westminster bank PLC or its nominees by the stock exchange pursuant to any short term certificate issued to the bank in accordance with the provisions of any written agreement relating to non-endorseable short term certificates for the time being in face between the stock exchange, the company & the bank (for details see form 395).
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    • 09 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge in compliance with the rules and regulations (including council notices) of the stock exchange
    Créé le 23 oct. 1986
    Livré le 03 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All shares stock & other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities (see form 395 dated for 3/11/86 for full details).
    Personnes ayant droit
    • The Stock Exchange of the United Kingdom and the Republic of Ireland
    Transactions
    • 03 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    • 07 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 nov. 1985
    Livré le 25 nov. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the rights interest and property present or future of the company (whether at law or in equity) in all securities transferred to the company or its nominees of the stock exchange present to any short term certificate issued to national westminster bank PLC. See doc M10 for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 nov. 1985Enregistrement d'une charge
    • 09 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 08 août 1985
    Livré le 19 août 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All shares stock and other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities (see doc M9 for details).
    Personnes ayant droit
    • The Stock Exchange
    Transactions
    • 19 août 1985Enregistrement d'une charge
    • 07 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 01 août 1984
    Livré le 17 août 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The securities therein defined together with all benefits arising therefrom and not transferred by the stock exchange to the company for details see doc M8.
    Personnes ayant droit
    • The Stock Exchange
    Transactions
    • 17 août 1984Enregistrement d'une charge
    • 07 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of variation
    Créé le 01 août 1984
    Livré le 17 août 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For varying the terms of the principal charge of even date
    Brèves mentions
    The deed varis the definition of the securities which are subject to the principal charge and also affects the ranking of the principal charge and certain charges in favour of other parties.
    Personnes ayant droit
    • The Stock Exchange
    Transactions
    • 17 août 1984Enregistrement d'une charge
    • 07 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 01 août 1984
    Livré le 16 août 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the rights interest and property present or future of the company (whether at law or in equity) in all shares stock and other securities of any class or description which are from time to time included in and evidenced by any current collateral certificate or supplemental collateral certificate issued pursuant to any operating agreement in writing for further details see doc M6.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 août 1984Enregistrement d'une charge
    • 09 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 mai 2017Commencement of winding up
    07 févr. 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0