CONNAUGHT PARTNERSHIPS LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCONNAUGHT PARTNERSHIPS LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01838150
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CONNAUGHT PARTNERSHIPS LTD ?

    • (4525) /

    Où se situe CONNAUGHT PARTNERSHIPS LTD ?

    Adresse du siège social
    KPMG LLP
    15 Canada Square Canary Wharf
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CONNAUGHT PARTNERSHIPS LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CONNAUGHT PROPERTY SERVICES LTD 05 janv. 200005 janv. 2000
    CONNAUGHT GROUP LIMITED29 déc. 199929 déc. 1999
    CONNAUGHT SOUTHERN LIMITED11 mars 198511 mars 1985
    FORKRIVER LIMITED03 août 198403 août 1984

    Quels sont les derniers comptes de CONNAUGHT PARTNERSHIPS LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour CONNAUGHT PARTNERSHIPS LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    20 pagesLIQ14
    A8Y4VCHN

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 mars 2019

    24 pagesLIQ03
    A81ZC4R7

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:notice of release of liquidator richard heis 22/1/18
    4 pagesLIQ MISC
    A79O4UNV

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 mars 2018

    22 pagesLIQ03
    A73766RF

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    10 pagesLIQ10
    A6WXAKMH

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600
    A6KV030H

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 mars 2017

    25 pages4.68
    A65TW0JE

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:secretary of state release of liquidator
    1 pagesLIQ MISC
    Q5LBVVJ4

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:Secretary of State's Certificate of Release of Liquidator
    1 pagesLIQ MISC
    A5HUEDPA

    Démission d'un liquidateur

    18 pages4.33
    A5G1VUIW

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:C.O. To remove/replace liquidator
    11 pagesLIQ MISC OC
    A5D7CCEJ

    Démission d'un liquidateur

    1 pages4.33
    A5D7CCER

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 mars 2016

    21 pages4.68
    A55XNWQ9

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 mars 2015

    19 pages4.68
    A46JXGGQ

    Changement d'adresse du siège social de Kpmg 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB à 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL le 08 avr. 2015

    2 pagesAD01
    A43SJ9TD

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    2 pagesF10.2
    A3F95YBK

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 mars 2014

    18 pages4.68
    A3739069

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    2 pagesF10.2
    A2I7WUEG

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    2 pagesF10.2
    A2I7WUE8

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    2 pagesF10.2
    A2I7WUE0

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    2 pagesF10.2
    A2I7WUDS

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    2 pagesF10.2
    A2I7WUDK

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    2 pagesF10.2
    A2I7WUDC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    2 pagesF10.2
    A2I7WUD8

    Qui sont les dirigeants de CONNAUGHT PARTNERSHIPS LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JONES, Peter
    34a Old Lane
    Nethertown, Drighlington
    BD11 1LU Bradford
    Administrateur
    34a Old Lane
    Nethertown, Drighlington
    BD11 1LU Bradford
    United KingdomBritishDirector25379730002
    WELLS, David Francis
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Administrateur
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritishAccountant104366980002
    CAVANAGH, Julia
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Secrétaire
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    British146797250001
    CRITCHLOW, Geoffrey David
    24 Windsor Square
    EX8 1JY Exmouth
    Devon
    Secrétaire
    24 Windsor Square
    EX8 1JY Exmouth
    Devon
    British47908530001
    HIDGLEY, Paul Frank
    Newhaven
    Coldwell Lane
    EX12 Axmouth Seaton
    Devon
    Secrétaire
    Newhaven
    Coldwell Lane
    EX12 Axmouth Seaton
    Devon
    British24801280001
    PEAGAM, Garry John
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    Secrétaire
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    BritishGroup Finance Director64426280002
    PHILLIPS, Jackey
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Secrétaire
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    British104367080003
    PIKE, David Kenneth
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    Secrétaire
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    BritishChartered Accountant99914770001
    ANDREWS, Stephen
    1 Burleigh Park
    KT11 2DU Cobham
    Surrey
    Administrateur
    1 Burleigh Park
    KT11 2DU Cobham
    Surrey
    EnglandBritishDirector127799790001
    BRAY, Iain Richard
    198 Banbury Road
    CV37 7HX Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    198 Banbury Road
    CV37 7HX Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritishCommercial Director154064760001
    CRITCHLOW, Geoffrey David
    24 Windsor Square
    EX8 1JY Exmouth
    Devon
    Administrateur
    24 Windsor Square
    EX8 1JY Exmouth
    Devon
    BritishAccountant47908530001
    DARKIN, Andrew
    Coombe Road
    Shaldon
    TQ14 0EX Teignmouth
    Broad Reach
    Devon
    Administrateur
    Coombe Road
    Shaldon
    TQ14 0EX Teignmouth
    Broad Reach
    Devon
    EnglandBritishManaging Director137575700001
    DAVIES, Mark Dingad
    Cold Ash Farm
    Long Lane
    RG18 9LT Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Cold Ash Farm
    Long Lane
    RG18 9LT Newbury
    Berkshire
    EnglandBritishDirector203044250004
    DUCKER, Jackie
    10 Avenue Road
    SO22 5AQ Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    10 Avenue Road
    SO22 5AQ Winchester
    Hampshire
    BritishDirector57381410002
    EVANS, Terence Mervin
    The Cottage Meare Green
    Stoke St Gregory
    TA3 6HY Taunton
    Somerset
    Administrateur
    The Cottage Meare Green
    Stoke St Gregory
    TA3 6HY Taunton
    Somerset
    BritishDirector47913740001
    FLINT, Andrew Michael
    Nore End
    141 Nore Road, Portishead
    BS20 8DX Bristol
    Avon
    Administrateur
    Nore End
    141 Nore Road, Portishead
    BS20 8DX Bristol
    Avon
    BritishDirector68436270001
    FLINT, Andrew Michael
    Nore End
    141 Nore Road, Portishead
    BS20 8DX Bristol
    Avon
    Administrateur
    Nore End
    141 Nore Road, Portishead
    BS20 8DX Bristol
    Avon
    BritishSurveyor68436270001
    HANCOCK, Timothy John
    82 Argus Lofts
    Robert Street
    BN1 4AY Brighton
    East Sussex
    Administrateur
    82 Argus Lofts
    Robert Street
    BN1 4AY Brighton
    East Sussex
    EnglandBritishDirector96124860001
    HILL, Stephen Ronald
    Oakfield House
    Stoke Hill
    EX4 9JN Exeter
    Devon
    Administrateur
    Oakfield House
    Stoke Hill
    EX4 9JN Exeter
    Devon
    United KingdomBritishFinance Director115233060001
    MIDGLEY, Paul Frank
    Newhaven
    Coldwell Lane
    EX14 4AJ Axmouth
    Devon
    Administrateur
    Newhaven
    Coldwell Lane
    EX14 4AJ Axmouth
    Devon
    BritishContract Manager68851460001
    OLDBURY, Stephen James
    20 Stanley Avenue
    Chiswell Green
    AL2 3AB St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    20 Stanley Avenue
    Chiswell Green
    AL2 3AB St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director126379060001
    PIKE, David Kenneth
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    Administrateur
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    EnglandBritishChartered Accountant99914770001
    QUINN, Derek Anthony
    26 Effingham Road
    St Andrews
    BS6 5BJ Bristol
    Administrateur
    26 Effingham Road
    St Andrews
    BS6 5BJ Bristol
    BritishSurveyor72848250001
    ROBERTS, Michael John
    Kibbear Cottage Kibbear
    Trull
    TA3 7LN Taunton
    Somerset
    Administrateur
    Kibbear Cottage Kibbear
    Trull
    TA3 7LN Taunton
    Somerset
    United KingdomBritishNational Sales Director66622050001
    SMITH, Richard David
    Horrells Idestone
    Longdown
    EX6 7BL Exeter
    Devon
    Administrateur
    Horrells Idestone
    Longdown
    EX6 7BL Exeter
    Devon
    BritishCompany Director17374050001
    SPRIGINGS, Ian Campbell
    Mead Cottage Crowhurst Road
    Catsfield
    TN33 9BT Battle
    East Sussex
    England
    Administrateur
    Mead Cottage Crowhurst Road
    Catsfield
    TN33 9BT Battle
    East Sussex
    England
    EnglandBritishQuantity Surveyor50610680001
    STANDING, Roger
    Broomwood Farmhouse
    Trolliloes Lane Cowbeech
    BN27 4QR Hailsham
    East Sussex
    Administrateur
    Broomwood Farmhouse
    Trolliloes Lane Cowbeech
    BN27 4QR Hailsham
    East Sussex
    BritishDirector47913670002
    STEELE, Andrew Philip
    Westering
    8 Five Bells
    TA23 0HZ Watchet
    Somerset
    Administrateur
    Westering
    8 Five Bells
    TA23 0HZ Watchet
    Somerset
    United KingdomBritishCommercial-Chartered Surveyor179702030008
    TINCKNELL, Angela
    Southdown Salcombe Hill
    EX10 0NY Sidmouth
    Devon
    Administrateur
    Southdown Salcombe Hill
    EX10 0NY Sidmouth
    Devon
    BritishCompany Director24801290001
    TINCKNELL, Mark William
    Hayne Barton
    Tipton St. John
    EX10 0AL Sidmouth
    Devon
    Administrateur
    Hayne Barton
    Tipton St. John
    EX10 0AL Sidmouth
    Devon
    EnglandBritishChairman4088810003
    TINCKNELL, William Charles
    Southdown Salcombe Hill
    EX10 0NY Sidmouth
    Devon
    Administrateur
    Southdown Salcombe Hill
    EX10 0NY Sidmouth
    Devon
    BritishEngineering Director4088850001

    CONNAUGHT PARTNERSHIPS LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security agreement
    Créé le 06 août 2009
    Livré le 25 août 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes (the Security Trustee)
    Transactions
    • 25 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Security agreement
    Créé le 10 juil. 2009
    Livré le 23 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (Note Hedging Security Trustee)
    Transactions
    • 23 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    A security agreement
    Créé le 17 août 2007
    Livré le 31 août 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transactions
    • 31 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 10 avr. 2007
    Livré le 13 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £20,204.92 (being equivalent of 3 months of the rents plus vat) or such greater sum (equivalent to 3 months of the rents plus vat from time to time).
    Personnes ayant droit
    • Highgate Properties Limited
    Transactions
    • 13 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee & debenture
    Créé le 13 déc. 2006
    Livré le 16 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Security Trustee for Itself and for Each of Thefinance Parties (The Security Trustee)
    Transactions
    • 16 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Account legal charge
    Créé le 27 oct. 2006
    Livré le 15 nov. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All amounts sitting to the credit of account number 06025288. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ebury Contracting Limited
    Transactions
    • 15 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 17 mai 2004
    Livré le 20 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transactions
    • 20 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 déc. 2000
    Livré le 22 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 22 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 nov. 2000
    Livré le 10 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 07 août 1997
    Livré le 21 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the company's obligations to the bank of ceylon under a lease dated 7 august 1997
    Brèves mentions
    By way of first legal charge the sum of £9,450 ("the deposit") standing to the credit of a deposit account in the bank's name at such clearing bank as it may in its absolute discretion determine.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Ceylon
    Transactions
    • 21 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 juil. 1995
    Livré le 22 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 6 pickering street armley leeds t/n wyk 295189. together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 22 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 sept. 1994
    Livré le 08 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from connaught group limited to the chargee on any account whatsoever under the provisions of the legal charge
    Brèves mentions
    Freehold property known as 109/111 east reech, taunton, somerset together with all fixtures and fittings and the benefit of all rights licences and the goodwill in relation to the business.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 sept. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 15 sept. 1993
    Livré le 17 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 févr. 1993
    Livré le 17 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    102 finlay road gloucester t/n gl 69467.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 mai 1990
    Livré le 14 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H, 16 tolworth rise south surbiton kingston-upon-thames greater london.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 04 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 oct. 1988
    Livré le 09 nov. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 27A tradescent road, london SW8 title no sgl 440185.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 09 nov. 1988Enregistrement d'une charge
    • 04 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 18 nov. 1985
    Livré le 25 nov. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge on undertaking all property & assets present & future including bookdebts & uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 25 nov. 1985Enregistrement d'une charge
    • 04 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CONNAUGHT PARTNERSHIPS LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 sept. 2010Administration started
    05 mars 2013Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    practitioner
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Richard Heis
    Kpmg Corporate Recovery
    P O Box 695
    EC4Y 8BB 8 Salisbury Square
    London
    practitioner
    Kpmg Corporate Recovery
    P O Box 695
    EC4Y 8BB 8 Salisbury Square
    London
    David James Costley-Wood
    One Snow Hill Snow Hill Queensway
    B4 6GM Birmingham
    practitioner
    One Snow Hill Snow Hill Queensway
    B4 6GM Birmingham
    Mark Granville Firmin
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    practitioner
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    2
    DateType
    05 mars 2013Commencement of winding up
    05 mai 2020Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Heis
    Kpmg Corporate Recovery
    P O Box 695
    EC4Y 8BB 8 Salisbury Square
    London
    practitioner
    Kpmg Corporate Recovery
    P O Box 695
    EC4Y 8BB 8 Salisbury Square
    London
    Mark Granville Firmin
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    practitioner
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    practitioner
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    David James Costley-Wood
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester
    practitioner
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester
    Paul Nicholas Dumbell
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    practitioner
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0