MHP COMMUNICATIONS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | MHP COMMUNICATIONS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01855944 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MHP COMMUNICATIONS LIMITED ?
Adresse du siège social | 60w Great Portland Street W1W 7RT London England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MHP COMMUNICATIONS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour MHP COMMUNICATIONS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2022 | 12 pages | AA | ||
legacy | 214 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 8 pages | AA | ||
legacy | 53 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Mark John Sanford en tant que secrétaire le 30 avr. 2022 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Emma Louise Wood en tant que secrétaire le 30 avr. 2022 | 1 pages | TM02 | ||
Changement d'adresse du siège social de 75 Bermondsey Street London SE1 3XF England à 60W Great Portland Street London W1W 7RT le 05 mai 2022 | 1 pages | AD01 | ||
Retrait de la demande de radiation de la société | 1 pages | DS02 | ||
Nomination de Mr Jonathan Andrew Peachey en tant qu'administrateur le 08 mars 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Peter Jonathan Harris en tant qu'administrateur le 08 mars 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de William Michael Thompson en tant que directeur le 08 mars 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Emma Louise Wood en tant que secrétaire le 08 mars 2022 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Lawrence Jeffrey Diamond en tant que directeur le 08 mars 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Paul Jason Caine en tant que directeur le 08 mars 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Collin Roy Abert en tant que directeur le 08 mars 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 60 Great Portland Street London W1W 7RT à 75 Bermondsey Street London SE1 3XF le 08 mars 2022 | 1 pages | AD01 | ||
Qui sont les dirigeants de MHP COMMUNICATIONS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANFORD, Mark John | Secrétaire | Great Portland Street W1W 7RT London 60w England | 295499510001 | |||||||
HARRIS, Peter Jonathan | Administrateur | Great Portland Street W1W 7RT London 60w England | England | British | Chief Financial Officer | 40917640001 | ||||
PEACHEY, Jonathan Andrew | Administrateur | Great Portland Street W1W 7RT London 60w England | England | British | Chief Operating Officer | 141274820001 | ||||
COLE, Mary Louise | Secrétaire | Great Portland Street W1W 7RT London 60 | 177903200001 | |||||||
EWING, Susanna | Secrétaire | Great Portland Street W1W 7RT London 60 | 156508470001 | |||||||
HARRIS, Peter | Secrétaire | Great Portland Street W1W 7RT London 60 | 151524540001 | |||||||
RUBEN, Stephen Michael | Secrétaire | 16 Pickhurst Green BR2 7QT Bromley | British | 73290610004 | ||||||
VAUGHAN, Mervyn John | Secrétaire | The Old Mill Park Road BA4 5BS Shepton Mallet Somerset | British | 4830930001 | ||||||
WOOD, Emma Louise | Secrétaire | Great Portland Street W1W 7RT London 60w England | 293364200001 | |||||||
ABERT, Collin Roy | Administrateur | N Michigan Ave Ste 3900 60611 Chicago 676 United States | United States | American | Private Equity | 246023210001 | ||||
BENDER, Brian Geoffrey, Sir | Administrateur | Rosendale Road SE21 8HE London 137 Uk | United Kingdom | British | None | 67196140001 | ||||
BIRTWISTLE, Michael David John | Administrateur | Great Portland Street W1D 7RT London 60 | United Kingdom | British | Consultant | 140365820001 | ||||
BISS, Adele | Administrateur | 7 Elsworthy Road NW3 3DS London | England | British | Director | 4429990001 | ||||
CAINE, Paul Jason | Administrateur | West 43rd Street Floor 8 10036 New York 229 Ny United States | United States | American | Company Director | 246023770001 | ||||
COLLINS, Antonia Gay | Administrateur | South Cadbury BA22 7HA Yeovil South Cadbury House Somerset | Uk | British | Financial Pr | 165151170001 | ||||
COWARD, Nicholas Ian | Administrateur | 340 Old Ford Road E3 5TA London | United Kingdom | British | Director | 60192140002 | ||||
DAVIES, Roger Oliver | Administrateur | 7 Elsworthy Road NW3 3DS London | United Kingdom | British | Director | 13540001 | ||||
DAY, Ian Philip | Administrateur | 5b Bury Lane Codicote SG4 8XX Hitchin Hertfordshire | England | British | Director | 74800310002 | ||||
DESHMUKH, Sacha Shisheer | Administrateur | 262d Finchley Road NW3 7AA London | England | British | Director | 72077120001 | ||||
DEVINE, Gavin Richard | Administrateur | Grosvenor Road W4 4EG London 44 | United Kingdom | British | Director | 105528610002 | ||||
DIAMOND, Lawrence Jeffrey | Administrateur | West 43rd Street Floor 8 10036 New York 229 Ny United States | United States | American | Chief Financial Officer | 246641140001 | ||||
HARRIS, Peter Jonathan | Administrateur | Great Portland Street W1W 7RT London 60 | England | British | Director | 40917640001 | ||||
HOWARD, Jane Alison | Administrateur | 121 Ridgway Wimbledon Village SW19 4RE London | England | British | Chairman | 51904570002 | ||||
JAQUES, Andrew Gavin | Administrateur | Langthorne Street SW6 6JT London 15 | England | British | Pr Consultant | 157090310001 | ||||
KLEIN, Deborah | Administrateur | Great Portland Street W1W 7RT London 60 | United Kingdom | British | Chief Executive | 104574070001 | ||||
LEVER, Christopher John | Administrateur | Flat 504 25 Dorset Square NW1 6QG London | British | Finance Director | 108850600001 | |||||
LEWIS, Deborah Jane | Administrateur | 27 Elthiron Road SW6 4BP London | United Kingdom | British | Managing Director | 51904510003 | ||||
MARTIN, Ashley Graham | Administrateur | Great Portland Street W1W 7RT London 60 | United Kingdom | British | Finance Director | 169305720001 | ||||
MATTHEWS, Christopher Wynne | Administrateur | Hawksfold Stables Hawksfold Lane West GU27 3NT Fernhurst West Sussex | United Kingdom | British | Company Director | 35887470006 | ||||
MOFFATT, James Nicholas Peter | Administrateur | Great Portland Street W1W 7RT London 60 United Kingdom | United Kingdom | British | Ceo | 158034000001 | ||||
NICOLLS, Andrew Darsie | Administrateur | The Common W5 3TR London 16 United Kingdom | United Kingdom | British | Pr Consultant | 54787500004 | ||||
PAYTON, Tim | Administrateur | Harringay Road N15 3HP London 181 | England | British | Director | 130747940001 | ||||
ROJAS, James Kenneth, Mr. | Administrateur | 60 Great Portland Street W1W 7RT London Engine England | United States | American | Cfo | 208189170001 | ||||
RUBEN, Stephen Michael | Administrateur | 16 Pickhurst Green BR2 7QT Bromley | United Kingdom | British | Director | 73290610004 | ||||
SCOTT, Peter John | Administrateur | 9 Pelham Crescent South Kensington SW7 2NP London Middlesex | England | British | Director | 97249440006 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MHP COMMUNICATIONS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Engine Group Limited | 06 avr. 2016 | Great Portland Street W1W 7RT London 60 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
MHP COMMUNICATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 26 juil. 2013 Livré le 31 juil. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 22 avr. 2013 Livré le 29 avr. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 20 mai 2011 Livré le 04 juin 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each chargor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of accession | Créé le 05 mars 2008 Livré le 07 mars 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each chargor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 11 nov. 2005 Livré le 25 nov. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Lease security assignemnt & charge | Créé le 29 mars 1985 Livré le 19 avr. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement & a lease agreement both dated 29.3.85 | |
Brèves mentions All rights title benefit and interest of the company in & to a lease agreement dated 29.3.85. all the equipment & goods and the proceeds thereof (see doc M9). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Lease security assignment & charge | Créé le 29 mars 1985 Livré le 19 avr. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement & a lease agreement both dated 29.3.85 | |
Brèves mentions All rights title benefit and interest of the company in & to a lease agreement dated 29.3.85. all the equipment & goods and the proceeds thereof (see doc M8). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Lease security assignment & charge | Créé le 29 mars 1985 Livré le 19 avr. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement & a lease agreement both dated 29.03.85 | |
Brèves mentions All rights title benefit and interest of the company in & to a lease agreement dated 29.3.85. all the equipment & goods and the proceeds thereof (see doc M7). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0