MHP COMMUNICATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMHP COMMUNICATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01855944
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MHP COMMUNICATIONS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe MHP COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    60w Great Portland Street
    W1W 7RT London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MHP COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MANDATE COMMUNICATIONS LIMITED21 nov. 200721 nov. 2007
    A S BISS AND COMPANY LIMITED01 avr. 200401 avr. 2004
    EMBOROUGH LIMITED19 août 198819 août 1988
    EMBOROUGH LEASING LIMITED16 oct. 198416 oct. 1984

    Quels sont les derniers comptes de MHP COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour MHP COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2022

    12 pagesAA

    legacy

    214 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    8 pagesAA

    legacy

    53 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Mark John Sanford en tant que secrétaire le 30 avr. 2022

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Emma Louise Wood en tant que secrétaire le 30 avr. 2022

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de 75 Bermondsey Street London SE1 3XF England à 60W Great Portland Street London W1W 7RT le 05 mai 2022

    1 pagesAD01

    Retrait de la demande de radiation de la société

    1 pagesDS02

    Nomination de Mr Jonathan Andrew Peachey en tant qu'administrateur le 08 mars 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Peter Jonathan Harris en tant qu'administrateur le 08 mars 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de William Michael Thompson en tant que directeur le 08 mars 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Emma Louise Wood en tant que secrétaire le 08 mars 2022

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Lawrence Jeffrey Diamond en tant que directeur le 08 mars 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Paul Jason Caine en tant que directeur le 08 mars 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Collin Roy Abert en tant que directeur le 08 mars 2022

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 60 Great Portland Street London W1W 7RT à 75 Bermondsey Street London SE1 3XF le 08 mars 2022

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de MHP COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SANFORD, Mark John
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60w
    England
    Secrétaire
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60w
    England
    295499510001
    HARRIS, Peter Jonathan
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60w
    England
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60w
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer40917640001
    PEACHEY, Jonathan Andrew
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60w
    England
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60w
    England
    EnglandBritishChief Operating Officer141274820001
    COLE, Mary Louise
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    Secrétaire
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    177903200001
    EWING, Susanna
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    Secrétaire
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    156508470001
    HARRIS, Peter
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    Secrétaire
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    151524540001
    RUBEN, Stephen Michael
    16 Pickhurst Green
    BR2 7QT Bromley
    Secrétaire
    16 Pickhurst Green
    BR2 7QT Bromley
    British73290610004
    VAUGHAN, Mervyn John
    The Old Mill
    Park Road
    BA4 5BS Shepton Mallet
    Somerset
    Secrétaire
    The Old Mill
    Park Road
    BA4 5BS Shepton Mallet
    Somerset
    British4830930001
    WOOD, Emma Louise
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60w
    England
    Secrétaire
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60w
    England
    293364200001
    ABERT, Collin Roy
    N Michigan Ave
    Ste 3900
    60611 Chicago
    676
    United States
    Administrateur
    N Michigan Ave
    Ste 3900
    60611 Chicago
    676
    United States
    United StatesAmericanPrivate Equity246023210001
    BENDER, Brian Geoffrey, Sir
    Rosendale Road
    SE21 8HE London
    137
    Uk
    Administrateur
    Rosendale Road
    SE21 8HE London
    137
    Uk
    United KingdomBritishNone67196140001
    BIRTWISTLE, Michael David John
    Great Portland Street
    W1D 7RT London
    60
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1D 7RT London
    60
    United KingdomBritishConsultant140365820001
    BISS, Adele
    7 Elsworthy Road
    NW3 3DS London
    Administrateur
    7 Elsworthy Road
    NW3 3DS London
    EnglandBritishDirector4429990001
    CAINE, Paul Jason
    West 43rd Street
    Floor 8
    10036 New York
    229
    Ny
    United States
    Administrateur
    West 43rd Street
    Floor 8
    10036 New York
    229
    Ny
    United States
    United StatesAmericanCompany Director246023770001
    COLLINS, Antonia Gay
    South Cadbury
    BA22 7HA Yeovil
    South Cadbury House
    Somerset
    Administrateur
    South Cadbury
    BA22 7HA Yeovil
    South Cadbury House
    Somerset
    UkBritishFinancial Pr165151170001
    COWARD, Nicholas Ian
    340 Old Ford Road
    E3 5TA London
    Administrateur
    340 Old Ford Road
    E3 5TA London
    United KingdomBritishDirector60192140002
    DAVIES, Roger Oliver
    7 Elsworthy Road
    NW3 3DS London
    Administrateur
    7 Elsworthy Road
    NW3 3DS London
    United KingdomBritishDirector13540001
    DAY, Ian Philip
    5b Bury Lane
    Codicote
    SG4 8XX Hitchin
    Hertfordshire
    Administrateur
    5b Bury Lane
    Codicote
    SG4 8XX Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector74800310002
    DESHMUKH, Sacha Shisheer
    262d Finchley Road
    NW3 7AA London
    Administrateur
    262d Finchley Road
    NW3 7AA London
    EnglandBritishDirector72077120001
    DEVINE, Gavin Richard
    Grosvenor Road
    W4 4EG London
    44
    Administrateur
    Grosvenor Road
    W4 4EG London
    44
    United KingdomBritishDirector105528610002
    DIAMOND, Lawrence Jeffrey
    West 43rd Street
    Floor 8
    10036 New York
    229
    Ny
    United States
    Administrateur
    West 43rd Street
    Floor 8
    10036 New York
    229
    Ny
    United States
    United StatesAmericanChief Financial Officer246641140001
    HARRIS, Peter Jonathan
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    EnglandBritishDirector40917640001
    HOWARD, Jane Alison
    121 Ridgway
    Wimbledon Village
    SW19 4RE London
    Administrateur
    121 Ridgway
    Wimbledon Village
    SW19 4RE London
    EnglandBritishChairman51904570002
    JAQUES, Andrew Gavin
    Langthorne Street
    SW6 6JT London
    15
    Administrateur
    Langthorne Street
    SW6 6JT London
    15
    EnglandBritishPr Consultant157090310001
    KLEIN, Deborah
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    United KingdomBritishChief Executive104574070001
    LEVER, Christopher John
    Flat 504
    25 Dorset Square
    NW1 6QG London
    Administrateur
    Flat 504
    25 Dorset Square
    NW1 6QG London
    BritishFinance Director108850600001
    LEWIS, Deborah Jane
    27 Elthiron Road
    SW6 4BP London
    Administrateur
    27 Elthiron Road
    SW6 4BP London
    United KingdomBritishManaging Director51904510003
    MARTIN, Ashley Graham
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    United KingdomBritishFinance Director169305720001
    MATTHEWS, Christopher Wynne
    Hawksfold Stables
    Hawksfold Lane West
    GU27 3NT Fernhurst
    West Sussex
    Administrateur
    Hawksfold Stables
    Hawksfold Lane West
    GU27 3NT Fernhurst
    West Sussex
    United KingdomBritishCompany Director35887470006
    MOFFATT, James Nicholas Peter
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    United Kingdom
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    United Kingdom
    United KingdomBritishCeo158034000001
    NICOLLS, Andrew Darsie
    The Common
    W5 3TR London
    16
    United Kingdom
    Administrateur
    The Common
    W5 3TR London
    16
    United Kingdom
    United KingdomBritishPr Consultant54787500004
    PAYTON, Tim
    Harringay Road
    N15 3HP London
    181
    Administrateur
    Harringay Road
    N15 3HP London
    181
    EnglandBritishDirector130747940001
    ROJAS, James Kenneth, Mr.
    60 Great Portland Street
    W1W 7RT London
    Engine
    England
    Administrateur
    60 Great Portland Street
    W1W 7RT London
    Engine
    England
    United StatesAmericanCfo208189170001
    RUBEN, Stephen Michael
    16 Pickhurst Green
    BR2 7QT Bromley
    Administrateur
    16 Pickhurst Green
    BR2 7QT Bromley
    United KingdomBritishDirector73290610004
    SCOTT, Peter John
    9 Pelham Crescent
    South Kensington
    SW7 2NP London
    Middlesex
    Administrateur
    9 Pelham Crescent
    South Kensington
    SW7 2NP London
    Middlesex
    EnglandBritishDirector97249440006

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MHP COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05015446
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    MHP COMMUNICATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 26 juil. 2013
    Livré le 31 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Incap Finance B.V.
    Transactions
    • 31 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 09 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 22 avr. 2013
    Livré le 29 avr. 2013
    Totalement satisfaite
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 avr. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 09 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 20 mai 2011
    Livré le 04 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 04 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 09 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession
    Créé le 05 mars 2008
    Livré le 07 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Governor and Company of the Bank of Ireland (The Security Trustee)
    Transactions
    • 07 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 09 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 11 nov. 2005
    Livré le 25 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 25 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Lease security assignemnt & charge
    Créé le 29 mars 1985
    Livré le 19 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement & a lease agreement both dated 29.3.85
    Brèves mentions
    All rights title benefit and interest of the company in & to a lease agreement dated 29.3.85. all the equipment & goods and the proceeds thereof (see doc M9).
    Personnes ayant droit
    • Adele Sophie Biss
    Transactions
    • 19 avr. 1985Enregistrement d'une charge
    • 16 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Lease security assignment & charge
    Créé le 29 mars 1985
    Livré le 19 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement & a lease agreement both dated 29.3.85
    Brèves mentions
    All rights title benefit and interest of the company in & to a lease agreement dated 29.3.85. all the equipment & goods and the proceeds thereof (see doc M8).
    Personnes ayant droit
    • Adele Sophie Biss
    Transactions
    • 19 avr. 1985Enregistrement d'une charge
    • 16 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Lease security assignment & charge
    Créé le 29 mars 1985
    Livré le 19 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement & a lease agreement both dated 29.03.85
    Brèves mentions
    All rights title benefit and interest of the company in & to a lease agreement dated 29.3.85. all the equipment & goods and the proceeds thereof (see doc M7).
    Personnes ayant droit
    • Adele Sophie Biss
    Transactions
    • 19 avr. 1985Enregistrement d'une charge
    • 16 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0