PRISM ESTATES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPRISM ESTATES LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01856071
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PRISM ESTATES LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe PRISM ESTATES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Raydale Barn
    Sandy Lane
    RH20 1EH Fittleworth
    West Sussex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PRISM ESTATES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ELDERFIND LIMITED16 juin 199516 juin 1995
    PRISM ESTATES LIMITED12 avr. 199512 avr. 1995
    MANORCEDAR LIMITED16 oct. 198416 oct. 1984

    Quels sont les derniers comptes de PRISM ESTATES LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 juin 2024
    Date d'échéance des prochains comptes31 mars 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PRISM ESTATES LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au26 juin 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation10 juil. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au26 juin 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour PRISM ESTATES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 26 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XD66AZT6

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2023

    9 pagesAA
    XCZND4HM

    Déclaration de confirmation établie le 26 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XC6NWLOJ

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2022

    9 pagesAA
    XC0BROY0

    Déclaration de confirmation établie le 26 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XB7JVWX5

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2021

    9 pagesAA
    XB3831I9

    Déclaration de confirmation établie le 26 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XA8S532Q

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2020

    9 pagesAA
    XA7CUC10

    Déclaration de confirmation établie le 26 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X987W4CB

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2019

    8 pagesAA
    X910IHZ7

    Déclaration de confirmation établie le 26 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X88EGGTN

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2018

    8 pagesAA
    X819KLL9

    Déclaration de confirmation établie le 27 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X79NKPPN

    Comptes consolidés établis au 30 juin 2017

    7 pagesAA
    X6XXCJ3F

    Déclaration de confirmation établie le 27 juin 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X69GO0PN

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2016

    6 pagesAA
    A63CAY6B

    Déclaration de confirmation établie le 04 juil. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01
    X5AI05E2

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2015

    6 pagesAA
    X52XIA9F

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    2 pagesMR04
    X4XWOM17

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    4 pagesMR04
    A4JO0R0X

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 juin 2015

    État du capital au 29 juin 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01
    X4ALDTUO

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2014

    8 pagesAA
    X42UCH4Z

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juil. 2014

    État du capital au 15 juil. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01
    X3C6FQOJ

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2013

    11 pagesAA
    X322PHU2

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 juin 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 25 juin 2013

    SH01
    X2B9BU0A

    Qui sont les dirigeants de PRISM ESTATES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DANCER, Nigel Candsell
    Raydale
    Sandy Lane
    RH20 1EH Fittleworth
    West Sussex
    Administrateur
    Raydale
    Sandy Lane
    RH20 1EH Fittleworth
    West Sussex
    EnglandBritishChartered Surveyor54900300002
    FRENCH, Graham John Canfor
    Neaves Cottage
    Stone Pit Lane
    BN5 9QU Henfield
    West Sussex
    Secrétaire
    Neaves Cottage
    Stone Pit Lane
    BN5 9QU Henfield
    West Sussex
    BritishChartered Surveyor62405440001
    FRENCH, Rosemary Wade
    Badger Wood House Clappers Lane
    Fulking
    BN5 9NJ Henfield
    West Sussex
    Secrétaire
    Badger Wood House Clappers Lane
    Fulking
    BN5 9NJ Henfield
    West Sussex
    British16573780001
    FRENCH, Graham John Canfor
    Neaves Cottage
    Stone Pit Lane
    BN5 9QU Henfield
    West Sussex
    Administrateur
    Neaves Cottage
    Stone Pit Lane
    BN5 9QU Henfield
    West Sussex
    United KingdomBritishChartered Surveyor62405440001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PRISM ESTATES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Nigel Candsell Dancer
    Raydale Barn
    Sandy Lane
    RH20 1EH Fittleworth
    West Sussex
    06 avr. 2016
    Raydale Barn
    Sandy Lane
    RH20 1EH Fittleworth
    West Sussex
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    PRISM ESTATES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 11 févr. 2011
    Livré le 19 févr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1 hive head road horndean hampshire t/no HP455926 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 nov. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 11 févr. 2011
    Livré le 19 févr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    131-135 taunton road bridgwater devon t/nos ST216111 ST191891 and ST86901 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 04 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 03 juil. 2009
    Livré le 04 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Sainsburys local crowborough hill crowborough t/n ESX264322 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 13 août 2004
    Livré le 17 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any of the beneficiaries
    Brèves mentions
    F/H land dbs garages crowborough hill crowborough sussex t/n ESX264332 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including debts goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Asset Finance PLC as Agent for the Beneficiaries
    Transactions
    • 17 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 27 juin 2003
    Livré le 05 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or caldism developments limited to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    100 ordinary shares of £1 each in the issued share capital of caldism developments limited and all dividends interest and other money payable to the chargor.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Asset Finance PLC (Trading as Anglo Irish Development Finance)
    Transactions
    • 05 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge on shares
    Créé le 19 août 1999
    Livré le 26 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liabilities of drivemix limited and/or the company to the chargee or any company which is a member of the same group of companies as the bank (an associated company) under the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge: the investments and all dividends,interest and other money payable in respect of the investments.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 26 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge on shares
    Créé le 03 août 1999
    Livré le 06 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liabilities of carmichael securities limited (the "borrower") owed or expressed to be owed to the chargee or any company from time to time a member of the same group of companies as the chargee and from the company under the charge
    Brèves mentions
    100 ordinary shares of £1.00 each in the issued share capital of carmichale securities limited all stock shares and other securities including all dividends interest and other money payable see form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Amglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 06 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 août 1995
    Livré le 17 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Basement flat, 28 norfolk road, brighton, east sussex t/no.ESX164854.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 mars 1989
    Livré le 07 mars 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Barn no 4 rospletha farm porthclims cornwall.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 mars 1989Enregistrement d'une charge
    • 27 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 août 1988
    Livré le 05 sept. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    28 norflk road, brighton, east sussex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 sept. 1988Enregistrement d'une charge
    • 27 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 avr. 1986
    Livré le 25 avr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    8 park street, minehead somerset.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 avr. 1986Enregistrement d'une charge
    • 27 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0