STENTION LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTENTION LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01865604
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STENTION LIMITED ?

    • Autre vente au détail en magasin non spécialisé (47190) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe STENTION LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Nursery
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    Suffolk
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de STENTION LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour STENTION LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 25 févr. 2016

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Ian William Furniss en tant que directeur le 17 févr. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ian William Furniss en tant que secrétaire le 17 févr. 2016

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Mark Haddock en tant qu'administrateur le 17 févr. 2016

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2015

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 nov. 2015

    État du capital au 09 nov. 2015

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Andrew Michael Lawrence Staff en tant que directeur le 31 mars 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 déc. 2014

    État du capital au 04 déc. 2014

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2014

    7 pagesAA

    Nomination de Mr Ian William Furniss en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Nomination de Mr Ian William Furniss en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Staff en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 déc. 2013

    État du capital au 05 déc. 2013

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2013

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 févr. 2012

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrew King en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Roger Notcutt en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de STENTION LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HADDOCK, Mark
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Administrateur
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    EnglandBritish205244020001
    ANDREW, Stephen Robert
    Chapel Farmhouse Chapel Lane
    Mouldsworth
    CH3 8BF Chester
    Cheshire
    Secrétaire
    Chapel Farmhouse Chapel Lane
    Mouldsworth
    CH3 8BF Chester
    Cheshire
    British49087860002
    FRASER, Ian Ford
    The Bothy
    Welbeck
    S80 3LW Worksop
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    The Bothy
    Welbeck
    S80 3LW Worksop
    Nottinghamshire
    British17335680002
    FURNISS, Ian William
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Secrétaire
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    188358510001
    STAFF, Andrew Michael Lawrence
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Secrétaire
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    British134035650001
    WALKER, Linda Margaret
    21 Cornelia Crescent
    Belvidere
    SY2 5NA Shrewsbury
    Shropshire
    Secrétaire
    21 Cornelia Crescent
    Belvidere
    SY2 5NA Shrewsbury
    Shropshire
    British48968430002
    ANDREW, Stephen Robert
    Chapel Farmhouse Chapel Lane
    Mouldsworth
    CH3 8BF Chester
    Cheshire
    Administrateur
    Chapel Farmhouse Chapel Lane
    Mouldsworth
    CH3 8BF Chester
    Cheshire
    EnglandBritish49087860002
    BARNES, Ian Malcolm
    Holly House The Fold
    Dorrington
    SY5 7JD Shrewsbury
    Shropshire
    Administrateur
    Holly House The Fold
    Dorrington
    SY5 7JD Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritish37745750001
    COLE, Michael David
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Administrateur
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    United KingdomBritish146969370001
    DRAPER, David
    The Barn
    High Hatfield
    NG9 7ST Cuckney Mansfield
    Nottinghamshire
    Administrateur
    The Barn
    High Hatfield
    NG9 7ST Cuckney Mansfield
    Nottinghamshire
    British22730200002
    FAUN, Stephen
    2 Worleston Close
    CW10 0RG Middlewich
    Cheshire
    Administrateur
    2 Worleston Close
    CW10 0RG Middlewich
    Cheshire
    British81650270001
    FRASER, Ian Ford
    The Bothy
    Welbeck
    S80 3LW Worksop
    Nottinghamshire
    Administrateur
    The Bothy
    Welbeck
    S80 3LW Worksop
    Nottinghamshire
    British17335680002
    FURNISS, Ian William
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Administrateur
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    EnglandBritish117943650001
    GRUNDY, Paul
    74 Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    74 Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritish17333220001
    KING, Andrew James
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Administrateur
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    EnglandBritish217979240001
    NOTCUTT, Roger William
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Administrateur
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    EnglandBritish134038090001
    REEVES, James Alan
    9 Kingscroft Close
    Dore
    S17 3RE Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    9 Kingscroft Close
    Dore
    S17 3RE Sheffield
    South Yorkshire
    British22730190001
    SCOTT, Graham Robert
    216 Main Road
    Goostrey
    CW4 8PE Crewe
    Cheshire
    Administrateur
    216 Main Road
    Goostrey
    CW4 8PE Crewe
    Cheshire
    British44672550004
    SPURLING, Anthony Christopher
    36 Mossgrove Road
    Timperley
    WA15 6LF Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    36 Mossgrove Road
    Timperley
    WA15 6LF Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish106994510001
    STAFF, Andrew Michael Lawrence
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Administrateur
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    EnglandBritish134035650001
    WHITING, Richard Antony
    Chestnut Farm
    Cross Lane, Kermincham
    CW12 2LJ Congleton
    Cheshire
    Administrateur
    Chestnut Farm
    Cross Lane, Kermincham
    CW12 2LJ Congleton
    Cheshire
    EnglandBritish327792630001
    WHITING, Richard Antony
    Chestnut Farm
    Cross Lane, Kermincham
    CW12 2LJ Congleton
    Cheshire
    Administrateur
    Chestnut Farm
    Cross Lane, Kermincham
    CW12 2LJ Congleton
    Cheshire
    EnglandBritish327792630001

    STENTION LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 02 oct. 2008
    Livré le 09 oct. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 01 oct. 2008
    Livré le 04 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a victoria garden centre wakefield road streethouse PO9NTEFACT west yorkshire t/no WYK445421, WYK72899, WYK781899 and WYK781290.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 02 nov. 2004
    Livré le 05 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £3,085,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H land on the south side of wakefield road, snydale, pontefract k/a victoria garden centre t/no WYK445421 and f/h land on the south side of wakefield road, snydale, pontefract t/no WYK72899.
    Personnes ayant droit
    • Niel Graham Hirst and Lillian Hirst
    Transactions
    • 05 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 nov. 2004
    Livré le 03 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    T/Nos WYK72899 & WYK445421. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 01 mai 2008
    • 01 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 sept. 2002
    Livré le 26 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 juin 1997
    Livré le 02 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 02 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 05 juin 1990
    Livré le 11 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over the book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 11 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 21 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0