RURALSPAR LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRURALSPAR LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01868983
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RURALSPAR LIMITED ?

    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe RURALSPAR LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Honeypot House
    56a Crewys Road
    NW2 2AD London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de RURALSPAR LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 nov. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour RURALSPAR LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 sept. 2012

    État du capital au 24 sept. 2012

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Période comptable précédente raccourcie du 30 nov. 2011 au 29 nov. 2011

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2010

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Sidney Stanley Stimler le 01 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2009

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    6 pages363s

    legacy

    6 pages363s

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2006

    4 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2005

    4 pagesAA

    legacy

    6 pages363s

    legacy

    pages363(287)

    legacy

    6 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    legacy

    pages363(287)

    legacy

    1 pages288a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2004

    4 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2003

    4 pagesAA

    legacy

    6 pages363s

    Qui sont les dirigeants de RURALSPAR LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    STIMLER, Maurice
    41 Princess Park Avenue
    NW11 0JR London
    Secrétaire
    41 Princess Park Avenue
    NW11 0JR London
    BritishDirector100226330001
    STIMLER, Sidney Stanley
    Honeypot House
    56a Crewys Road
    NW2 2AD London
    Administrateur
    Honeypot House
    56a Crewys Road
    NW2 2AD London
    EnglandBritishCo Director5491640001
    BRACEINER, Abraham Jacob
    5 Park Way
    NW11 0EX London
    Secrétaire
    5 Park Way
    NW11 0EX London
    British35628530001
    LITTLE, Ann Pauline
    10 The Meadow
    BR7 6AA Chislehurst
    Kent
    Secrétaire
    10 The Meadow
    BR7 6AA Chislehurst
    Kent
    British44144660001
    STIMLER, Miriam
    97 The Ridgeway
    NW11 9RX London
    Administrateur
    97 The Ridgeway
    NW11 9RX London
    United KingdomBritishCo Director5491630001

    RURALSPAR LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of assignment of rents
    Créé le 06 oct. 2000
    Livré le 10 oct. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The benefit of all rents licence or tenancy fees payable over the property known as 27-31 the parade oadby leicestershire.
    Personnes ayant droit
    • Newcastle Building Society
    Transactions
    • 10 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage deed
    Créé le 06 oct. 2000
    Livré le 10 oct. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    27-31 the parade,oadby,leicestershire; t/no LT212478; all buildings fixtures fittings and fixed plant and machinery thereon.
    Personnes ayant droit
    • Newcastle Building Society
    Transactions
    • 10 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of floating charge
    Créé le 06 oct. 2000
    Livré le 10 oct. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Newcastle Building Society
    Transactions
    • 10 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture deed
    Créé le 14 déc. 1994
    Livré le 16 déc. 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bristol and West Building Society
    Transactions
    • 16 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage deed
    Créé le 14 déc. 1994
    Livré le 16 déc. 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Units 27/31 the parade oadby leicester & units 1/6 cavendish buildings barton street gloucester tog with all buildings structures and fixtures (inc trade) fixed plant and machinery and the goodwill of the business and a floating charge all other undertaking and assets of the company. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bristol and West Building Society
    Transactions
    • 16 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 25 janv. 1991
    Livré le 07 févr. 1991
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a 1-6 cavendeish building barton street gloucester title no gr 4845 tog with all buildings & fixtures and the proceeds of sale please see doc M48 for details.
    Personnes ayant droit
    • Skandia Financial Services Limited
    Transactions
    • 07 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 25 janv. 1991
    Livré le 07 févr. 1991
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Skandia Financial Services Limited
    Transactions
    • 07 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 25 janv. 1991
    Livré le 07 févr. 1991
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 27-31 the parade oadby leicester title no lt 212478 tog with all buildings & fixtures and the proceeds of sale please see doc M45 for details.
    Personnes ayant droit
    • Skandia Financial Services Limited
    Transactions
    • 07 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 13 juil. 1988
    Livré le 14 juil. 1988
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H lands & premises being 27-31 (odd nos) the parade oadly leicester.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 10 févr. 1986
    Livré le 12 févr. 1986
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H flats 1 & 1A (ground floor) 2 (first floor) and 3 (second floor) at 76 westbourne terrace, bayswater, london W2.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 12 févr. 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 01 mars 1985
    Livré le 05 mars 1985
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a 1/6 cavendish buildings barton st, gloucester.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 05 mars 1985Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0