GREGORY PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGREGORY PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01869885
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GREGORY PROPERTIES LIMITED ?

    • Activités combinées de services administratifs de bureau (82110) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe GREGORY PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Dlp House
    46 Prescott Street
    HX1 2QW Halifax
    West Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GREGORY PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WATERCROSS LIMITED07 déc. 198407 déc. 1984

    Quels sont les derniers comptes de GREGORY PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour GREGORY PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    11 pagesLIQ14

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    5 pagesNDISC

    Changement d'adresse du siège social de 12 Cardale Court Cardale Park Beckwith Head Road Harrogate HG3 1RY England à Dlp House 46 Prescott Street Halifax West Yorkshire HX1 2QW le 15 juin 2018

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 21 mai 2018

    LRESEX

    Déclaration des affaires

    8 pagesLIQ02

    Changement d'adresse du siège social de 2 the Embankment Sovereign Street Leeds West Yorkshire LS1 4GP à 12 Cardale Court Cardale Park Beckwith Head Road Harrogate HG3 1RY le 03 avr. 2018

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 22 févr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2017

    13 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2016

    16 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2016

    12 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 31 janv. 2017 au 30 juin 2016

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 mars 2016

    État du capital au 15 mars 2016

    • Capital: GBP 60,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2015

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 févr. 2015

    État du capital au 23 févr. 2015

    • Capital: GBP 60,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2014

    14 pagesAA

    Satisfaction de la charge 39 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 févr. 2014

    État du capital au 24 févr. 2014

    • Capital: GBP 60,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2013

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    17 pagesAA

    Période comptable précédente prolongée du 29 déc. 2012 au 31 janv. 2013

    1 pagesAA01

    Période comptable précédente raccourcie du 30 déc. 2011 au 29 déc. 2011

    1 pagesAA01

    Qui sont les dirigeants de GREGORY PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROBERTSON, Marjorie
    78 Blackmoor Lane
    Bardsey
    LS17 9DY Leeds
    Secrétaire
    78 Blackmoor Lane
    Bardsey
    LS17 9DY Leeds
    British72111170002
    GREGORY, George Barry
    The Cottage Stainburn Lane
    Leathley
    LS21 2LF Otley
    North Yorkshire
    Administrateur
    The Cottage Stainburn Lane
    Leathley
    LS21 2LF Otley
    North Yorkshire
    United KingdomBritish29331210001
    GURNEY, Trevor Robert
    Churchgate
    Bramhope
    LS16 9BN Leeds
    15
    West Yorkshire
    Administrateur
    Churchgate
    Bramhope
    LS16 9BN Leeds
    15
    West Yorkshire
    United KingdomBritish5339510003
    FISHER, Eric Desmond
    Sunleigh Walton Avenue
    Pannal
    HG3 1EX Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Sunleigh Walton Avenue
    Pannal
    HG3 1EX Harrogate
    North Yorkshire
    British25299950001
    ILLINGWORTH, John Robert
    7 Woodthorpe Park Drive
    Sandal
    WF2 6HY Wakefield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    7 Woodthorpe Park Drive
    Sandal
    WF2 6HY Wakefield
    West Yorkshire
    British51409510001
    BRAMALL, Douglas Charles Antony
    Warren Farm Warren Lane
    Brearton
    HG3 3DB Harrogate
    Administrateur
    Warren Farm Warren Lane
    Brearton
    HG3 3DB Harrogate
    United KingdomBritish29331220001
    WILKINSON, Peter John Byrne
    2 Haworth Grove
    Heaton
    BD9 5PE Bradford
    West Yorkshire
    Administrateur
    2 Haworth Grove
    Heaton
    BD9 5PE Bradford
    West Yorkshire
    British9269380001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GREGORY PROPERTIES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Sovereign Street
    LS1 4GP Leeds
    2 The Embankment
    England
    06 avr. 2016
    Sovereign Street
    LS1 4GP Leeds
    2 The Embankment
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementUnited Kingdom
    Numéro d'enregistrement4184646
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    GREGORY PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 16 mai 2007
    Livré le 23 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 23 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 août 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 05 mars 1998
    Livré le 10 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property known as land at dark lane, birstall, kirklees, west yorkshire title number wyk 436573.
    Personnes ayant droit
    • The British Linen Bank Limited
    Transactions
    • 10 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 févr. 1998
    Livré le 18 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fountain mills, hyndburn road, accrington, lancashire title number LA740727.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 déc. 1997
    Livré le 09 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Kidd house and land at sandbeck way wetherby west yorkshire t/n's wyk 456771,WYK378196.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge and assignment
    Créé le 23 déc. 1996
    Livré le 02 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of charge all the agreement details of which are set out in the schedule hereto and the benefit of the same and all the premises comprised therein and the company's estate and interest in every conveyance transfer or lease which may by granted to the company pursuant to the agreement by way of assignment all moneys due or owing or from time to time becoming due or owing to the company under or by virtue of the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 déc. 1996
    Livré le 02 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land in beckwith heath rd,harrogate,known as cardale court,harrogate,north yorkshire; nyk 167226.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 févr. 1996
    Livré le 05 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that piece of f/h property at dick lane pudsey bradford. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Guernsey Investments Limited
    Transactions
    • 05 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 12 sept. 1995
    Livré le 15 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and every interest in or over the f/h land and building at barton dock road trafford park manchester and/or the proceeds of sale thereof.
    Personnes ayant droit
    • Douglas Charles Anthony Bramall
    Transactions
    • 15 sept. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 janv. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge and assignment
    Créé le 17 sept. 1993
    Livré le 23 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to all those persons (as defined) trading as drypool investments pursuant to the finance documents
    Brèves mentions
    All right title and interest in a building agreement and a building contract guarantee and all its entitlements to the receipt of all moneys payable to it or receivables.
    Personnes ayant droit
    • All Those Persons (As Defined) Trading as Drypool Investments
    Transactions
    • 23 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge and assignment
    Créé le 17 sept. 1993
    Livré le 23 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to all those persons (as defined) trading as drypool investments pursuant to the finance documents
    Brèves mentions
    All right title and interest arising out of a performance bond and all its entitlements to the receipt of all moneys payable to it or receivable.
    Personnes ayant droit
    • Those Persons (As Defined) Trading as Drypool Investments
    Transactions
    • 23 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment and charge
    Créé le 17 sept. 1993
    Livré le 23 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to all those persons (as defined) trading as drypool investments pursuant to the finance documents
    Brèves mentions
    Fixed charge which constitute the balance standing to the credit of a sterling deposit account number 40425737 with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Those Persons (As Defined) Trading as Drypool Investments
    Transactions
    • 23 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 mai 1993
    Livré le 25 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    5 and 7 east parade harrowgate north yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 mai 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over building contract
    Créé le 10 août 1992
    Livré le 14 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the finance documents (as defined in the charge)
    Brèves mentions
    Building contract relating to the development dated 29/5/92 (for full details refer to form M395 & continuation sheets ref M78C).
    Personnes ayant droit
    • Guernsey Investments Limited
    Transactions
    • 14 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 10 août 1992
    Livré le 12 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    An agreement relating to an office development at blenheim walk leeds and all moneys due or owing to the chargor please see doc M342C for details.
    Personnes ayant droit
    • Guernsey Investments Limited
    Transactions
    • 12 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge & assignment
    Créé le 18 mars 1992
    Livré le 20 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    An agreement dated 28/3/91 between leeds city development company limited & the mortgagor relating to land at isle mills holbecklane leeds & estate & interest & all monies.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 juin 1991
    Livré le 18 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at beckwith head road, harrogate north yorkshire. Title no. Nyk 82292.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 14 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 août 1990
    Livré le 22 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a harlow court farm pannal harrogate north yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 18 nov. 1998Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 27 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 août 1990
    Livré le 17 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a legal charge dated 9/8/90
    Brèves mentions
    F/L on the east side of beckwith head road, harrogate, north yorkshire with all benefit & interest thereof.
    Personnes ayant droit
    • Chartered Trust PLC
    Transactions
    • 17 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 21 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chage by way of legal mortgage
    Créé le 09 août 1990
    Livré le 17 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/L on the east side of beckwith head road harrogate north yorkshire with all fixtures other than trade machinery.
    Personnes ayant droit
    • Chartered Trust PLC
    Transactions
    • 17 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 juin 1990
    Livré le 08 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    An agreement relating to development & sale of an office building at belgrave street & merrion place leeds west yorkshire, by way of:-. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transactions
    • 08 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 mai 1990
    Livré le 14 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a harlow court pannal harrogate north yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 11 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 janv. 1990
    Livré le 27 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    An agreement relating to the property dated 14/12/89 made between leeds city development company limited and the company the whole of land off belgrave street and merrion place, leeds (more particularly described in the agreement) : together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transactions
    • 27 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge over building agreement
    Créé le 10 janv. 1990
    Livré le 12 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge dated 13/10/89
    Brèves mentions
    A building agreement dated 16TH october 89 made between the company and gmi construction group PLC relating to the carrying out of construction works on all that f/h property k/a land at kingwell gate, wakefield, west yorkshire, title no. Wyk 264152.
    Personnes ayant droit
    • Chartered Trust PLC
    Transactions
    • 12 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 07 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 13 oct. 1989
    Livré le 17 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a land at lingwell gate & carr gate wakefield west yorkshire title no wyk 264152.
    Personnes ayant droit
    • Chartered Trust Public Limited Company
    Transactions
    • 17 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    • 29 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A registered charge
    Créé le 21 déc. 1988
    Livré le 23 déc. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Charge of agreement for lease relating to land at york road deighton road wetherby.
    Personnes ayant droit
    • N.M. Rothschild & Sons LTD
    Transactions
    • 23 déc. 1988Enregistrement d'une charge
    • 06 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    GREGORY PROPERTIES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    21 mai 2018Commencement of winding up
    06 juil. 2019Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sarah Long
    Dl Partnership (Uk) Limited Dlp House
    46 Prescott Street
    HX1 2QW Halifax
    practitioner
    Dl Partnership (Uk) Limited Dlp House
    46 Prescott Street
    HX1 2QW Halifax
    Antony Denham
    Dl Partnership (Uk) Limited Dlp House
    46 Prescott Street
    HX1 2QW Halifax
    practitioner
    Dl Partnership (Uk) Limited Dlp House
    46 Prescott Street
    HX1 2QW Halifax

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0