CENTRAL WEIGHING LTD
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CENTRAL WEIGHING LTD |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01869891 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CENTRAL WEIGHING LTD ?
| Adresse du siège social | Unit 142 Hartlebury Trading Estate, Hartlebury DY10 4JB Kidderminster Worcestershire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CENTRAL WEIGHING LTD ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour CENTRAL WEIGHING LTD ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 02 juil. 2013
| 4 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Ola Tricia Aramita Barreto-Morley en tant que directeur le 31 mars 2013 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré | 1 pages | AD03 | ||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée | 1 pages | AD02 | ||||||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 30 juin 2012 au 31 déc. 2012 | 1 pages | AA01 | ||||||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||||||
Divers Section 519 | 1 pages | MISC | ||||||||||||||
Rachat d'actions propres. | 4 pages | SH03 | ||||||||||||||
Nomination de S & J Registrars Limited en tant que secrétaire le 28 mai 2012 | 2 pages | AP04 | ||||||||||||||
Nomination de Ola Tricia Aramita Barreto-Morley en tant qu'administrateur le 28 mai 2012 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Giles Matthew Hudson en tant qu'administrateur le 28 mai 2012 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Edward Ufland en tant qu'administrateur le 28 mai 2012 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Pauline Vera Stokes en tant que directeur le 28 mai 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Richard William Stokes en tant que directeur le 28 mai 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Philip Matthew Deakin en tant qu'administrateur le 28 mai 2012 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Ian Ball en tant que secrétaire le 28 mai 2012 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Rachat d'actions propres. | 3 pages | SH03 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de CENTRAL WEIGHING LTD ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S & J REGISTRARS LIMITED | Secrétaire | Gresham Street Fifth Floor EC2V 7NG London 99 United Kingdom |
| 43122090005 | ||||||||||
| DEAKIN, Philip Matthew | Administrateur | Unit 142 Hartlebury Trading Estate, Hartlebury DY10 4JB Kidderminster Worcestershire | United Kingdom | British | 146225080002 | |||||||||
| HUDSON, Giles Matthew | Administrateur | Unit 142 Hartlebury Trading Estate, Hartlebury DY10 4JB Kidderminster Worcestershire | United Kingdom | British | 161583790003 | |||||||||
| UFLAND, Edward | Administrateur | Unit 142 Hartlebury Trading Estate, Hartlebury DY10 4JB Kidderminster Worcestershire | United Kingdom | British | 87558180001 | |||||||||
| BALL, Ian | Secrétaire | 9 Oakdale Close Pensnett DY5 4PY Brierley Hill West Midlands | British | 121775640001 | ||||||||||
| JACKSON, Peter Stephen | Secrétaire | The Corner House 16 Newtown SG4 8UQ Codicote Hertfordshire | British | 4425080001 | ||||||||||
| LANGFORD, Philip James Deverell, Mr. | Secrétaire | Highfield 90 Harmer Green Lane AL6 0EP Welwyn Hertfordshire | British | 34943510001 | ||||||||||
| GD SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | Goodman Derrick 6th Floor 90 Fetter Lane EC4A 1PT London | 66216820001 | |||||||||||
| BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita | Administrateur | Unit 142 Hartlebury Trading Estate, Hartlebury DY10 4JB Kidderminster Worcestershire | England | British,Portuguese | 140644240001 | |||||||||
| JACKSON, Peter Stephen | Administrateur | The Corner House 16 Newtown SG4 8UQ Codicote Hertfordshire | United Kingdom | British | 4425080001 | |||||||||
| STOKES, Pauline Vera | Administrateur | Yew Tree Cottage Torton Lane Torton DY10 4HX Kidderminster Worcestershire | United Kingdom | British | 126405790001 | |||||||||
| STOKES, Richard William | Administrateur | Yew Tree Cottage Torton Lane, Torton DY104HX Kidderminster Worcestershire | England | British | 22813550003 |
CENTRAL WEIGHING LTD a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 24 août 2007 Livré le 30 août 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 04 mai 1990 Livré le 17 mai 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 21 mars 1986 Livré le 09 avr. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti £30,000 | |
Brèves mentions All the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 25 avr. 1985 Livré le 02 mai 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0