123 LEEDS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la société123 LEEDS LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01873281
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de 123 LEEDS LIMITED ?

    • Pharmacie en officine (47730) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe 123 LEEDS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Bdo Llp 1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de 123 LEEDS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OPTICAL EXPRESS (SOUTHERN) LIMITED23 mai 199723 mai 1997
    SPECIALEYES PLC26 sept. 198826 sept. 1988
    SPECIALEYES PUBLIC LIMITED COMPANY31 janv. 198531 janv. 1985
    TUDORTIME PUBLIC LIMITED COMPANY19 déc. 198419 déc. 1984

    Quels sont les derniers comptes de 123 LEEDS LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 déc. 2011
    Date d'échéance des prochains comptes19 déc. 2012
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au01 janv. 2011

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour 123 LEEDS LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au27 nov. 2016
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation11 déc. 2016
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour 123 LEEDS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour 123 LEEDS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Restauration par ordonnance du tribunal

    2 pagesAC92

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Graeme Ramsay Murdoch le 10 déc. 2015

    1 pagesCH03

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 18 sept. 2015

    12 pages2.35B

    Avis de vacance de poste par l'administrateur

    11 pages2.39B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 07 févr. 2014

    12 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 07 févr. 2014

    11 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 07 févr. 2014

    11 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 16 août 2013

    12 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Changement d'adresse du siège social de Pkf (Uk) Llp 10 South Parade Leeds LS1 5QS le 08 juil. 2013

    2 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur June Stewart le 17 juin 2013

    2 pagesCH01

    Avis d'approbation réputée des propositions

    2 pagesF2.18

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    8 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    42 pages2.17B

    Changement d'adresse du siège social de White Rose House 28a York Place Leeds West Yorkshire LS1 2EZ le 10 oct. 2012

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Certificat de changement de nom

    Company name changed optical express (southern) LIMITED\certificate issued on 26/09/12
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name26 sept. 2012

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2011 au 30 déc. 2011

    3 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 déc. 2011

    État du capital au 20 déc. 2011

    • Capital: GBP 642,704.9
    SH01

    Comptes annuels établis au 01 janv. 2011

    18 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de 123 LEEDS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MURDOCH, Graeme Ramsay
    Deerdykes Road
    Cumbernauld
    G68 9HF Glasgow
    5
    United Kingdom
    Secrétaire
    Deerdykes Road
    Cumbernauld
    G68 9HF Glasgow
    5
    United Kingdom
    British38792570005
    MEIN, Stewart
    5 Wallace Wynd Laurel Grove
    Cambuslang
    G72 8SE Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    5 Wallace Wynd Laurel Grove
    Cambuslang
    G72 8SE Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish111822400001
    MOULSDALE, David Charles
    5 Deerdykes Road
    Cumbernauld
    G68 9HF Glasgow
    Administrateur
    5 Deerdykes Road
    Cumbernauld
    G68 9HF Glasgow
    United KingdomBritish69808430006
    MOULSDALE, June
    3 Munro Drive
    G66 8HA Milton Of Campsie
    Administrateur
    3 Munro Drive
    G66 8HA Milton Of Campsie
    United KingdomBritish86663970002
    COTEMAN, Jeffrey Graham
    167 Imperial Drive
    HA2 7JP Harrow
    Middlesex
    Secrétaire
    167 Imperial Drive
    HA2 7JP Harrow
    Middlesex
    British21355220001
    PRICE, Roger Charles
    36 Wattleton Road
    HP9 1SE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    36 Wattleton Road
    HP9 1SE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British15909920001
    SHAND, George William
    22 Ormond Crescent
    TW12 2TH Hampton
    Middlesex
    Secrétaire
    22 Ormond Crescent
    TW12 2TH Hampton
    Middlesex
    British32434350001
    BINNIE, Stewart John
    36 Glebe Road
    Barnes
    SW13 0EA London
    Administrateur
    36 Glebe Road
    Barnes
    SW13 0EA London
    EnglandBritish131771340001
    COMPTON, Spencer Douglas David, The Most Honourable The Marquess Of Northampton
    Compton Wynyates Tysoe
    CV35 0UD Warwick
    Administrateur
    Compton Wynyates Tysoe
    CV35 0UD Warwick
    EnglandBritish61164800001
    COTEMAN, Jeffrey Graham
    Sharrow-Whit Denham Walk
    SL9 0EN Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Sharrow-Whit Denham Walk
    SL9 0EN Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British49689340001
    DAW, Andrew
    7 High Street
    OX18 2JN Bampton
    Oxfordshire
    Administrateur
    7 High Street
    OX18 2JN Bampton
    Oxfordshire
    British52475500001
    FRANEY, Timothy
    32 Herne Hill
    SE24 9QS London
    Administrateur
    32 Herne Hill
    SE24 9QS London
    EnglandBritish2570000001
    GARDNER, Rennie
    Flat 1 3 Victoria Road
    Lenzie Kirkintilloch
    G66 5AW Glasgow
    Administrateur
    Flat 1 3 Victoria Road
    Lenzie Kirkintilloch
    G66 5AW Glasgow
    British66031300001
    GOLDSTONE, Michael
    Ladywood 6 High Coombe Place
    Warren Cuttings
    KT2 7HH Kingston
    Surrey
    Administrateur
    Ladywood 6 High Coombe Place
    Warren Cuttings
    KT2 7HH Kingston
    Surrey
    British2631970001
    GRAHAM, Robert Lancelot
    9 Southvale Road
    Blackheath Village
    SE3 0TP London
    Administrateur
    9 Southvale Road
    Blackheath Village
    SE3 0TP London
    British36089270003
    KEOUGH, Stephen
    La Neuve Maison
    Frie Au Four
    CHANNEL St Saviour
    Guernsey
    Administrateur
    La Neuve Maison
    Frie Au Four
    CHANNEL St Saviour
    Guernsey
    British49363430002
    MOULSDALE, Gordon
    14 Cree Avenue
    Bishopbriggs
    G64 1XG Glasgow
    Administrateur
    14 Cree Avenue
    Bishopbriggs
    G64 1XG Glasgow
    British51904040001
    MURDOCH, Graeme Ramsay
    52 Turners Avenue
    Maxwellton Gate
    PA1 2NZ Paisley
    Renfrewshire
    Administrateur
    52 Turners Avenue
    Maxwellton Gate
    PA1 2NZ Paisley
    Renfrewshire
    British38792570002
    NOBLE, Andrew Stephen
    62 Woodside
    Wimbledon
    SW19 7AF London
    Administrateur
    62 Woodside
    Wimbledon
    SW19 7AF London
    British13614150001
    POWER, James Francis
    Flat 3
    18 Norham Gardens
    OX2 9QB
    Oxfordshire
    Administrateur
    Flat 3
    18 Norham Gardens
    OX2 9QB
    Oxfordshire
    British4251540001
    PRICE, Roger Charles
    36 Wattleton Road
    HP9 1SE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    36 Wattleton Road
    HP9 1SE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish15909920001
    RAINES, Mark
    Cubbins Farm
    Longworth Lane
    BL7 9QY Bolton
    Administrateur
    Cubbins Farm
    Longworth Lane
    BL7 9QY Bolton
    United KingdomBritish107787640001
    RITCHIE, Ian
    The Molins
    Rickling Green
    CB11 3YG Saffron Waldon
    Essex
    Administrateur
    The Molins
    Rickling Green
    CB11 3YG Saffron Waldon
    Essex
    British95676240001
    ROBERTSHAW, John
    3 Birches Farm
    Isfield
    TN22 Uckfield
    Sussex
    Administrateur
    3 Birches Farm
    Isfield
    TN22 Uckfield
    Sussex
    British15481610001
    SHAND, George William
    22 Ormond Crescent
    TW12 2TH Hampton
    Middlesex
    Administrateur
    22 Ormond Crescent
    TW12 2TH Hampton
    Middlesex
    EnglandBritish32434350001
    SMITH, Brian David
    Crueen 5 Hale Road
    Wendover
    HP22 6NE Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Crueen 5 Hale Road
    Wendover
    HP22 6NE Aylesbury
    Buckinghamshire
    British31344390001

    123 LEEDS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 12 juin 2009
    Livré le 26 juin 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargor's to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 juin 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 04 mai 2007
    Livré le 18 mai 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 18 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 04 juil. 2002
    Livré le 11 juil. 2002
    En cours
    Montant garanti
    The sum of £1,550.00 and interest thereon due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All money in the rent deposit account and all money from time to time withdrawn therefrom.
    Personnes ayant droit
    • Exclusive Investments Limited
    Transactions
    • 11 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 28 mai 2002
    Livré le 31 mai 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The deposit account and all money from time to time withdrawn from the deposit account in accordance with the rent deposit deed.
    Personnes ayant droit
    • Langham Properties Limited
    Transactions
    • 31 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 31 oct. 2000
    Livré le 10 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 févr. 1998
    Livré le 03 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 03 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of covenant and deposit
    Créé le 11 déc. 1995
    Livré le 22 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a deed of covenant of even date
    Brèves mentions
    The interest in the deposit account within clause 1 of the deed of covenant. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Standard Life Assurance Company
    Transactions
    • 22 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 31 août 1995
    Livré le 07 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A fixed charge over all the "deposit(s)" referred to in the schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 sept. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 29 juin 1994
    Livré le 07 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to ravenseft properties limited pursuant to the performance of the lease.
    Brèves mentions
    Rent deposit of £11,250 paid under the deed dated 29TH june 1994 between the company and ravenseft properties limited and all other sums from time to time paid and any additional sums paid into the account pursuant to the terms of the deed,.
    Personnes ayant droit
    • Ravenseft Properties Limited.
    Transactions
    • 07 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 juin 1994
    Livré le 05 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    23 kings walk gloucester gloucestershire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 nov. 1993
    Livré le 08 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 87, 26 crown walk milton keynes bucks t/no.BM162205.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 nov. 1993
    Livré le 03 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    18 and 20 merseyway stockport greater manchester.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 déc. 1991
    Livré le 03 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    20 broadwalk, harlow, essex. T/no.EX440779.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 déc. 1991
    Livré le 16 déc. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    17 spurriergate and 1 high ousegate york north yorkshire (part of 1/7 spurriergate and 1-3 high ousegate) as comprised in an assignment dated 10.4.91.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 juil. 1991
    Livré le 25 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Ground mezzanine and first floor premises with shop--1 swan walk,romford,london borough of havering.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 10 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 juin 1991
    Livré le 15 juin 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £22,000 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    7 weston rd brighton east sussex.
    Personnes ayant droit
    • Buzz-Bovs Limited
    Transactions
    • 15 juin 1991Enregistrement d'une charge
    • 26 nov. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 mai 1991
    Livré le 30 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    7, western road, brighton, east sussex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 10 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 mai 1991
    Livré le 14 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    37/38 baxtergate doncaster, south yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 10 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 févr. 1991
    Livré le 14 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 12B meadowhill shopping centre, sheffield.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 10 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 févr. 1991
    Livré le 14 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Second floor 167 imperial drive harrow l/b of harrow.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 10 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 sept. 1990
    Livré le 10 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    364 dukes walk maidstone, kent.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 mai 1990
    Livré le 14 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    24 baxtergate, doncaster, south yorkshire title no syk 250704.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 mai 1990
    Livré le 11 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    4 & 8 st peter's way, derby, derbyshire title no dy 75422.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 mars 1990
    Livré le 03 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 68, merry hill centre, dudley, west midlands.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 mars 1990
    Livré le 03 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    7 trinity parade high street hounslow l/b of hounslow.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    123 LEEDS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    02 oct. 2012Administration started
    18 sept. 2015Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian Christopher Schofield
    10 South Parade
    LS1 5QS Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    10 South Parade
    LS1 5QS Leeds
    West Yorkshire
    Anne Buchanan
    Pkf
    78 Carlton Place
    G5 9TH Glasgow
    practitioner
    Pkf
    78 Carlton Place
    G5 9TH Glasgow
    Bryan Jackson
    Pkf (Uk) Llp
    78 Carlton Place
    G5 9TH Glasgow
    practitioner
    Pkf (Uk) Llp
    78 Carlton Place
    G5 9TH Glasgow

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0