ABBEYCREST (READING) LIMITED

ABBEYCREST (READING) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéABBEYCREST (READING) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01882974
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ABBEYCREST (READING) LIMITED ?

    • Établissements de soins infirmiers en résidence (87100) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe ABBEYCREST (READING) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Asticus Building 2nd Floor
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ABBEYCREST (READING) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour ABBEYCREST (READING) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 janv. 2016

    État du capital au 27 janv. 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Sanne Group Secretaries (Uk) Limited le 20 juil. 2015

    1 pagesCH04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    2 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de C/O Sanne Group 2nd Floor Pollen House 10 Cork Street London W1S 3NP à Asticus Building 2nd Floor 21 Palmer Street London SW1H 0AD le 05 août 2015

    1 pagesAD01

    Nomination de Jonathan David Farkas en tant qu'administrateur le 27 janv. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mathieu Streiff en tant que directeur le 27 janv. 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 janv. 2015

    État du capital au 26 janv. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mathieu Streiff le 31 mars 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Sanne Group Secretaries (Uk) Limited le 31 mars 2014

    1 pagesCH04

    legacy

    28 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT1

    legacy

    3 pagesGUARANTEE1

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Sanne Group 1 Berkeley Street London United Kingdom W1J 8DJ* le 07 avr. 2014

    1 pagesAD01

    Démission d'un auditeur

    2 pagesAA03

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 janv. 2014

    État du capital au 24 janv. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2014 au 31 déc. 2013

    3 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    17 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ABBEYCREST (READING) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    21
    England
    Secrétaire
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    21
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement8334728
    175738460001
    FARKAS, Jonathan David
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    Administrateur
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    LuxembourgAmericanManaging Director193539990001
    JENNINGS, Eric Stanley
    4 Mill Green
    Caversham
    RG4 8EX Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    4 Mill Green
    Caversham
    RG4 8EX Reading
    Berkshire
    British6847820005
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Secrétaire
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    British52338530002
    CORMACK, Derek George
    Pillars
    Grantley Avenue, Wonersh
    GU5 0QN Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Pillars
    Grantley Avenue, Wonersh
    GU5 0QN Guildford
    Surrey
    EnglandIrishAccountant67400530015
    GRIFFIN, Craig
    Melvin
    Halebourne Lane, Chobham
    GU24 8SL Woking
    Surrey
    Administrateur
    Melvin
    Halebourne Lane, Chobham
    GU24 8SL Woking
    Surrey
    BritishDirector122298210001
    HILL, Peter Martin
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Administrateur
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritishAccountant130983750001
    JEFFERY, Paul Anthony Keith
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Administrateur
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritishAccountant65609290003
    JENNINGS, Eric Stanley
    4 Mill Green
    Caversham
    RG4 8EX Reading
    Berkshire
    Administrateur
    4 Mill Green
    Caversham
    RG4 8EX Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCo Director6847820005
    JENNINGS, Frances Anne
    4 Mill Green
    Caversham
    RG4 8EX Reading
    Berkshire
    Administrateur
    4 Mill Green
    Caversham
    RG4 8EX Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director6847810005
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Administrateur
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritishSolicitor148139420001
    STREIFF, Mathieu Bernard
    c/o Sanne Group
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    2nd Floor Pollen House
    Administrateur
    c/o Sanne Group
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    2nd Floor Pollen House
    United StatesAmericanAttorney200529310001
    WHITE, Ian James
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Administrateur
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritishAccountant133383410003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ABBEYCREST (READING) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building, 2nd Floor
    England
    06 avr. 2016
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building, 2nd Floor
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement04258255
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    ABBEYCREST (READING) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 28 juil. 2010
    Livré le 06 août 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 06 août 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 16 nov. 2007
    Livré le 27 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Ascot house 28 wingrove road fenham,34 and 36 wingrove road newcastle upon tynet/no's TY221509 and TY52154,bradbury house bradbury house new street braintree t/no ESX647090, cheshire house 22 st mary's road ashton on mersey t/no GM54543 (for details of further properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 28 juin 2007
    Livré le 29 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a abbeycrest nursing home, essex way, kennylands road, sonning common, reading t/n ON91174. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 31 mai 2007
    Livré le 05 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee)
    Transactions
    • 05 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 21 févr. 1994
    Livré le 08 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a abbeycrest nursing home essex way kennylands road sonning common berkshire t/no ON91174 & the proceeds of sale with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 01 oct. 1992
    Livré le 09 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 23 juin 1988
    Livré le 28 juin 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from mogadons limited on any account whatsoever to the chargee
    Brèves mentions
    L/H property k/a abbeycrest nursing home, kennylands road, sonning common, reading and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 juin 1988Enregistrement d'une charge
    • 07 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 avr. 1988
    Livré le 16 mai 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £325,000 on any account whatsoever under the terms of the charge
    Brèves mentions
    L/H land k/a abbey crest kennylands road, sonning common, county of berkshire the goodwill of the business & benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • Mercantile Credit Company Limited
    Transactions
    • 16 mai 1988Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0