SLG REALISATIONS PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSLG REALISATIONS PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 01890236
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SLG REALISATIONS PLC ?

    • (7240) /

    Où se situe SLG REALISATIONS PLC ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    London
    SE1 2AF
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SLG REALISATIONS PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SMARTLOGIK GROUP PLC06 juil. 200106 juil. 2001
    BRIGHT STATION PLC05 mai 200005 mai 2000
    M.A.I.D. PLC10 févr. 199410 févr. 1994
    M.A.I.D. SYSTEMS LIMITED27 mars 198527 mars 1985
    MAPOLA LIMITED27 févr. 198527 févr. 1985

    Quels sont les derniers comptes de SLG REALISATIONS PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au

    Quels sont les derniers dépôts pour SLG REALISATIONS PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 avr. 2012

    6 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    3 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 nov. 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 mai 2011

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 nov. 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 mai 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 nov. 2009

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 mai 2009

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 nov. 2008

    7 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 nov. 2008

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Divers

    S/S cert.:-release of liquidator
    1 pagesMISC

    Divers

    C/O replacement of liquidator
    37 pagesMISC

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    legacy

    1 pages287

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    6 pages4.68

    Qui sont les dirigeants de SLG REALISATIONS PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BAIR, James Henry
    31001 Palomares Road
    Castro Valley
    California
    94552
    Usa
    Administrateur
    31001 Palomares Road
    Castro Valley
    California
    94552
    Usa
    American75209650001
    CANHAM, Simon Anthony Charles
    168 Westwood Road
    Tilehurst
    RG31 6LN Reading
    Berkshire
    Administrateur
    168 Westwood Road
    Tilehurst
    RG31 6LN Reading
    Berkshire
    EnglandBritish72748180002
    HILL, Stephen James
    Monks Well House
    Monks Well
    GU10 1RH Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Monks Well House
    Monks Well
    GU10 1RH Farnham
    Surrey
    British68448760002
    JEFFERIES, David George
    Espada 30 Abbots Drive
    GU25 4SE Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    Espada 30 Abbots Drive
    GU25 4SE Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritish73661520003
    LOMNITZ, Robert Kurt
    25 Aberdare Gardens
    NW6 3AJ London
    Administrateur
    25 Aberdare Gardens
    NW6 3AJ London
    United KingdomAmerican42406160005
    BALL, Jonathan Andre Stoner
    13 Combemartin Road
    SW18 5PP London
    Secrétaire
    13 Combemartin Road
    SW18 5PP London
    British41360300003
    GIBSON, Terence Albert
    5 Lichfield Terrace
    Cranham
    RM14 3JD Upminster
    Essex
    Secrétaire
    5 Lichfield Terrace
    Cranham
    RM14 3JD Upminster
    Essex
    British82077160001
    MATTEY, David Gary
    17 Bryanston Mews West
    W1 London
    Secrétaire
    17 Bryanston Mews West
    W1 London
    British7199250001
    BARTON, Ian Joseph, Dr
    Five Farthings
    53 Moorfield Road Duxford
    CB2 4PP Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Five Farthings
    53 Moorfield Road Duxford
    CB2 4PP Cambridge
    Cambridgeshire
    British36400650002
    BURROWS, Graham
    16383 Hillow Road
    Los Gatos 95032
    FOREIGN Ca Usa
    Administrateur
    16383 Hillow Road
    Los Gatos 95032
    FOREIGN Ca Usa
    American61121760001
    GALT, Jeffery
    14991 Granite Court Saratoga 95070
    California
    FOREIGN Usa
    Administrateur
    14991 Granite Court Saratoga 95070
    California
    FOREIGN Usa
    Amercian54422140001
    HUSSEY OF NORTH BRADLEY, Marmaduke James, Lord
    Flat 15 47 Courtfield Road
    SW7 4DB London
    Administrateur
    Flat 15 47 Courtfield Road
    SW7 4DB London
    British53112500002
    LIEBMAN, Leon Herschel
    2 Neville Terrace
    SW7 3AT London
    Administrateur
    2 Neville Terrace
    SW7 3AT London
    American7399140001
    MALLER, Steve
    14 Medway Avenue
    RG23 7DP Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    14 Medway Avenue
    RG23 7DP Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritish106577990001
    MANDER, Michael Stuart
    41 Rivermill
    Grosvenor Road
    SW1V 3TN London
    Administrateur
    41 Rivermill
    Grosvenor Road
    SW1V 3TN London
    EnglandBritish118843520001
    MATTEY, David Gary
    10 Royal Avenue
    SW3 4QF London
    Administrateur
    10 Royal Avenue
    SW3 4QF London
    EnglandBritish7199250004
    MEERS, Jeffrey
    Clarence House Herons Corft
    Old Avenue
    KT13 0PL Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    Clarence House Herons Corft
    Old Avenue
    KT13 0PL Weybridge
    Surrey
    British77696390001
    MOLLE, Jason Brooks
    6225 Wakefalls Drive
    27587 Wakeforest
    North Carolina
    Usa
    Administrateur
    6225 Wakefalls Drive
    27587 Wakeforest
    North Carolina
    Usa
    British54932190001
    MORTON, Ciaran Gregory
    2 Hungerford Road
    Holloway
    N7 9LX London
    Administrateur
    2 Hungerford Road
    Holloway
    N7 9LX London
    British58520380001
    NASH, Bill
    4342 Redwood Avenue
    212 Marina Del Ray
    90929 California
    Usa
    Administrateur
    4342 Redwood Avenue
    212 Marina Del Ray
    90929 California
    Usa
    British22461030003
    NASH, Daniel
    87 Blandford Street
    W1U 8AE London
    Administrateur
    87 Blandford Street
    W1U 8AE London
    United KingdomUsa103470240001
    SHARP, Anthony Christopher John
    Flat 2 105 Oxford Street
    W1R 1TF London
    Administrateur
    Flat 2 105 Oxford Street
    W1R 1TF London
    United KingdomBritish37199800001
    SHIPLEY, Marck Alan
    337 Willow Road Menlo Park
    California 94025
    FOREIGN Usa
    Administrateur
    337 Willow Road Menlo Park
    California 94025
    FOREIGN Usa
    Usa55711240001
    SMITH, Derek Brian
    83 High Street
    BA9 9JZ Wincanton
    Somerset
    Administrateur
    83 High Street
    BA9 9JZ Wincanton
    Somerset
    British47865160001
    SOMMERS, Patrick Charles
    3117 Sheridan Road
    Evanston
    Illinois
    60202
    Usa
    Administrateur
    3117 Sheridan Road
    Evanston
    Illinois
    60202
    Usa
    American71479620001
    SWANK, Richard
    23 Sanford Town Road
    Redding
    06896
    Usa
    Administrateur
    23 Sanford Town Road
    Redding
    06896
    Usa
    American63424980002
    TEICHMAN, Thomas Alfred
    120 Pavillion Road
    SW1X 0AX London
    Administrateur
    120 Pavillion Road
    SW1X 0AX London
    EnglandBritish70634260003
    THOMAS, Allen Lloyd
    3 Chester Street
    SW1X 7BB London
    Administrateur
    3 Chester Street
    SW1X 7BB London
    American34543780002
    WAGNER, Daniel Maurice
    Flat 1
    15 Wedderburn Road
    NW3 5QS London
    Administrateur
    Flat 1
    15 Wedderburn Road
    NW3 5QS London
    United KingdomBritish15049110003
    WAGNER, John Reuben
    300 East 56 Street
    Apartment 19e New York Ny10022
    Usa
    Administrateur
    300 East 56 Street
    Apartment 19e New York Ny10022
    Usa
    British14560990001

    SLG REALISATIONS PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 12 juin 2001
    Livré le 21 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including the bridge facility letter agreement between the company and the chargee of even date
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Antfactory Investments Bv
    Transactions
    • 21 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of deposit
    Créé le 17 août 2000
    Livré le 25 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Initial deposit of £5,000,000 credited to account no.10066883 With the bank and any addition thereon.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 20 juil. 2000
    Livré le 04 août 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and lease of even date relating to the premises known as west wing, latour house, chertsey boulevard, hanworth lane, chertsey, surrey
    Brèves mentions
    A deposit of £75,600 in an interest-bearing deposit account.
    Personnes ayant droit
    • Euroinvest Estates Limited
    Transactions
    • 04 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 13 nov. 1997
    Livré le 21 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company (formerly known as M.A.I.d PLC) or any other group company as defined therein to the chargee as defined in the debenture (the "secured obligations")
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Chase Manhattan International Limited(As Security Agent for the Security Beneficiaries) (the "Security Agent")
    Transactions
    • 21 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment of keyman life policies (the "deed")
    Créé le 13 nov. 1997
    Livré le 21 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company (formerly known as M.A.I.D. PLC) 0R any group company as defined therein to the chargee as defined in the deed (the "secured obligations")
    Brèves mentions
    Full title guarantee unto the security agent the policies and all monies including bonuses.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Chase Manhattan International Limited (The "Security Agent")(as Security Agent for the Security Beneficiaries)
    Transactions
    • 21 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over accounts
    Créé le 13 nov. 1997
    Livré le 21 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to chase manhattan international limited (as security agent for the security beneficiaries), whether or not the security beneficiaries shall have been an original party to the reelevant transaction, under the terms of this charge over accounts
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all their right title and interest in the charged accounts with the repayment and satisfaction when due of all the secured obligations. Charged accounts-the royal bank of scotland PLC london belgravia branch 24 grosvenor place london SW1X 7HP, sort code-16-00-16, account nos: 1246668; 12466684;91000024; 10036801; maidsyst-USD1; maidsyst-USD12; and maidpro-USD1.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Chase Manhattan International Limited (As Security Agent for the Security Beneficiaries)
    Transactions
    • 21 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 août 1991
    Livré le 28 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 30 avr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 25 févr. 1991
    Livré le 05 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 25-2-91
    Brèves mentions
    18 dufferin street l/b islington.
    Personnes ayant droit
    • R. Sacker
    • S.V. Gale
    • J.W. Harrison
    Transactions
    • 05 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 23 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 mai 1990
    Livré le 04 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £25,000
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Leon Liebman
    Transactions
    • 04 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 28 mars 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 nov. 1985
    Livré le 04 déc. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 déc. 1985Enregistrement d'une charge
    • 30 oct. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SLG REALISATIONS PLC a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    25 août 2012Dissolved on
    21 mai 2002Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Elizabeth Anne Bingham
    Becket House
    1 Lambeth Palace Road
    SE1 7EU London
    practitioner
    Becket House
    1 Lambeth Palace Road
    SE1 7EU London
    Michael David Rollings
    Becket House
    1 Lambeth Palace Road
    SE1 7EU London
    practitioner
    Becket House
    1 Lambeth Palace Road
    SE1 7EU London
    Patrick Joseph Brazzill
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0