MAYBORN (UK) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MAYBORN (UK) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01894022 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MAYBORN (UK) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Mayborn House Balliol Business Park NE12 8EW Newcastle Upon Tyne United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MAYBORN (UK) LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MAYBORN (UK) LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 11 mai 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 25 mai 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 11 mai 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour MAYBORN (UK) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessation de la nomination de Louise Jean Paulucy Rich en tant que directeur le 30 avr. 2026 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2024 | 37 pages | AA | ||||||||||
legacy | 63 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 2 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 2 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Paul Ely en tant que directeur le 12 mars 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Martin Gerard Cooke en tant qu'administrateur le 10 mai 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2023 | 37 pages | AA | ||||||||||
legacy | 64 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Jianjun Shi en tant qu'administrateur le 07 oct. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen William Parkin en tant que directeur le 05 sept. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2022 | 37 pages | AA | ||||||||||
legacy | 64 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 2 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Louise Jean Paulucy Rich le 20 nov. 2023 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de James William Matthew Taylor en tant que directeur le 18 août 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Louise Paulucy Rich en tant qu'administrateur le 08 août 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de MAYBORN (UK) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOKE, Martin Gerard | Administrateur | Balliol Business Park NE12 8EW Newcastle Upon Tyne Mayborn House United Kingdom | England | British | 335674470001 | |||||
| SHI, Jianjun | Administrateur | Balliol Business Park NE12 8EW Newcastle Upon Tyne Mayborn House United Kingdom | England | Chinese | 303961170001 | |||||
| CUSWORTH, James Bruce | Secrétaire | 155 Middle Drive Ponteland NE20 9DU Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | English | 1628620001 | ||||||
| DOWSON, Peter Wylie | Secrétaire | Northumberland Business Park West NE23 7RH Cramlington Jackel International Limited Northumberland England | British | 67689990002 | ||||||
| HARTLEY, Ian Michael | Secrétaire | 29 Eynsford Rise DA4 0HS Eynsford Kent | British | 120062080001 | ||||||
| ALBERICI, Piero Luigi | Administrateur | 30 Burdon Terrace NE2 3AE Jesmond Newcastle Upon Tyne | England | British | 44150910002 | |||||
| AUSTIN, Neal | Administrateur | Balliol Business Park NE12 8EW Newcastle Upon Tyne Mayborn House United Kingdom | England | British | 178750590001 | |||||
| BANERJI, Ranjan | Administrateur | The Beeches 46 Western Way Ponteland NE20 9AP Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 65855100001 | ||||||
| BARKER, David Dunn | Administrateur | The Dell Fulbeck NE61 3JY Morpeth Northumberland | British | 35520560001 | ||||||
| BOWEN, Richard Eric | Administrateur | 63 Stowor Park Road B91 1EQ Solihull West Midlands | England | British | 20407970001 | |||||
| CHAN, Pik Wong | Administrateur | 84 Lawrence Street Alexandria Nsw 2015 Australia | British | 35748560002 | ||||||
| CHAPMAN, Edward | Administrateur | Balliol Business Park NE12 8EW Newcastle Upon Tyne Mayborn House United Kingdom | United Kingdom | British | 58560640002 | |||||
| COLLINS, Richard | Administrateur | 15 Sedgmoor Close HP10 9BH Flackwell Heath Buckinghamshire | England | British | 141820080001 | |||||
| CORNELIUS, George Charles Caswell | Administrateur | The Old Farm House Old Mill Road Broughton Astley LE9 6PQ Leicester Leicestershire | British | 59350110001 | ||||||
| CUSWORTH, James Bruce | Administrateur | 155 Middle Drive Ponteland NE20 9DU Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | English | 1628620001 | |||||
| DALZIEL, Gary | Administrateur | 11 The Lea Finchampstead RG40 4YB Wokingham Berkshire | Great Britain | British | 126243590001 | |||||
| DOCKAR, Lynn Christine | Administrateur | Grey Gables Old Great North Road LS25 3AW Aberford West Yorkshire | British | 26971110001 | ||||||
| DOWSON, Peter Wylie | Administrateur | Northumberland Business Park West NE23 7RH Cramlington Jackel International Limited Northumberland England | United Kingdom | British | 67689990002 | |||||
| ELY, Simon Paul | Administrateur | Balliol Business Park NE12 8EW Newcastle Upon Tyne Mayborn House United Kingdom | United Kingdom | British | 307534890001 | |||||
| GRIFFIN, Kevan William | Administrateur | Anick Old House Anick NE46 4LW Hexham Northumberland | British | 45246580002 | ||||||
| HALL, Mark Alan Stanley | Administrateur | Northumberland Business Park West NE23 7RH Cramlington Jackel International Limited Northumberland England | England | British | 113180470003 | |||||
| HARDENBERG, Marc | Administrateur | 1 Post Office Terrace ST11 9QS Fulford Staffordshire | England | Dutch | 104760900001 | |||||
| HARTLEY, Ian Michael | Administrateur | 29 Eynsford Rise DA4 0HS Eynsford Kent | United Kingdom | British | 120062080001 | |||||
| HILLMAN, Sarah Walpole | Administrateur | 3 Mackerel Hall SG8 5BS Royston Hertfordshire | England | British | 41947820001 | |||||
| HUGHES, David Kevin | Administrateur | 5 The Hols AL7 2HN Welwyn Garden City Hertfordshire | England | British | 176016050001 | |||||
| HUNTER, Carol Ann | Administrateur | 54a Barrowgate Road Chiswick W4 4QY London | England | British | 66385940003 | |||||
| JONES, David John | Administrateur | 6 Woodside NE46 1HU Hexham Northumberland | British | 54359880001 | ||||||
| KANKIWALA, Nishpank Rameshbabu | Administrateur | One Tree Hill Sparrow Row GU24 8TA Chobham Surrey England | England | British | 112673960001 | |||||
| KINCAID, Norman | Administrateur | 11 Southlands NE30 2QS North Shields Tyne & Wear | British | 107999560001 | ||||||
| MOONEY, John Ashley Case | Administrateur | Monks Lodge Newminster NE61 2YJ Morpeth Northumberland | British | 89065570001 | ||||||
| PARKIN, Stephen William | Administrateur | Balliol Business Park NE12 8EW Newcastle Upon Tyne Mayborn House United Kingdom | United Kingdom | British | 115333810003 | |||||
| REES, Arnold Edward | Administrateur | 9 Melmerby Close Gosforth NE3 5JA Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 141731980001 | ||||||
| RICH, Louise Jean Paulucy | Administrateur | Balliol Business Park NE12 8EW Newcastle Upon Tyne Mayborn House United Kingdom | England | British | 312668660002 | |||||
| RIDDELL, Simon Francis | Administrateur | Cheeseburn Grange Stamfordham NE18 0PT Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 13102240002 | |||||
| RIDDELL, Simon Francis | Administrateur | Cheeseburn Grange Stamfordham NE18 0PT Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 13102240002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MAYBORN (UK) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayborn Group Limited | 06 avr. 2016 | Balliol Business Park NE12 8EW Newcastle Upon Tyne Mayborn House United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0