THE RESTAURANT PARTNERSHIP PLC

THE RESTAURANT PARTNERSHIP PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE RESTAURANT PARTNERSHIP PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 01901705
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE RESTAURANT PARTNERSHIP PLC ?

    • Restaurants avec licence (56101) / Hébergement et restauration
    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe THE RESTAURANT PARTNERSHIP PLC ?

    Adresse du siège social
    Corus House
    1 Auckland Park
    MK1 1BU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE RESTAURANT PARTNERSHIP PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CRAWLEY WILSON RESTAURANTS PUBLIC LIMITED COMPANY03 déc. 198503 déc. 1985
    CRAWLEY WILSON INVESTMENTS LIMITED18 juin 198518 juin 1985
    PASTCASE LIMITED02 avr. 198502 avr. 1985

    Quels sont les derniers comptes de THE RESTAURANT PARTNERSHIP PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour THE RESTAURANT PARTNERSHIP PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 09 sept. 2020 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Yet King Loy en tant que directeur le 18 févr. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David Michael Westerby en tant qu'administrateur le 18 févr. 2020

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2019

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 sept. 2019 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 30 juin 2018

    23 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 sept. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Kwan Cheong Ng en tant que directeur le 29 août 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nyen Faat Wong en tant que directeur le 29 août 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Yet King Loy en tant qu'administrateur le 28 août 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Khurram Mohmand en tant qu'administrateur le 28 août 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Andrew Khoo en tant qu'administrateur le 28 août 2018

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2017

    18 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Changement d'adresse du siège social de The Old Farmhouse Rossway Park Estate Berkhamsted Hertfordshire HP4 3TZ à Corus House 1 Auckland Park Milton Keynes Buckinghamshire MK1 1BU le 01 nov. 2017

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 09 sept. 2017 avec mises à jour

    39 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2016

    20 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 09 sept. 2016 avec mises à jour

    41 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de THE RESTAURANT PARTNERSHIP PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MOHMAND, Khurram
    1 Auckland Park
    MK1 1BU Milton Keynes
    Corus House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    1 Auckland Park
    MK1 1BU Milton Keynes
    Corus House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    179043740001
    KHOO, Andrew
    1 Auckland Park
    MK1 1BU Milton Keynes
    Corus House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Auckland Park
    MK1 1BU Milton Keynes
    Corus House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomAustralianDirector249871890001
    MOHMAND, Khurram
    1 Auckland Park
    MK1 1BU Milton Keynes
    Corus House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Auckland Park
    MK1 1BU Milton Keynes
    Corus House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant250433850001
    WESTERBY, David Michael
    1 Auckland Park
    MK1 1BU Milton Keynes
    Corus House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Auckland Park
    MK1 1BU Milton Keynes
    Corus House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector267685530001
    CLAYTON, Andrew
    Rossway Park Estate
    HP4 3TZ Berkhamsted
    The Old Farmhouse
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Rossway Park Estate
    HP4 3TZ Berkhamsted
    The Old Farmhouse
    Hertfordshire
    UkLegal Manager102497250001
    MANTZ, Ann Elizabeth
    21 Four Wents
    KT11 2NE Cobham
    Surrey
    Secrétaire
    21 Four Wents
    KT11 2NE Cobham
    Surrey
    British37441550001
    PILLAY, Paul Vijayasingam
    69 Lilleshall Avenue
    Monkston
    MK10 9HU Milton Keynes
    Secrétaire
    69 Lilleshall Avenue
    Monkston
    MK10 9HU Milton Keynes
    Other79416150001
    SMART, Elaine Anne Joyce
    Mill Green House
    Stoke By Clare
    CO10 8HJ Sudbury
    Suffolk
    Secrétaire
    Mill Green House
    Stoke By Clare
    CO10 8HJ Sudbury
    Suffolk
    British24843530002
    STOKES, James Patrick
    Ashvine
    Westridge Highclere
    RG20 9RY Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    Ashvine
    Westridge Highclere
    RG20 9RY Newbury
    Berkshire
    British77171430001
    TAN, Magdalene Siok Leng
    9 Skeats Wharf
    Pennyland
    MK15 8AY Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    9 Skeats Wharf
    Pennyland
    MK15 8AY Milton Keynes
    Buckinghamshire
    MalaysianLawyer96244810002
    TANSEY, Philip
    15 Ashbourne Avenue
    NW11 0DP London
    Secrétaire
    15 Ashbourne Avenue
    NW11 0DP London
    British2962740002
    TANSEY, Philip
    1 Weech Road
    NW6 1DL London
    Secrétaire
    1 Weech Road
    NW6 1DL London
    British2962740001
    VARLEY, Martin Peter
    7 Trott Street
    SW11 3DS London
    Secrétaire
    7 Trott Street
    SW11 3DS London
    BritishCompany Secretary77370250001
    VAUGHAN, James Anthony Sanya
    Flat 1
    41 Fairhazel Gardens
    NW6 3QN London
    Secrétaire
    Flat 1
    41 Fairhazel Gardens
    NW6 3QN London
    British54129740001
    ACKERMAN, Royston Kenneth, Dr
    35 Tadema Road
    SW10 0PZ London
    Administrateur
    35 Tadema Road
    SW10 0PZ London
    EnglandBritishCompany Director46368750001
    BREACH, Paul Ellis
    4 Clifton Gate
    Hollywood Road
    SW10 9XD London
    Administrateur
    4 Clifton Gate
    Hollywood Road
    SW10 9XD London
    United KingdomUnited KingdomCompany Director110210220001
    CAHILL, John Patrick
    1 Wentworth Cottages
    Thorndown Lane
    GU20 6DJ Windlesham
    Surrey
    Administrateur
    1 Wentworth Cottages
    Thorndown Lane
    GU20 6DJ Windlesham
    Surrey
    BritishDirector63753920001
    CLAYTON, Andrew
    Rossway Park Estate
    HP4 3TZ Berkhamsted
    The Old Farmhouse
    Hertfordshire
    Administrateur
    Rossway Park Estate
    HP4 3TZ Berkhamsted
    The Old Farmhouse
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector102497250003
    CRAWLEY, Nicholas David Townsend
    Ogbourne Maizey Manor
    Ogbourne Maizey
    SN8 1RY Marlborough
    Wiltshire
    Administrateur
    Ogbourne Maizey Manor
    Ogbourne Maizey
    SN8 1RY Marlborough
    Wiltshire
    EnglandEnglishRestaurateur96980780001
    GATER, George
    1 High St North
    Stewkley
    LU7 0HJ Leighton Buzzard
    Tythe House
    Beds
    Uk
    Administrateur
    1 High St North
    Stewkley
    LU7 0HJ Leighton Buzzard
    Tythe House
    Beds
    Uk
    United KingdomScottishCompany Director1111000002
    HOLMES, Charles Richard
    5 Morris Drive
    SN8 1TT Marlborough
    Wiltshire
    Administrateur
    5 Morris Drive
    SN8 1TT Marlborough
    Wiltshire
    BritishDirector81939380001
    KIRSCHNER, Gerd Peter
    100 Blanchland Circle
    Monkston
    MK10 9FL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    100 Blanchland Circle
    Monkston
    MK10 9FL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    AustrianDirector72256270002
    LOY, Yet King
    1 Auckland Park
    MK1 1BU Milton Keynes
    Corus House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Auckland Park
    MK1 1BU Milton Keynes
    Corus House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomCanadianDirector212662900002
    NG, Kwan Cheong
    HP4 3TZ Berkhamsted
    The Old Farmhouse Rossway
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    HP4 3TZ Berkhamsted
    The Old Farmhouse Rossway
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector212646760001
    O BRIEN, Conor John Anthony
    Gorsefield House
    Newtown Common
    RG20 9BE Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Gorsefield House
    Newtown Common
    RG20 9BE Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Director72690550002
    OFFORD, Derek Robert
    17 Claremont Road
    TN1 1SY Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    17 Claremont Road
    TN1 1SY Tunbridge Wells
    Kent
    BritishDirector45845620001
    ONG, Hung Ming
    Rossway Park Estate
    HP4 3TZ Berkhamsted
    The Old Farmhouse
    Hertfordshire
    Administrateur
    Rossway Park Estate
    HP4 3TZ Berkhamsted
    The Old Farmhouse
    Hertfordshire
    MalaysiaMalaysianDirector173029030001
    PILLAY, Paul Vijayasingam
    69 Lilleshall Avenue
    Monkston
    MK10 9HU Milton Keynes
    Administrateur
    69 Lilleshall Avenue
    Monkston
    MK10 9HU Milton Keynes
    OtherCompany Secretary79416150001
    SALVONI, Elena Maria
    27 Noel Road
    Islington
    N1 8HQ London
    Administrateur
    27 Noel Road
    Islington
    N1 8HQ London
    ItalianCompany Director36471970001
    SCADE, Thomas Nicholas
    New Mill House New Mill Road
    RG27 0RB Eversley
    Hampshire
    Administrateur
    New Mill House New Mill Road
    RG27 0RB Eversley
    Hampshire
    BritishRestauranteur And Co.Director3568490001
    SCHMIDT, Jurgen
    301 Beaulah Hill
    SE19 3UZ London
    Administrateur
    301 Beaulah Hill
    SE19 3UZ London
    GermanCompany Director39756930001
    STOKES, James Patrick
    Ashvine
    Westridge Highclere
    RG20 9RY Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Ashvine
    Westridge Highclere
    RG20 9RY Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Director77171430001
    TAN, Magdalene Siok Leng
    9 Skeats Wharf
    Pennyland
    MK15 8AY Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    9 Skeats Wharf
    Pennyland
    MK15 8AY Milton Keynes
    Buckinghamshire
    MalaysianLawyer96244810002
    TANG, Kim Siw
    Rossway Park Estate
    HP4 3TZ Berkhamsted
    The Old Farmhouse
    Hertfordshire
    Administrateur
    Rossway Park Estate
    HP4 3TZ Berkhamsted
    The Old Farmhouse
    Hertfordshire
    MalaysiaMalaysianDirector119268250001
    WALTON MASTERS, David Ralph
    Hatchet Lane Farm
    Hatchet Lane
    SL5 8QE Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Hatchet Lane Farm
    Hatchet Lane
    SL5 8QE Ascot
    Berkshire
    EnglandBritishDirector7332180001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THE RESTAURANT PARTNERSHIP PLC ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Corus Hotels Limited
    Rossway Park
    Rossway
    HP4 3TZ Berkhamsted
    Corus House
    Herts
    United Kingdom
    25 avr. 2016
    Rossway Park
    Rossway
    HP4 3TZ Berkhamsted
    Corus House
    Herts
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueCompany
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleEngland
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement171238
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actions de la société.

    THE RESTAURANT PARTNERSHIP PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Second debenture
    Créé le 30 janv. 2006
    Livré le 03 févr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Corus Hotels PLC
    Transactions
    • 03 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 02 nov. 2005
    Livré le 05 nov. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Corus Hotels PLC
    Transactions
    • 05 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 07 juil. 1998
    Livré le 08 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 06 juil. 1998
    Livré le 09 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2 greek street london. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 06 juil. 1998
    Livré le 09 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a ground foor and basement at 48 rochester row london t/n NGL734695. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 06 juil. 1998
    Livré le 09 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a basement and ground floor at 342 kings road london t/n NGL625065. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 06 juil. 1998
    Livré le 09 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a basement and ground floor 7 park walk chelsea london. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 06 juil. 1998
    Livré le 09 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a basement and ground floor at 29/35 great portland street london. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 06 juil. 1998
    Livré le 09 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a premises on the ground floor of orion aparthotel 7-21 goswell road london. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 06 mai 1998
    Livré le 16 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a deed of guarantee of even date herewith
    Brèves mentions
    The gay hussar 2 greek street london together with all plant machinery implements utensils furniture and equipment and the goodwill of the business.
    Personnes ayant droit
    • Regal Hotel Group PLC
    Transactions
    • 16 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 avr. 1998
    Livré le 27 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H orion aparthotel 7/21 goswell road london EC1 floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture equipment floating charge the undertaking property assets.
    Personnes ayant droit
    • Josiah Wedgwood & Sons Limited
    Transactions
    • 27 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 mars 1998
    Livré le 03 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal charge
    Brèves mentions
    L/H ground floor and basement 7 park walk chelsea london SW10. By way of by way of floating charge the undertaking and all other property assets and rights present and future. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Josiah Wedgwood & Sons Limited
    Transactions
    • 03 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 janv. 1998
    Livré le 10 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Ground floor & basement 7 park walk chelsea l/b of kensington & chelsea.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 déc. 1997
    Livré le 06 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Restaurant premises at the orion aparthotel 7/21 goswell road royal london borough of kensington and chelsea.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 mars 1997
    Livré le 14 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2 greek street l/b of city of westminster.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 févr. 1997
    Livré le 11 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that l/h property k/a the ground floor and basement of 342 kings road chelsea london SW3 5UR comprised in the lease t/n NGL625065 with all buildings fixtures fittings plant and machinery by way of floating charge the undertaking and all other property and assets. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Josiah Wedgwood & Sons Limited
    Transactions
    • 11 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 févr. 1997
    Livré le 11 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that l/h property k/a part ground floor and basement 29/35 great portland street london W1 with all buildings fixtures fittings planr and machinery by way of floating charge the underaking and all property and assets. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Josiah Wedgwood & Sons Limited
    Transactions
    • 11 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 févr. 1997
    Livré le 11 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that l/h property k/a ground floor and basement 48 rochester row london SW1 t/n NGL734695 with all buildings fixtures fittings plant and machinery by way of floating charge all undertaking property and assets. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Josiah Wedgwood & Sons Limited
    Transactions
    • 11 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 févr. 1997
    Livré le 11 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that l/h property k/a 30 charlotte street london W1P 1HJ t/n NGL736403 with all buildings fixtures and fittings by way of floating charge the undertaking and all property and assets. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Josiah Wedgwood & Sons Limited
    Transactions
    • 11 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 juil. 1996
    Livré le 15 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Ground floor shop and basement premises forming part of the building k/a 29/35 great portland street london borough of city of westminster.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rental deposit agreement
    Créé le 03 juil. 1996
    Livré le 06 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 16TH december 1988
    Brèves mentions
    The deposit account opened by the chargee in the sum of £41,125 (being the deposit of £35,000 plus V.A.T.).. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Collin Estates Limited
    Transactions
    • 06 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rental deposit deed
    Créé le 01 juil. 1996
    Livré le 18 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £13,250 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All money from time to time standing to the credit of the deposit account including the initial deposit of £13,250.
    Personnes ayant droit
    • Maurice Saleh Gourgey and Kathe Gourgey and Da Phillips & Co(Trustees of Pedersen Caterers Pension Scheme)
    Transactions
    • 18 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 juil. 1996
    Livré le 15 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Part of 48 rochester row l/b of city of westminster t/n NGL734695.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 août 1995
    Livré le 24 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that the land and premises shortly k/as 1 percy street london W1.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 févr. 1995
    Livré le 27 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    30 charlotte street london l/b of camden.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0