MUFG RETIREMENT SOLUTIONS PENSION ADMINISTRATION (HS) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | MUFG RETIREMENT SOLUTIONS PENSION ADMINISTRATION (HS) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01901744 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MUFG RETIREMENT SOLUTIONS PENSION ADMINISTRATION (HS) LIMITED ?
Adresse du siège social | Oxford Point 13-17 Oxford Road BH8 8GS Bournemouth United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MUFG RETIREMENT SOLUTIONS PENSION ADMINISTRATION (HS) LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 30 juin 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 mars 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MUFG RETIREMENT SOLUTIONS PENSION ADMINISTRATION (HS) LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 07 mars 2026 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 21 mars 2026 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 07 mars 2025 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour MUFG RETIREMENT SOLUTIONS PENSION ADMINISTRATION (HS) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 07 mars 2025 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Link Group Corporate Director Limited le 20 janv. 2025 | 1 pages | CH02 | ||||||||||
Modification des détails de Link Pension Administration Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 janv. 2025 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed link pension administration (hs) LIMITED\certificate issued on 20/01/25 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Inscription de la charge 019017440004, créée le 28 nov. 2024 | 25 pages | MR01 | ||||||||||
Modification des détails de Link Pension Administration Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 sept. 2024 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Link Group Corporate Director Limited le 30 sept. 2024 | 1 pages | CH02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 6th Floor 65 Gresham Street London EC2V 7NQ England à Oxford Point 13-17 Oxford Road Bournemouth BH8 8GS le 30 sept. 2024 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2023 | 24 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 07 mars 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Graham Mark Hickling en tant que directeur le 19 oct. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed hs pensions LIMITED\certificate issued on 03/07/23 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 07 mars 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 30 juin 2022 au 30 juin 2023 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Graham Mark Hickling le 31 oct. 2022 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Link Group Corporate Director Limited en tant qu'administrateur le 01 nov. 2022 | 2 pages | AP02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Simon Pattison en tant que directeur le 31 oct. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Daniel John Joselyn en tant que directeur le 31 oct. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Steven Michael Goddard en tant que directeur le 31 oct. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Anthony Blackmur en tant que directeur le 31 oct. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Deidre Michelle Mcgrath en tant qu'administrateur le 01 nov. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Richard James Wilson en tant qu'administrateur le 31 oct. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Alexander Eben Ronald Tullett en tant qu'administrateur le 31 oct. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Peter Jones en tant que directeur le 29 oct. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de Goddard Perry Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 oct. 2022 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de MUFG RETIREMENT SOLUTIONS PENSION ADMINISTRATION (HS) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGRATH, Deidre Michelle | Administrateur | 13-17 Oxford Road BH8 8GS Bournemouth Oxford Point United Kingdom | Australia | Australian | Ceo | 301828790001 | ||||||||
TULLETT, Alexander Eben Ronald | Administrateur | 13-17 Oxford Road BH8 8GS Bournemouth Oxford Point United Kingdom | England | British | Director | 261027470001 | ||||||||
WILSON, Richard James | Administrateur | 13-17 Oxford Road BH8 8GS Bournemouth Oxford Point United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 282947470001 | ||||||||
MUFG PMS CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Administrateur | 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Central Square United Kingdom |
| 239773600009 | ||||||||||
ALEXANDER, Aileen Lesley | Secrétaire | 11 The Glebe PH2 9GF Abernethy Perthshire | British | 112583930001 | ||||||||||
ELSTON, David Aiken | Secrétaire | Aegon House Daresbury Park WA4 4HS Daresbury Cheshire | British | 152119670001 | ||||||||||
JOHNS, Janet Wilson | Secrétaire | 45 Daniell Way CH3 5XH Chester Cheshire | British | 9333010001 | ||||||||||
MACKENZIE, James Kenneth | Secrétaire | Aegon House Daresbury Park WA4 4HS Daresbury Cheshire | British | 155175590001 | ||||||||||
YOUNG, Ian Gordon | Secrétaire | 30 Lennox Row EH5 3LT Edinburgh Midlothian | British | 15401360002 | ||||||||||
ADAMSON, Mark Henzell | Administrateur | 12 Alma Road Clifton BS8 2BY Bristol | British | Company Director | 98758680001 | |||||||||
BEATTIE, John Colin | Administrateur | Aegon House Daresbury Park WA4 4HS Daresbury Cheshire | Scotland | British | Managing Director | 136508990001 | ||||||||
BLACKMAN, Andrew John | Administrateur | Tudor Close CR2 9DX South Croydon 22 Surrey | England | British | Director Pensions & Employee Benefits | 117751660001 | ||||||||
BLACKMUR, Paul Anthony | Administrateur | Gresham Street EC2V 7NQ London 6th Floor 65 England | England | British | Company Director | 291426250001 | ||||||||
BRUNET, Maurice Clive | Administrateur | 12 Abbots Walk KY2 5NL Kirkcaldy Fife | United Kingdom | British | Director | 62153230002 | ||||||||
CHADWICK, Robert | Administrateur | 20 Tarvin Road Littleton CH3 7DG Chester Cheshire | England | British | Company Director | 119286210001 | ||||||||
CONNOR, Stephen | Administrateur | Aegon House Daresbury Park WA4 4HS Daresbury Cheshire | United Kingdom | British | Director | 57576050002 | ||||||||
COONEY, Cathryn Anne | Administrateur | Amberlea Mold Road Wylfa Hill Mynydd Isa CH7 6TD Mold Flintshire | British | Administration Director | 63745990003 | |||||||||
DORNAN, Peter Gordon | Administrateur | 2 Hopetoun Park EH31 2EP Gullane East Lothian | Scotland | British | Director Of Group Business | 77337710001 | ||||||||
GODDARD, Steven Michael | Administrateur | High Street TN13 1JD Sevenoaks The Old Vicarage Kent | England | British | Director Pension & Employee Benefits | 71681800001 | ||||||||
GRACE, Adrian Thomas | Administrateur | Aegon House Daresbury Park WA4 4HS Daresbury Cheshire | United Kingdom | British | Business Manager | 125518930001 | ||||||||
HICKLING, Graham Mark | Administrateur | Gresham Street EC2V 7NQ London 6th Floor 65 England | England | British | None | 156117950003 | ||||||||
HICKLING, Graham Mark | Administrateur | 17 Lansdowne Road CR0 2BX Croydon 8th Floor Corinthian House Surrey | England | British | Director | 138276550001 | ||||||||
HORN, Iain George | Administrateur | 99 Beamish Close Appleton WA4 5RJ Warrington | British | Managing Director | 81285160002 | |||||||||
JONES, Peter | Administrateur | Gresham Street EC2V 7NQ London 6th Floor 65 England | England | British | Pensions Manager | 278135940001 | ||||||||
JOSELYN, Daniel John | Administrateur | Gresham Street EC2V 7NQ London 6th Floor 65 England | England | British | Company Director | 298246750001 | ||||||||
MACKLE, Feilim | Administrateur | 11 Marine Parade EH39 4LD North Berwick East Lothian | Scotland | Irish | Company Director | 164413100001 | ||||||||
PATTISON, Mark Simon | Administrateur | Gresham Street EC2V 7NQ London 6th Floor 65 England | England | British | Company Director | 264174130001 | ||||||||
QUINLIVAN, John | Administrateur | 26 Woodside Park Avenue Walthamstow E17 3NP London | British American | Sales Development Actuary | 77511360001 | |||||||||
ROBERTSON, William John | Administrateur | 4 Cavendish Drive Newton Mearns G77 5NY Glasgow | Scotland | British | Actuarial Director | 145428580001 | ||||||||
SCOTT, Gillian Catherine | Administrateur | Aegon House Daresbury Park WA4 4HS Daresbury Cheshire | United Kingdom | British | Director | 124638490001 | ||||||||
SMITH, Ronald | Administrateur | St Michaels Golly Burton Rossett LL12 0AH Wrexham Clwyd | British | Director | 5826110001 | |||||||||
STEVENSON, Nina Clare | Administrateur | 17 Lansdowne Road CR0 2BX Croydon Corinthian House Surrey | United Kingdom | British | Director | 196362910001 | ||||||||
STEWARD, John Timothy Hugh | Administrateur | The Farthings Well Lane CH3 8AU Mouldsworth Cheshire | England | British | Company Director | 9333020001 | ||||||||
STEWARD, Margaret Beatrice | Administrateur | The Farthings Well Lane CH3 8AU Mouldsworth Cheshire | England | British | Company Director | 9333030001 | ||||||||
THORESEN, Otto | Administrateur | Westerlea Abbotsford Road EH39 5DB North Berwick East Lothian | Scotland | British | Director | 45163250002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MUFG RETIREMENT SOLUTIONS PENSION ADMINISTRATION (HS) LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mufg Retirement Solutions Pension Administration Limited | 31 oct. 2022 | 13-17 Oxford Road BH8 8GS Bournemouth Oxford Point United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Goddard Perry Holdings Limited | 07 sept. 2020 | 17 Lansdowne Road CR0 2BX Croydon Corinthian House Surrey England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Goddard Perry Consulting Limited | 06 avr. 2016 | Lansdowne Road CR0 2BX Croydon Corinthian House England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0