TULLETT PREBON (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTULLETT PREBON (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01908771
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TULLETT PREBON (UK) LIMITED ?

    • Administration des marchés financiers (66110) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe TULLETT PREBON (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    135 Bishopsgate
    EC2M 3TP London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TULLETT PREBON (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PREBON MARSHALL YAMANE (UK) LIMITED01 juin 199901 juin 1999
    PREBON YAMANE (UK) LIMITED31 juil. 199231 juil. 1992
    BABCOCK FULTON PREBON LIMITED10 avr. 199010 avr. 1990
    BABCOCK & BROWN (KW) LIMITED15 juin 198915 juin 1989
    BABCOCK & BROWN (MONEY MARKET) LIMITED16 juil. 198616 juil. 1986
    MONEY MARKET AGENCIES LIMITED16 janv. 198616 janv. 1986
    PRECIS (456) LIMITED26 avr. 198526 avr. 1985

    Quels sont les derniers comptes de TULLETT PREBON (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour TULLETT PREBON (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pagesLIQ13

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 10 déc. 2021

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 24 nov. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 30 oct. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2020 au 30 déc. 2020

    1 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de Floor 2 155 Bishopsgate London EC2M 3TQ England à 135 Bishopsgate London EC2M 3TP le 07 mai 2021

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    1 pagesAA

    État du capital au 04 déc. 2020

    • Capital: GBP 0.10
    3 pagesSH19

    Déclaration de confirmation établie le 30 oct. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c 22/04/2020
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    26 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration de confirmation établie le 29 oct. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Andrew Ren-Yiing Chen en tant qu'administrateur le 23 oct. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Paul James Ashley en tant que directeur le 27 sept. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    1 pagesAA

    Modification des détails de Prebon Yamane International Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 déc. 2018

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de Tower 42 Level 37 25 Old Broad Street London EC2N 1HQ à Floor 2 155 Bishopsgate London EC2M 3TQ le 31 déc. 2018

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 16 oct. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    1 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robin James Stewart le 17 juil. 2018

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de TULLETT PREBON (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHEN, Andrew Ren-Yiing
    EC2M 3TP London
    135 Bishopsgate
    England
    Administrateur
    EC2M 3TP London
    135 Bishopsgate
    England
    EnglandBritish225251990001
    STEWART, Robin James
    EC2M 3TP London
    135 Bishopsgate
    England
    Administrateur
    EC2M 3TP London
    135 Bishopsgate
    England
    EnglandBritish161299680001
    ANKERS, Peter
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    Secrétaire
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    British56413750001
    ANKERS, Peter
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    Secrétaire
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    British56413750001
    BRILL, Tiffany Fern
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    Secrétaire
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    218151560001
    CHALLEN, Nicola
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Secrétaire
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Other119903660002
    DE FREITAS, Maria Teresa
    Flat 1 47 Lloyd Baker Street
    WC1X 9AA London
    Secrétaire
    Flat 1 47 Lloyd Baker Street
    WC1X 9AA London
    British95153090009
    DEARLOVE, Juliet Mary
    Churchgate House
    15 Churchgate Street
    CM17 0JT Old Harlow
    Essex
    Secrétaire
    Churchgate House
    15 Churchgate Street
    CM17 0JT Old Harlow
    Essex
    British72784040001
    DYER BARTLETT, Diana
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Secrétaire
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    177123560001
    HOSKINS, Justin Wilbert
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Secrétaire
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    171912470001
    MAYHILL, Geoffrey Ronald
    1 The Avenue
    Kew
    TW9 2AL Richmond
    Surrey
    Secrétaire
    1 The Avenue
    Kew
    TW9 2AL Richmond
    Surrey
    British812670009
    PEEL, Alistair Charles
    Deep Acres
    HP6 5NX Amersham
    6
    Bucks
    England
    Secrétaire
    Deep Acres
    HP6 5NX Amersham
    6
    Bucks
    England
    British90844500002
    SHAW, Gary Allan
    63a Cambray Road
    SW12 0ER London
    Secrétaire
    63a Cambray Road
    SW12 0ER London
    British67579830001
    DAVID VENUS & COMPANY LLP
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    Forme juridiqueLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Type d'identificationHors EEE
    Autorité légaleCOMPANIES ACT 2006
    Numéro d'enregistrementOC309455
    131429630001
    ASHLEY, Paul James
    Bishopsgate
    EC2M 3TQ London
    155
    United Kingdom
    Administrateur
    Bishopsgate
    EC2M 3TQ London
    155
    United Kingdom
    EnglandBritish332150410001
    BATEMAN, Richard Harrison
    Mabbs Hill Farmhouse
    Stonegate
    TN5 7EF Wadhurst
    East Sussex
    Administrateur
    Mabbs Hill Farmhouse
    Stonegate
    TN5 7EF Wadhurst
    East Sussex
    British1478010001
    BOLTON, Marcus Peregrine
    High Barn
    Sutton Place, Abinger Hammer
    RH5 6RP Dorking
    Surrey
    Administrateur
    High Barn
    Sutton Place, Abinger Hammer
    RH5 6RP Dorking
    Surrey
    EnglandBritish84102400001
    BRIGHT, Steven Lee
    35 Forest Way
    IG8 0QB Woodford Green
    Essex
    Administrateur
    35 Forest Way
    IG8 0QB Woodford Green
    Essex
    British104678480001
    BUIK, David Barlow
    22 Regents Park Road
    NW1 7TX London
    Administrateur
    22 Regents Park Road
    NW1 7TX London
    Canadian2294590001
    BURNETT, Michael Arthur
    65 Ellerby Street
    SW6 6EU London
    Administrateur
    65 Ellerby Street
    SW6 6EU London
    British32574310001
    CALVERT, John Michael
    Brick House Farm
    Cherry Street, Duton Hill
    CM6 2EE Dunmow
    Essex
    Administrateur
    Brick House Farm
    Cherry Street, Duton Hill
    CM6 2EE Dunmow
    Essex
    British68355150001
    COMPAS, Felix George
    265 Edgwarebury Lane
    HA8 8QL Edgware
    Middlesex
    Administrateur
    265 Edgwarebury Lane
    HA8 8QL Edgware
    Middlesex
    British32574320002
    CORKER, Stephen Roger
    10 Monmouth Road
    W2 5SB London
    Administrateur
    10 Monmouth Road
    W2 5SB London
    United KingdomBritish43964780001
    COSTELLO, Kevin
    91 Free Trade Wharf 340 The Highway
    E1 9ET London
    Administrateur
    91 Free Trade Wharf 340 The Highway
    E1 9ET London
    British32574330002
    DAWES, Cindy Jane
    Brook House
    Torland Drive
    KT22 0JA Oxshott
    Surrey
    Administrateur
    Brook House
    Torland Drive
    KT22 0JA Oxshott
    Surrey
    United KingdomUnited Kingdom74822120001
    DUCKWORTH, Stephen Charles
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Administrateur
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    EnglandBritish69519860001
    DUNKLEY, Paul Simon
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Administrateur
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    EnglandBritish138694990001
    GARTHWAITE, Ian Dudley
    Flat 4 4 Addison Crescent
    W14 8JP London
    Administrateur
    Flat 4 4 Addison Crescent
    W14 8JP London
    British32034890001
    GIORDANO, Anthony
    Apartment 204
    Cardomom Building 31 Shad Thames
    SE1 2YR London
    Administrateur
    Apartment 204
    Cardomom Building 31 Shad Thames
    SE1 2YR London
    British32574350001
    GOLDBERG, David Howard
    47 Ventnor Drive
    N20 8BT London
    Administrateur
    47 Ventnor Drive
    N20 8BT London
    British67412280001
    GRANAT, Ian James
    Wychbold
    Church Road Tattingstone
    IP9 2NA Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    Wychbold
    Church Road Tattingstone
    IP9 2NA Ipswich
    Suffolk
    British104761410001
    HARNETT, Geoffrey Victor
    2d Thorney Crescent
    Morgans Walk
    SW11 3TR London
    Administrateur
    2d Thorney Crescent
    Morgans Walk
    SW11 3TR London
    British56333090001
    HAWKINS, James Patrick Fitzgerald
    Gosias Grange
    Thaxted Road Wimbish
    CB10 2UZ Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    Gosias Grange
    Thaxted Road Wimbish
    CB10 2UZ Saffron Walden
    Essex
    British32574370001
    HEATH, Jeremy Richard
    Ruffroof
    40 Lucastes Avenue
    RH16 1JY Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    Ruffroof
    40 Lucastes Avenue
    RH16 1JY Haywards Heath
    West Sussex
    United KingdomBritish32574380001
    HOCKEY, Joseph Max
    3 South Terrace
    High Street
    DA4 0DF Farningham
    Kent
    Administrateur
    3 South Terrace
    High Street
    DA4 0DF Farningham
    Kent
    British78982470001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TULLETT PREBON (UK) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Prebon Yamane International Limited
    155 Bishopsgate
    EC2M 3TQ London
    Floor 2
    England
    06 avr. 2016
    155 Bishopsgate
    EC2M 3TQ London
    Floor 2
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House (England And Wales)
    Numéro d'enregistrement2619854
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    TULLETT PREBON (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental security agreement
    Créé le 12 janv. 2009
    Livré le 15 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies not exceeding £12,500,000.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Trustees of the Tullett Liberty Pension Scheme (The Trustees)
    Transactions
    • 15 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental security agreement
    Créé le 12 janv. 2009
    Livré le 15 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies not exceeding £12,500,000.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Trustees of Prebon Yamane (Ex K-W) Pension Scheme (the Trustees)
    Transactions
    • 15 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of novation and amendment
    Créé le 15 nov. 2007
    Livré le 20 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from tullet prebon group limited under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Floating charge all its assets on the terms of the security agreement as amended by the deed,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Trustees of the Prebon Yamane (Ex K-W) Pension Scheme (Trustees)
    Transactions
    • 20 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement
    Créé le 29 janv. 2007
    Livré le 16 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the principal employer not exceeding £12,500,000 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first floating charge all assets,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Trustees of the Tullett Liberty Pension Scheme
    Transactions
    • 16 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement
    Créé le 29 janv. 2007
    Livré le 13 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the principal employer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First floating charge all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Trustees of the Prebon Yamane (Ex K-W) Pension Scheme
    Transactions
    • 13 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Terms of business agreement
    Créé le 06 mars 2001
    Livré le 27 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Brèves mentions
    By way of first, fixed charge and pledge over all securities, documents of or entering title to property, cash or other assets of any nature held by or subject to the control of fcl by way of deposit or margin (or any nominee or custodian of fcl) for the account of the client (including without limitation, the benefit of all contractual rights and obligations and any proceeds of sale and any securities or other assets which fcl has agreed to hold as custodian) and by way of general lien and right of set-off.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Clearing London Limited
    Transactions
    • 27 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 17 janv. 1986
    Livré le 20 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts. (See doc no M17).
    Personnes ayant droit
    • Aidamoor Limited
    Transactions
    • 20 janv. 1986Enregistrement d'une charge

    TULLETT PREBON (UK) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 déc. 2021Commencement of winding up
    14 mars 2023Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0