LADBROKE RETAIL PARKS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | LADBROKE RETAIL PARKS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01909337 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LADBROKE RETAIL PARKS LIMITED ?
| Adresse du siège social | 3rd Floor One New Change EC4M 9AF London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LADBROKE RETAIL PARKS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour LADBROKE RETAIL PARKS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||
Deuxième dépôt de la déclaration de confirmation datée du 04 nov. 2020 | 3 pages | RP04CS01 | ||||||
Deuxième dépôt d'un bilan du capital suite à une émission d'actions au 09 sept. 2020
| 4 pages | RP04SH01 | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 nov. 2020 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||
| ||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 09 sept. 2020
| 4 pages | SH01 | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 17 mai 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Cessation de la nomination de Sonja Arsenić en tant que secrétaire le 21 nov. 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||
Nomination de Ladbrokes Coral Corporatr Secretaries Limited en tant que secrétaire le 21 nov. 2019 | 2 pages | AP04 | ||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 4 pages | AA | ||||||
Nomination de Sonja Arsenić en tant que secrétaire le 08 août 2019 | 2 pages | AP03 | ||||||
Cessation de la nomination de Ladbrokes Coral Corporate Secretaries Limited en tant que secrétaire le 08 août 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 17 mai 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Modification des détails de Ladbroke Group Properties Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 juil. 2018 | 2 pages | PSC05 | ||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 4 pages | AA | ||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Ladbrokes Coral Corporate Secretaries Limited le 10 juil. 2018 | 1 pages | CH04 | ||||||
Changement d'adresse du siège social de 5th Floor the Zig Zag Building 70 Victoria Street London England SW1E 6SQ England à 3rd Floor One New Change London EC4M 9AF le 17 juil. 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||
Cessation de la nomination de Cassandra Alice Cammidge en tant que directeur le 28 juin 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||
Modification des détails de Ladbroke Group Properties Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 juin 2017 | 2 pages | PSC05 | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 17 mai 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Nomination de Cassandra Alice Cammidge en tant qu'administrateur le 16 avr. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||
Cessation de la nomination de Geoffrey Keith Howard Mason en tant que directeur le 16 avr. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||
Nomination de Charles Alexander Sutters en tant qu'administrateur le 12 déc. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||
Cessation de la nomination de Vinod Parmar en tant que directeur le 12 déc. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||
Qui sont les dirigeants de LADBROKE RETAIL PARKS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADBROKES CORAL CORPORATR SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | One New Change EC4M 9AF London 3rd Floor England |
| 264854400001 | ||||||||||
| SMITH, Stuart John | Administrateur | One New Change EC4M 9AF London 3rd Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 224533160001 | |||||||||
| SUTTERS, Charles Alexander | Administrateur | One New Change EC4M 9AF London 3rd Floor United Kingdom | England | British | 221886390001 | |||||||||
| ARSENIĆ, Sonja | Secrétaire | One New Change EC4M 9AF London 3rd Floor United Kingdom | 261328120001 | |||||||||||
| HUGHES, Barbara | Secrétaire | Flat 3 11 Hazelmere Road NW6 6PY London | British | 45702460001 | ||||||||||
| NOBLE, Michael Jeremy | Secrétaire | Rectory Lodge Parsons Shaw Lusted Hall Lane TN16 2NL Tatsfield Kent | British | 32786810002 | ||||||||||
| LADBROKES CORAL CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | One New Change EC4M 9AF London 3rd Floor United Kingdom | 60530770047 | |||||||||||
| ADAMS, David Alexander Robertson | Administrateur | 58 Dry Hill Park Road TN10 3BX Tonbridge Kent | British | 55757700002 | ||||||||||
| ADELMAN, Jonathan Mark | Administrateur | Imperial House Imperial Drive Rayners Lane HA2 7JW Harrow Middlesex | England | British | 84639590002 | |||||||||
| ANDERSON, Randolph John | Administrateur | 43 Duckett Road N4 1BJ London | British | 65745670001 | ||||||||||
| BARKER, Pamela Joy | Administrateur | 13 The Paddocks Stapleford Abbotts RM4 1HG Romford Essex | British | 115289630001 | ||||||||||
| BATY, John Clifford | Administrateur | Flat C 1 Cranley Gardens N10 3AA London | England | British | 100331850001 | |||||||||
| BOYDELL, Joanna | Administrateur | Boreas Rushmere Lane HP5 3QY Chesham Buckinghamshire | England | British | 118883430001 | |||||||||
| BUSHNELL, Adrian John | Administrateur | Imperial House Imperial Drive Rayners Lane HA2 7JW Harrow Middlesex | United Kingdom | British | 210900670001 | |||||||||
| CAMMIDGE, Cassandra Alice, Cassandra'S Company Secretarial Services | Administrateur | The Zig Zag Building 70 Victoria Street SW1E 6SQ London 5th Floor England England | England | British | 245446520001 | |||||||||
| COLEMAN, John | Administrateur | Belchers Farm Belchers Lane Nazeing EN9 2SA Waltham Abbey Essex | British | 56366250001 | ||||||||||
| DYSON, Ian | Administrateur | The Laurels Miles Lane KT11 2ED Cobham Surrey | British | 50916710001 | ||||||||||
| EARP, Neil Timothy | Administrateur | Springfield Farm Warren Lane SG9 9QD Cottered Hertfordshire | British | 83045240001 | ||||||||||
| FRANKS, Nigel Alan | Administrateur | 18 Gilkes Crescent SE21 7BS London | United Kingdom | British | 119727210001 | |||||||||
| GOSLING, Peter Charles | Administrateur | 95 Worcester Road SM2 6QL Cheam Surrey | England | English | 142633640001 | |||||||||
| HIBBERT, Stephen | Administrateur | Manor House Dockenfield GU10 4HL Farnham Surrey | British | 37097410001 | ||||||||||
| HUMPHREYS, Stephen | Administrateur | 1 Victoria Yard Fairclough Street E1 1PP London | British | 71438830002 | ||||||||||
| JONES, Nigel Richard Ifor | Administrateur | 14 Wootton Hill Farm East Hunsbury NN4 9JJ Northampton | British | 69526300001 | ||||||||||
| LENNARD, Geoffrey | Administrateur | Flat 11 Laurie House 16 Airlie Gardens W8 7AW London | British | 27565120002 | ||||||||||
| LEWIS, Steven David | Administrateur | 66 Sheringham Avenue N14 4UG London | British | 32315950001 | ||||||||||
| MASON, Geoffrey Keith Howard | Administrateur | The Zig Zag Building 70 Victoria Street SW1E 6SQ London 5th Floor England England | United Kingdom | British | 37404250003 | |||||||||
| MORGAN, Nicholas Mark | Administrateur | 55 Dukes Wood Drive SL9 7LJ Gerrard's Cross Buckinghamshire | United Kingdom | British | 106335450001 | |||||||||
| NOBLE, Michael Jeremy | Administrateur | Imperial House Imperial Drive Rayners Lane HA2 7JW Harrow Middlesex | United Kingdom | British | 32786810005 | |||||||||
| O'MAHONY, Jeremiah Francis | Administrateur | Jerpoint House 11 Grange Court Road East Common AL5 1BY Harpenden Hertfordshire | British | 1128630001 | ||||||||||
| PARMAR, Vinod | Administrateur | The Zig Zag Building 70 Victoria Street SW1E 6SQ London 5th Floor England England | United Kingdom | British | 124202750001 | |||||||||
| SHAH, Snehal | Administrateur | Imperial House Imperial Drive Rayners Lane HA2 7JW Harrow Middlesex | United Kingdom | British | 167628520002 | |||||||||
| STEIN, Cyril | Administrateur | Flat 60 Hyde Park Towers Porchester Terrace W2 3HJ London | British | 40629810001 | ||||||||||
| STEWART, Donald Gordon William | Administrateur | Arntemplar 69 Main Street Killearn G63 9NE Glasgow | British | 39839930001 | ||||||||||
| TALJAARD, Desmond Louis Mildmay | Administrateur | 59 Crescent West EN4 0EQ Hadley Wood Hertfordshire | United Kingdom | British | 215884620001 | |||||||||
| TRENTER, Ronald Charles | Administrateur | The Lodge Warren Lane SG9 9QS Cottered Buntingford | British | 92995260001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LADBROKE RETAIL PARKS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladbroke Group Properties Limited | 06 avr. 2016 | One New Change EC4M 9AF London 3rd Floor England United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
LADBROKE RETAIL PARKS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Créé le 06 nov. 1989 Livré le 24 nov. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of missives dated 6TH and 7TH june 1989 amended by formal letters dated 29/9/89 | |
Brèves mentions All and whole that plot or area of ground in the county of ay[r which is situate generally to the west of those houses and others as be on the western side of mcinway crescent, irvine (for full details see form 395). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Development agreement | Créé le 23 déc. 1987 Livré le 13 janv. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land at county oak adjoining london road crawley west sussex t/n wsx 113440. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0