FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED

FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01909445
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    81 Cromwell Road
    London
    SW7 5BW
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FAIRBRIAR DEVELOPMENTS LIMITED03 juin 199603 juin 1996
    FAIRBRIAR INVESTMENTS LIMITED04 sept. 198504 sept. 1985
    SWANMIGHT LIMITED29 avr. 198529 avr. 1985

    Quels sont les derniers comptes de FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Cessation de la nomination de Valsec Company Secretarial Services Limited en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 juin 2011

    État du capital au 16 juin 2011

    • Capital: GBP 101
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2010

    11 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Removal of share capital 23/12/2010
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Sect 551 ca 2006 23/12/2010
    RES13

    Certificat de changement de nom

    Company name changed fairbriar developments LIMITED\certificate issued on 19/01/11
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name19 janv. 2011

    Avis de changement de nom"

    CONNOT

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    État du capital après une attribution d'actions au 23 déc. 2010

    • Capital: GBP 100
    3 pagesSH01

    Cessation de la nomination de Valad Secretarial Services Limited en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Nomination de Valsec Company Secretarial Services Limited en tant que secrétaire

    3 pagesAP04

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2009

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Valad Secretarial Services Limited le 22 mai 2010

    2 pagesCH04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Dr Stanley Swee Han Quek le 01 oct. 2009

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon John Patrick Lear le 01 oct. 2009

    3 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2008

    13 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    2 pages288c

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2007

    12 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NG, Seng Khoon
    101 Coldershaw Road
    W13 9DU London
    Secrétaire
    101 Coldershaw Road
    W13 9DU London
    British90211410001
    LEAR, Simon John Patrick
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    Administrateur
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    United KingdomBritish138750860001
    QUEK, Stanley Swee Han, Dr
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    Administrateur
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    SingaporeSingaporean123800250001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Secrétaire
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    British812680001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Secrétaire
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    British812680001
    STAFFORD, Rodney Frank John
    8a The Glade
    KT22 9TH Fetcham
    Surrey
    Secrétaire
    8a The Glade
    KT22 9TH Fetcham
    Surrey
    British34094600001
    WRIGHT, Gordon Nicholson
    8 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    8 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British38011750001
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    Scotland
    Secrétaire
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    Scotland
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC219311
    133355520001
    VALSEC COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Secrétaire
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement7307485
    154199770001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Administrateur
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    UkBritish812680001
    COOMBES, William Frederick
    Windles
    Bangor Road North
    LL57 Ivor Heath
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Windles
    Bangor Road North
    LL57 Ivor Heath
    Buckinghamshire
    British18604620001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    HANKINSON, Derek William
    Foxlea Manor
    Dorneywood Road
    SL1 8PS Burnham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Foxlea Manor
    Dorneywood Road
    SL1 8PS Burnham
    Buckinghamshire
    British822380001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    NESBITT, Peter Victor
    76 Reedham Drive
    CR8 4DS Purley
    Surrey
    Administrateur
    76 Reedham Drive
    CR8 4DS Purley
    Surrey
    British27564990001
    PAIRMAN, Lynda Annette
    Ballagawne Cottage Ballagawne Road
    Colby
    IM9 4AZ Castletown
    Isle Of Man
    Administrateur
    Ballagawne Cottage Ballagawne Road
    Colby
    IM9 4AZ Castletown
    Isle Of Man
    British132910006
    VAN REYK, Philip
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    Administrateur
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    EnglandBritish76943220003
    WOOD-PENN, Richard Cecil
    3 Glebe Road
    Cogenhoe
    NN7 1NR Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    3 Glebe Road
    Cogenhoe
    NN7 1NR Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish99981260001
    WRIGHT, Gordon Nicholson
    8 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    8 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British38011750001

    FRASERS FB (UK) DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 19 août 1996
    Livré le 21 août 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property being part of the land comprised in title no. K555760. fixed charges on all buildings and other structures on the property, any goodwill, all plant machinery and other items affixed to the property and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property. Assignment of the rental sums. Floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or at the property.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Charge
    Créé le 31 janv. 1996
    Livré le 02 févr. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the beneficial interest in relation to the f/h property situate at and k/a home farm home farm lane tunbridge wells kent t/n k 446173.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 29 juin 1993
    Livré le 08 juil. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 18 juin 1990
    Livré le 20 juin 1990
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 juin 1990Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0