SCOTT WILSON PAVEMENT ENGINEERING LTD

SCOTT WILSON PAVEMENT ENGINEERING LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSCOTT WILSON PAVEMENT ENGINEERING LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01910469
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SCOTT WILSON PAVEMENT ENGINEERING LTD ?

    • (7499) /

    Où se situe SCOTT WILSON PAVEMENT ENGINEERING LTD ?

    Adresse du siège social
    Scott House
    Alencon Link
    RG21 7PP Basingstoke
    Hampshire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SCOTT WILSON PAVEMENT ENGINEERING LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SWK PAVEMENT ENGINEERING LIMITED01 mai 198501 mai 1985

    Quels sont les derniers comptes de SCOTT WILSON PAVEMENT ENGINEERING LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au02 mai 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour SCOTT WILSON PAVEMENT ENGINEERING LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 02 mai 2010

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 déc. 2010

    État du capital au 21 déc. 2010

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Geoffrey Michael Redwood le 09 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Geoffrey Howard French le 09 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Robert John Armitage le 09 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes établis au 03 mai 2009

    2 pagesAA

    legacy

    1 pages403a

    Comptes établis au 27 avr. 2008

    2 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages190

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages353

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    Comptes annuels établis au 29 avr. 2007

    24 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    Qui sont les dirigeants de SCOTT WILSON PAVEMENT ENGINEERING LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CARROLL, Nicola Margaret
    18 Littlefield Road
    GU34 2DJ Alton
    Hampshire
    Secrétaire
    18 Littlefield Road
    GU34 2DJ Alton
    Hampshire
    British98022820001
    ARMITAGE, Robert John
    NG9
    Administrateur
    NG9
    United KingdomBritish33519710001
    FRENCH, Geoffrey Howard
    58 Andover Road
    RG14 6JN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    58 Andover Road
    RG14 6JN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish42801040001
    REDWOOD, Geoffrey Michael
    17 Folly Lane North
    Hale
    GU9 0HU Farnham
    Surrey
    Administrateur
    17 Folly Lane North
    Hale
    GU9 0HU Farnham
    Surrey
    EnglandBritish4727540001
    REDWOOD, Geoffrey Michael
    17 Folly Lane North
    Hale
    GU9 0HU Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    17 Folly Lane North
    Hale
    GU9 0HU Farnham
    Surrey
    British4727540001
    BROWN, Stephen Frederick, Professor
    Hillcrest Willow Brook
    Stanton On The Wolds
    NG12 5BB Nottingham
    Administrateur
    Hillcrest Willow Brook
    Stanton On The Wolds
    NG12 5BB Nottingham
    United KingdomBritish41622360001
    CHAN, Francis Wai Kun, Dr
    17 Hatton Gardens
    Nuthall
    NG16 1QT Nottingham
    Administrateur
    17 Hatton Gardens
    Nuthall
    NG16 1QT Nottingham
    British84356530001
    COLLOP, Andrew Charles, Professor
    46 Seaford Avenue
    Wollaton
    NG8 1LB Nottingham
    Administrateur
    46 Seaford Avenue
    Wollaton
    NG8 1LB Nottingham
    United KingdomBritish65783230001
    DAVIS, Derek Hunt
    85 Grangewood Road
    Wollaton
    NG8 2FX Nottingham
    Administrateur
    85 Grangewood Road
    Wollaton
    NG8 2FX Nottingham
    British48503580001
    GREEN, Philip Arthur
    28 Manningford Close
    SO23 7EU Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    28 Manningford Close
    SO23 7EU Winchester
    Hampshire
    British3878900001
    HAWLEY, Robin William
    15 Richmond Drive
    WS14 9SZ Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    15 Richmond Drive
    WS14 9SZ Lichfield
    Staffordshire
    British87246210001
    INNES, Peter, Sir
    The Wheel House
    44 Nations Hill
    SO23 7QY Kingsworthy
    Hampshire
    Administrateur
    The Wheel House
    44 Nations Hill
    SO23 7QY Kingsworthy
    Hampshire
    British74509470001
    JENNISON, Christopher William
    Brook House Brookside
    East Leake
    LE12 6PB Loughborough
    Leicestershire
    Administrateur
    Brook House Brookside
    East Leake
    LE12 6PB Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish43585840001
    KEMP, William Ronald
    70 Chartwell Avenue
    Wingerworth
    S42 6SP Chesterfield
    Derbyshire
    Administrateur
    70 Chartwell Avenue
    Wingerworth
    S42 6SP Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritish43585680001
    MCKITTRICK, Robert Alexander
    15 The Dell
    S40 4DL Chesterfield
    Derbyshire
    Administrateur
    15 The Dell
    S40 4DL Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritish122415960001
    NUTT, John Lloyd
    The Old Forge
    8 George Street Kingsclere
    RG20 5NQ Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    The Old Forge
    8 George Street Kingsclere
    RG20 5NQ Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish33519740002
    ROBERTSON, Douglas William, Doctor
    The Limes 44 Church Street
    Long Bennington
    NG23 5EN Newark
    Nottinghamshire
    Administrateur
    The Limes 44 Church Street
    Long Bennington
    NG23 5EN Newark
    Nottinghamshire
    British41622150001
    WYNNE-JONES, Martin
    31 Ribblesdale Road
    NG5 3GY Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    31 Ribblesdale Road
    NG5 3GY Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish67098360001

    SCOTT WILSON PAVEMENT ENGINEERING LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 18 déc. 2002
    Livré le 02 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 17 mai 1995
    Livré le 07 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 29 mars 1994
    Livré le 19 avr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 19 avr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 oct. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0