CROWN CRUISERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCROWN CRUISERS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01913902
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CROWN CRUISERS LIMITED ?

    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe CROWN CRUISERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CROWN CRUISERS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour CROWN CRUISERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Application for striking off 13/05/2013
    RES13

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2011

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 mai 2012

    État du capital au 16 mai 2012

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Joyce Walter le 09 mai 2012

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2010

    3 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Joyce Walter le 24 juin 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs. Joyce Walter le 24 juin 2010

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr. Andrew Lloyd John le 21 juin 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr. Andrew Lloyd John le 17 juin 2010

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2009

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes établis au 30 sept. 2008

    3 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 30 sept. 2007

    3 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages225

    Qui sont les dirigeants de CROWN CRUISERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WALTER, Joyce
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    Secrétaire
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    BritishChartered Secretary76169540002
    JOHN, Andrew Lloyd
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    Administrateur
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    United KingdomBritishLawyer75467790004
    WALTER, Joyce
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    Administrateur
    Tui Travel House
    Crawley Business Quarter
    RH10 9QL Fleming Way, Crawley
    West Sussex
    United KingdomBritishChartered Secretary76169540003
    BAKER, Christopher Paul
    19 Hillrise Close
    Worlingham
    NR34 7BS Beccles
    Suffolk
    Secrétaire
    19 Hillrise Close
    Worlingham
    NR34 7BS Beccles
    Suffolk
    British1529460001
    STARLING, Rebecca Jean Godwin
    11 Rossdale Road
    Putney
    SW15 1AD London
    Secrétaire
    11 Rossdale Road
    Putney
    SW15 1AD London
    BritishSolicitor45381850004
    CARTER, John Richard
    Woodrow House
    Cawston
    NR10 4HS Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Woodrow House
    Cawston
    NR10 4HS Norwich
    Norfolk
    BritishCompany Director1529470001
    CRONIN, Karon Michelle
    19 Bernard Avenue
    East Cosham
    PO6 2JP Portsmouth
    Hants
    Administrateur
    19 Bernard Avenue
    East Cosham
    PO6 2JP Portsmouth
    Hants
    BritishCompany Director115600890001
    DANIELS, Trevor John Mervyn
    20 Blackberry Way
    Oulton Broad
    NR32 3HF Lowestoft
    Suffolk
    Administrateur
    20 Blackberry Way
    Oulton Broad
    NR32 3HF Lowestoft
    Suffolk
    EnglishBoatyard Manager2170530001
    GORDON, Christopher Richard Chesterfield
    Trentham House 4 Tower Street
    PO10 7BH Emsworth
    Hampshire
    Administrateur
    Trentham House 4 Tower Street
    PO10 7BH Emsworth
    Hampshire
    United KingdomBritishCompany Director12726190001
    GREEN, Rupert John Henry
    Honer House
    Honer Lane, South Mundham
    PO20 1LZ Chichester
    West Sussex
    Administrateur
    Honer House
    Honer Lane, South Mundham
    PO20 1LZ Chichester
    West Sussex
    United KingdomBritishCommercial Director109770810001
    GREGORY, Keith
    The Old Rectory
    Ringsfield
    NR34 8JU Beccles
    Suffolk
    Administrateur
    The Old Rectory
    Ringsfield
    NR34 8JU Beccles
    Suffolk
    United KingdomBritishCompany Director29508740001
    HOWARD, Andrew Geoffrey David
    The Great Oast
    Steep Marsh
    GU32 2BN Hampshire
    Administrateur
    The Great Oast
    Steep Marsh
    GU32 2BN Hampshire
    BritishDirector96200870001
    HOWELL, David
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishDirector109591300001
    JENKINS, Nigel John
    Coombe Cross St Hill Road
    RH19 4JU East Grinstead
    Administrateur
    Coombe Cross St Hill Road
    RH19 4JU East Grinstead
    EnglandBritishCompany Director24257330001
    PRIOR, Mathew Roger
    6 Princes Square
    BN3 4GE Hove
    East Sussex
    Administrateur
    6 Princes Square
    BN3 4GE Hove
    East Sussex
    EnglandBritishDirector81379530003
    ROBINSON, John Lee
    The Village House
    High Street
    CB11 3PF Newport
    Essex
    Administrateur
    The Village House
    High Street
    CB11 3PF Newport
    Essex
    BritishFinance Director115663640001
    THOMAS, Hywel David
    Orchard House
    102 Church Road
    KT4 7RZ Worcester Park
    Surrey
    Administrateur
    Orchard House
    102 Church Road
    KT4 7RZ Worcester Park
    Surrey
    EnglandBritishAccountant59274640002
    WATLING, Geoffrey Charles
    8 Ber Street
    NR1 3EJ Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    8 Ber Street
    NR1 3EJ Norwich
    Norfolk
    BritishCompany Director3634140001

    CROWN CRUISERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture between the company crown blue line limited and crown holidays limited and bhf-bank ag
    Créé le 26 juil. 2000
    Livré le 03 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    In favour of the chargee all monies and liabilities due owing or incurred on 26 july 2000 or thereafter by any company (as defined) under the terms of the facility agreement
    Brèves mentions
    Payment to the chargee of the indebtedness with full title guarantee all the freehold and leasehold property together with all buildings and fixtures. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bhf-Bank Ag
    Transactions
    • 03 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 janv. 1997
    Livré le 30 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral debenture
    Créé le 14 févr. 1995
    Livré le 21 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 21 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 nov. 1994
    Livré le 13 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Piece of land at somerleyton k/a crown boatyard together with the wherry dyke and staithe cottage and land adjoining suffolk.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 nov. 1994
    Livré le 13 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on south side of staithe lane somerleyton suffolk t/n SK116406.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 09 nov. 1990
    Livré le 20 nov. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 nov. 1990Enregistrement d'une charge
    • 18 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 nov. 1990
    Livré le 15 nov. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from crown holidays limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Stock-in-trade work-in-progress prepayments & investments. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 15 nov. 1990Enregistrement d'une charge
    • 27 nov. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 11 mai 1990
    Livré le 17 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 18 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 18 avr. 1988
    Livré le 22 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 18 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0