STAR ENERGY HOLDINGS LIMITED

STAR ENERGY HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTAR ENERGY HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01915605
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STAR ENERGY HOLDINGS LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe STAR ENERGY HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Pearl Assurance House
    319 Ballards Lane
    N12 8LY London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STAR ENERGY HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PENTEX ENERGY LIMITED20 mai 199720 mai 1997
    MELROSE ENERGY PLC03 mars 199503 mars 1995
    CROSSROADS OIL GROUP PLC15 juin 198915 juin 1989
    LYSANDER PETROLEUM PLC18 juin 198518 juin 1985
    FEYGRAN PUBLIC LIMITED COMPANY21 mai 198521 mai 1985

    Quels sont les derniers comptes de STAR ENERGY HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2006

    Quels sont les derniers dépôts pour STAR ENERGY HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 janv. 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 juil. 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 janv. 2010

    5 pages4.68

    legacy

    1 pages287

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolution d'insolvabilité

    Resolution INSOLVENCY:Special Resolution "in specie"
    1 pagesLIQ MISC RES

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 12 janv. 2009

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages225

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages287

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    11 pagesAA

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages363a

    Qui sont les dirigeants de STAR ENERGY HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JUDD, Colin
    3a Cambridge Park
    TW1 2PF Twickenham
    Secrétaire
    3a Cambridge Park
    TW1 2PF Twickenham
    BritishCompany Director51885630008
    JUDD, Colin
    3a Cambridge Park
    TW1 2PF Twickenham
    Administrateur
    3a Cambridge Park
    TW1 2PF Twickenham
    United KingdomBritishCompany Director51885630008
    WESSEL, Roland Wessel
    30 Canonbury Square
    Islington
    N1 2AL London
    Administrateur
    30 Canonbury Square
    Islington
    N1 2AL London
    United KingdomUk / NetherlandsCompany Director97115180002
    BARLOW, Julie
    The Orchard
    Cross Street, Sturton-Le-Steeple
    DN22 9HL Retford
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    The Orchard
    Cross Street, Sturton-Le-Steeple
    DN22 9HL Retford
    Nottinghamshire
    BritishFinancial Controller65066120004
    HARRISON, Andrew
    13 Ranelagh Villas
    BN3 6HE Hove
    East Sussex
    Secrétaire
    13 Ranelagh Villas
    BN3 6HE Hove
    East Sussex
    BritishCompany Secretary2356800003
    MANDERSON, Michael Lindsay
    25 Newlands
    EH27 8LR Kirknewton
    Midlothian
    Secrétaire
    25 Newlands
    EH27 8LR Kirknewton
    Midlothian
    BritishChartered Accountant67433260001
    PENDOCK, Simon Barry
    80 Rivermead Court
    Ranelagh Gardens
    SW6 3RZ London
    Secrétaire
    80 Rivermead Court
    Ranelagh Gardens
    SW6 3RZ London
    British35339250001
    ADAIR, Robert Fredrik Martin
    31 Pembroke Square
    W8 6PB London
    Administrateur
    31 Pembroke Square
    W8 6PB London
    BritishFinancier37096760001
    BARDSLEY, Stanford
    3951 Lares Way
    Salt Lake City Utah
    FOREIGN
    Usa
    Administrateur
    3951 Lares Way
    Salt Lake City Utah
    FOREIGN
    Usa
    AmericanCompany Director3716310001
    CAMERON, Henry Ogilvy
    20 Wellbrae Terrace
    AB15 7XY Aberdeen
    Scotland
    Administrateur
    20 Wellbrae Terrace
    AB15 7XY Aberdeen
    Scotland
    BritishSolicitor179510001
    DOWLAND, Graham Rochford
    31 Doneraile Street
    SW6 6EL London
    Administrateur
    31 Doneraile Street
    SW6 6EL London
    AustralianFinance Director61833670003
    GRAHAM, Jeffrey Gilles
    The Old Barn
    Drake Holes
    DN10 5DF Doncaster
    South Yorkshire
    Administrateur
    The Old Barn
    Drake Holes
    DN10 5DF Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritishManaging Director78944540001
    GUINNESS, William Loel Seymour
    10 Bourne Street
    SW1W 8JU London
    Administrateur
    10 Bourne Street
    SW1W 8JU London
    BritishCompany Director34271080001
    HARRISON, Andrew
    13 Ranelagh Villas
    BN3 6HE Hove
    East Sussex
    Administrateur
    13 Ranelagh Villas
    BN3 6HE Hove
    East Sussex
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)BritishCompany Secretary2356800003
    HARRISON JNR, Frank
    P O Box 51943
    Lafayette Louisiana 70505
    FOREIGN
    Usa
    Administrateur
    P O Box 51943
    Lafayette Louisiana 70505
    FOREIGN
    Usa
    AmericanGeologist15097540001
    JORDAN, Russell Rodger
    3 Newlands
    EH27 8LR Kirknewton
    Midlothian
    Administrateur
    3 Newlands
    EH27 8LR Kirknewton
    Midlothian
    ScotlandBritishDirector70003620002
    LANE, George
    11e/1 Ravelston Park
    EH4 3DX Edinburgh
    Administrateur
    11e/1 Ravelston Park
    EH4 3DX Edinburgh
    BritishCompany Director19070490001
    PENDOCK, Simon Barry
    80 Rivermead Court
    Ranelagh Gardens
    SW6 3RZ London
    Administrateur
    80 Rivermead Court
    Ranelagh Gardens
    SW6 3RZ London
    BritishCompany Director35339250001
    SOENDERUP, Mogens
    Ryvangs Alle 26
    8240 Risskov
    FOREIGN
    Denmark
    Administrateur
    Ryvangs Alle 26
    8240 Risskov
    FOREIGN
    Denmark
    DanishCompany Director15097550001
    SURTEES, Anthony Conyers
    Potters Hatch House
    Crondall
    GU10 5PW Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Potters Hatch House
    Crondall
    GU10 5PW Farnham
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director18075560001
    THORUP, Alvin Robert
    400 Deret Building
    Salt Lake City Utah
    FOREIGN
    Usa
    Administrateur
    400 Deret Building
    Salt Lake City Utah
    FOREIGN
    Usa
    AmericanLawyer15097560001
    WEST, Andrew Thomas
    4 Filkins Hall
    Filkins
    GL7 3JJ Lechdale
    Gloucestershire
    Administrateur
    4 Filkins Hall
    Filkins
    GL7 3JJ Lechdale
    Gloucestershire
    United KingdomBritishInvestment Banker79568920001

    STAR ENERGY HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed and floating security document
    Créé le 08 août 2005
    Livré le 15 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly k/a pentex energy limited to the finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The present real property; future real property; other assets; by way of first floating charge, its undertaking and all its assets, both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V. as Security Trustee for the Benefit of the Finance Parties (The Securitytrustee)
    Transactions
    • 15 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Scottish laws pledge
    Créé le 05 août 2005
    Livré le 15 août 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due fro the comapny to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Right title interest and benefit in and to the pledged securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V as Security Trustee for the Benefit of the Finance Parties (The Securitytrustee)
    Transactions
    • 15 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Shares pledge
    Créé le 17 mai 2002
    Livré le 30 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The pledged securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 mai 2002
    Livré le 30 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 mars 2002
    Livré le 09 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Shares pledge
    Créé le 29 févr. 2000
    Livré le 18 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilitiy of pentex oil PLC,pentex oil UK limited,pentex oil & gas limited and pentex italia limited (the borrowers) and the company to the chargee for itself and as trustee for and on behalf of the banks (as defined) and to the banks (or any of them) under the charge and pursuant to the agreement and under any security document and/or any deed supplemental thereto
    Brèves mentions
    20,034,840 fully paid ordinary shares of 10 pence each in the capial of pentex oil PLC and all other securities of every kind which may at any time directly or indirectly be derived fron any kind of the said shares whether by way of bonus,rights,exchange,option,preference,capital re-organisation or otherwise all monies and assets whatsoever.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 févr. 1998
    Livré le 11 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility documents (as defined)
    Brèves mentions
    Right title and interest in to and under the proceeds of the rights issue the provisional allotment letters,receiving bank account,any balance and the underwriting agreement and sub underwriting arrangements. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Strand Associates Limited
    Transactions
    • 11 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment of the investment agreement (dated 5TH september 1996)
    Créé le 05 sept. 1996
    Livré le 14 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The aggregate of all present and/or future actual and/or contingent liabilities (in whatever currency they may be expressed) of the company and rowebury PLC to the chargee (whether incurred solely, severally or jointly with others and whether incurred as principal or surety) together with any commissions and legal and other expenses incurred, in each case, under the us $20,000,000 loan agreement dated 5TH september 1996 (as therein defined)
    Brèves mentions
    All its rights, title and interest in and to the investment agreement dated 5TH september 1996. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Chase Manhattan Bank
    Transactions
    • 14 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment of a placing agreement (dated 5TH september 1996)
    Créé le 05 sept. 1996
    Livré le 14 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The aggregate of all present and/or future actual and/or contingent liabilities (in whatever currency they may be expressed) of the company to the chargee (whether incurred solely, severally or jointly with others and whether incurred as principal or surety) together with any interest accrued in respect of such liabilities and all charges, commisions and legal and other expenses incurred, in each case, under the us $20,000,000 loan agreement dated 5TH september 1996 (as therein defined)
    Brèves mentions
    All the company's rights title and interest in and to the placing agreement dated 5TH september 1996. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Chase Manhattan Bank
    Transactions
    • 14 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignation in security
    Créé le 19 janv. 1996
    Livré le 31 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations of the company to the chargee under clauses 2(2) c and 11(3) of the charge together with all obligations to indemnify the chargee
    Brèves mentions
    All right title benefit and interest in and to the account (see form 395 for definition) the deposit and all other balances and any agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    STAR ENERGY HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    12 janv. 2009Commencement of winding up
    20 juil. 2011Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David Rubin
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London
    practitioner
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0