ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED

ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01917732
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED ?

    • Autres travaux de construction spécialisés n.d.a. (43999) / Construction

    Où se situe ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    West Point
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HAYVERN LIMITED27 juil. 198727 juil. 1987
    HAYVERN CONSTRUCTION LIMITED30 mai 198530 mai 1985

    Quels sont les derniers comptes de ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2013
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2014
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 déc. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 juin 2016

    11 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 juin 2015

    9 pages4.68

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Changement d'adresse du siège social de Lancaster House Centurion Way Leyland Lancashire PR26 6TX à West Point Old Trafford Manchester M16 9HU le 18 juil. 2014

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 26 juin 2014

    LRESSP

    Nomination de Mr Andrew Michael Eastwood en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Paul Birch en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Nelson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Melvyn Ewell en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 févr. 2014

    État du capital au 11 févr. 2014

    • Capital: GBP 441,001
    SH01

    Comptes annuels établis au 28 déc. 2012

    12 pagesAA

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Nomination de Sherard Secretariat Services Limited en tant que secrétaire

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Paul Birch en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de David Foster en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Melvyn Ewell en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Andrew Latham Nelson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ian Fraser en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Arnold en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de John Flood en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Secrétaire
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5615519
    109588620001
    BIRCH, Paul
    Lancashire Enterprise Business Park
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    England
    Administrateur
    Lancashire Enterprise Business Park
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    England
    EnglandBritishDirector76116640003
    EASTWOOD, Andrew Michael
    Lancashire Enterprise Business Park
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    England
    Administrateur
    Lancashire Enterprise Business Park
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    England
    EnglandBritishDirector160883820001
    BIRCH, Paul
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    British76116640002
    DUNN, Brian
    Highbank
    Fleet Street, Horwich
    BL6 6BD Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    Highbank
    Fleet Street, Horwich
    BL6 6BD Bolton
    Lancashire
    British27826460002
    GAVAN, John Vincent
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    Secrétaire
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    BritishSolicitor36153790001
    ARNOLD, David Llewelyn
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Finance Director181213200001
    ATHERTON, Paul Taylor
    44 Molyneux Road
    BL5 3HP Westhoughton
    Lancashire
    Administrateur
    44 Molyneux Road
    BL5 3HP Westhoughton
    Lancashire
    United KingdomBritishBuilder82322300001
    BILLINGTON, David
    55 Molyneux Road
    Westhoughton
    BL5 3UJ Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    55 Molyneux Road
    Westhoughton
    BL5 3UJ Bolton
    Lancashire
    BritishBuilder27826470001
    BIRCH, Iain Harvey
    4 Eton Park
    PR2 9NL Preston
    Lancashire
    Administrateur
    4 Eton Park
    PR2 9NL Preston
    Lancashire
    EnglandBritishCommercial Manager116126370001
    COLLINS, John
    Copse Haven
    Roundhill Road
    DL2 1QD Hurworth
    County Durham
    Administrateur
    Copse Haven
    Roundhill Road
    DL2 1QD Hurworth
    County Durham
    BritishSales & Marketing Director95036480001
    DUNN, Brian
    Highbank
    Fleet Street, Horwich
    BL6 6BD Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    Highbank
    Fleet Street, Horwich
    BL6 6BD Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishAccountant27826460002
    DUNN, Lorraine
    56 Colchester Drive
    Farnworth
    BL4 0LU Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    56 Colchester Drive
    Farnworth
    BL4 0LU Bolton
    Lancashire
    BritishSecretary27826490001
    DUNN, Philip
    56 Colchester Drive
    Farnworth
    BL4 0LU Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    56 Colchester Drive
    Farnworth
    BL4 0LU Bolton
    Lancashire
    BritishBuilder27826480001
    ENTWISTLE, Keith Roy
    2 Cobden Street
    Egerton
    BL7 9SX Bolton
    Administrateur
    2 Cobden Street
    Egerton
    BL7 9SX Bolton
    BritishChartered Surveyor51587490001
    EWELL, Melvyn
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Administrateur
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    EnglandBritishCeo61515760002
    FLOOD, John Joseph
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector73695830003
    FOSTER, David Neil
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector79227590003
    FRASER, Ian Ellis
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    ScotlandUkChief Executive28393850006
    GAVAN, John Vincent
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritishSolicitor36153790001
    GAVAN, John Vincent
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritishSolicitor36153790001
    JOYCE, Martin John
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector72254420003
    KEOGH, Sean
    Whitehead Farm
    650 Whittingham Lane Goosnargh
    PR3 2JJ Preston
    Lancashire
    Administrateur
    Whitehead Farm
    650 Whittingham Lane Goosnargh
    PR3 2JJ Preston
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector123405900001
    KIRKBY, Neil Robert Ernest
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director51438040006
    LAVERY, Kevin Gregory
    Old Colony House
    6, South King Street
    M2 6DQ Manchester
    Administrateur
    Old Colony House
    6, South King Street
    M2 6DQ Manchester
    United KingdomBritishDirector115961810003
    MALONEY, John Gerard
    10 Pendle Hill
    Grimsargh
    PR2 5BG Preston
    Lancashire
    Administrateur
    10 Pendle Hill
    Grimsargh
    PR2 5BG Preston
    Lancashire
    IrishChief Operating Officer96964980001
    MCGRORY, Jack
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishChief Executive Officer96596920001
    MCINNES, Randolf Graham
    Journeys End
    Werneth Low
    SK14 3AF Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    Journeys End
    Werneth Low
    SK14 3AF Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishAccountant100684180001
    MCLAUGHLIN, Owen Gerard
    Lancaster House
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancashire
    Administrateur
    Lancaster House
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector17129800004
    NELSON, Andrew Latham
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Administrateur
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    United KingdomBritishFinance Director36191090003
    NEWSOME, William
    36 Burghley Drive
    Bradley Fold
    M26 3XY Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    36 Burghley Drive
    Bradley Fold
    M26 3XY Bolton
    Lancashire
    BritishDirector84941580001
    O'MALLEY, Desmond Francis
    261 Didsbury Road
    Heaton Mersey
    SK4 3JG Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    261 Didsbury Road
    Heaton Mersey
    SK4 3JG Stockport
    Cheshire
    BritishDirector55097840001
    O'MALLEY, Eammon
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    Administrateur
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    BritishDirector25364820002
    PARKER, Gary
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director50372730001
    ROULSTONE, Graham Frank
    Cedar Farm Stone Lane
    Burringham
    DN17 3ND Scunthorpe
    North Lincs
    Administrateur
    Cedar Farm Stone Lane
    Burringham
    DN17 3ND Scunthorpe
    North Lincs
    EnglandBritishIt Director112257690001

    ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 18 mai 2007
    Livré le 31 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 31 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession to a composite guarantee and mortgage debenture dated 21 august 2000 (the "debenture deed of accession")
    Créé le 01 nov. 2001
    Livré le 02 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys obligations and liabilities for the time due owing or incurred by the obligors (as defined therein) or any of them to any of the beneficiaries (as defined therein) including without limitation all moneys obligations and liabilities for the time being due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the financing documents (as defined) and/or on any other account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee Forand on Behalf of the Beneficaries (As Each Termis Defined in the Debenture Deed of Accession)
    Transactions
    • 02 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage
    Créé le 06 mars 2000
    Livré le 08 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H premises at queen street/ gas street farnworth bolton greater manchester. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 08 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Commercial property security deed
    Créé le 05 mai 1999
    Livré le 12 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H- queen street,farnworth,bolton and land and buildings on the west side of gas street farnworth bolton greater manchester.t/nos GM686096 and GM265102.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 12 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge deed
    Créé le 10 juil. 1990
    Livré le 19 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The performance of the companies obligations to robert heyworth group limited under the agreement dated 28/6/90 and in the charge deed.
    Brèves mentions
    The sum of fifty thousand pounds placed on deposit at national westminster bank 46 market street chorley lancs.
    Personnes ayant droit
    • Robert Heyworth Group Limited
    Transactions
    • 19 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 11 févr. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 12 sept. 1988
    Livré le 15 sept. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Stocks shares other securities. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Tsb England & Wales PLC
    Transactions
    • 15 sept. 1988Enregistrement d'une charge
    • 09 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    26 juin 2014Commencement of winding up
    11 janv. 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Beverley Ellice Budsworth
    The Debt Advisor West Point 501 Chester Road
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    practitioner
    The Debt Advisor West Point 501 Chester Road
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0