COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01917810 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED ?
| Adresse du si ège social | One Canada Square Canary Wharf E14 5AP London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 27 déc. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 mars 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 27 déc. 2020 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 mars 2021 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 29 déc. 2019 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 mars 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 déc. 2018 | 4 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr James Joseph Mullen en tant qu'administrateur le 16 août 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Richard Fox en tant que directeur le 16 août 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Jeremy Ian Fuller en tant qu'administrateur le 01 mars 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Vijay Lakhman Vaghela en tant que directeur le 01 mars 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 4 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur T M Directors Limited le 04 mai 2018 | 1 pages | CH02 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire T M Secretaries Limited le 04 mai 2018 | 1 pages | CH04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 01 janv. 2017 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 27 déc. 2015 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 déc. 2014 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REACH SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Canada Square Canary Wharf E14 5AP London One United Kingdom |
| 82853180002 | ||||||||||
| FULLER, Simon Jeremy Ian | Administrateur | Canary Wharf E14 5AP London One Canada Square United Kingdom | England | British | 181763320002 | |||||||||
| MULLEN, James Joseph | Administrateur | One Canada Square Canary Wharf E14 5AP London | England | Scottish | 91567460002 | |||||||||
| REACH DIRECTORS LIMITED | Administrateur | Canada Square Canary Wharf E14 5AP London One United Kingdom |
| 82853130002 | ||||||||||
| APPLETON, David Neil | Secrétaire | 2 Colledge Close Brinklow CV23 0NT Coventry Warwickshire | British | 52329620001 | ||||||||||
| PAYNE, Carolyn Sarah | Secrétaire | 37 Whitecroft Road B26 3RD Birmingham | British | 44120670001 | ||||||||||
| VICKERS, Paul Andrew | Secrétaire | 10 Pembroke Villas The Green TW9 1QF Richmond-Upon-Thames Surrey | British | 146096300001 | ||||||||||
| WHITEHOUSE, John | Secrétaire | 231 Streetsbrook Road B91 1HE Solihull West Midlands | British | 39146610002 | ||||||||||
| AITKEN, Geraldine | Administrateur | 1 Clydesdale Court Kings Lane CV37 0LZ Snitterfield Warwickshire | British | 73882830001 | ||||||||||
| ALLWOOD, Charles John | Administrateur | Park Farm The Twist Wigginton HP23 6DU Tring Hertfordshire | England | British | 35681240003 | |||||||||
| APPLETON, David Neil | Administrateur | 2 Colledge Close Brinklow CV23 0NT Coventry Warwickshire | British | 52329620001 | ||||||||||
| BURTON, Royston Walter | Administrateur | 89 Corbett Road Hollywood B47 5LT Birmingham | British | 44120740001 | ||||||||||
| DAY, Philip Julian | Administrateur | 42 Heath Croft Road B75 6RW Sutton Coldfield West Midlands | British | 14092200001 | ||||||||||
| EWING, Margaret | Administrateur | Maraval Hamm Court KT13 8YG Weybridge Surrey | British | 68009020001 | ||||||||||
| FOX, Simon Richard | Administrateur | One Canada Square Canary Wharf E14 5AP London | United Kingdom | British | 58101280002 | |||||||||
| HADDOW, Andrew David Charles | Administrateur | 68 Pinewoods Avenue Hagley DY9 0JF Stourbridge West Midlands | British | 54060210001 | ||||||||||
| HUTCHBY, Michael | Administrateur | 26 Sunnyhill LE10 2SB Hinckley Leicestershire | British | 61630410001 | ||||||||||
| KIRBY, Alan Alwyne | Administrateur | 48 Bawnmore Road Bilton CV22 7QW Rugby Warwickshire | United Kingdom | British | 148157770001 | |||||||||
| LESTER, Vernon David Walter | Administrateur | 26 East Mount Road YO2 2BD York North Yorkshire | British | 51985920001 | ||||||||||
| MASON, Daniel Cavner | Administrateur | 72 Church Road Erdington B24 9BD Birmingham | British | 38365090002 | ||||||||||
| OAKLEY, Christopher John | Administrateur | Random Wood Ling Lane, Scarcroft LS14 3HY Leeds West Yorkshire | British | 68410390001 | ||||||||||
| PAYNE, Carolyn Sarah | Administrateur | 37 Whitecroft Road B26 3RD Birmingham | British | 44120670001 | ||||||||||
| POWLES, Sharon Susan | Administrateur | Thurleycroft Common Lane, Mappleborough Green B80 7DP Studley Warwickshire | British | 108225810001 | ||||||||||
| VAGHELA, Vijay Kumar Lakhman Meghji | Administrateur | One Canada Square Canary Wharf E14 5AP London | England | British | 60412210002 | |||||||||
| VICKERS, Paul Andrew | Administrateur | One Canada Square Canary Wharf E14 5AP London | England | British | 146096300001 | |||||||||
| VICKERS, Paul Andrew | Administrateur | 10 Pembroke Villas The Green TW9 1QF Richmond-Upon-Thames Surrey | England | British | 146096300001 | |||||||||
| WELLS, Stephen David | Administrateur | 7 Jacksons Meadow Bidford On Avon B50 4HQ Alcester Warwickshire | British | 53321720002 | ||||||||||
| WEST, Denise May | Administrateur | 642 Streetsbrook Road B91 1LB Solihull West Midlands | British | 52930570001 | ||||||||||
| WHITEHOUSE, John | Administrateur | 231 Streetsbrook Road B91 1HE Solihull West Midlands | British | 39146610002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Hinckley Times Limited | 06 avr. 2016 | Canary Wharf E14 5AP London One Canada Square England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
COVENTRY NEWSPAPERS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 16 mars 1990 Livré le 20 mars 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due to the banks or any of them or standard chartered bank for itself and as agent and trustee for the banks by midland newspapers limited under the facility agreement dated 2/3/90 or by the company pursuant to a guarantee dated 16/3/90 made in favour of the agent or by midland or any guarantor (as defined) under any financing documents (as defined) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery (for full details see form 395) see 395 for details. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0