BCP REALISATIONS (2008) LIMITED

BCP REALISATIONS (2008) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBCP REALISATIONS (2008) LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01919060
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BCP REALISATIONS (2008) LIMITED ?

    • (2661) /
    • (2666) /

    Où se situe BCP REALISATIONS (2008) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BCP REALISATIONS (2008) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BISON CONCRETE PRODUCTS LIMITED31 déc. 199531 déc. 1995
    BISON FLOORS LIMITED20 janv. 198920 janv. 1989
    BISON LIMITED18 juil. 198518 juil. 1985
    MASTEREX LIMITED04 juin 198504 juin 1985

    Quels sont les derniers comptes de BCP REALISATIONS (2008) LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2007
    Date d'échéance des prochains comptes31 oct. 2008
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2006

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BCP REALISATIONS (2008) LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au04 oct. 2016
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation18 oct. 2016
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BCP REALISATIONS (2008) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour BCP REALISATIONS (2008) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Restauration par ordonnance du tribunal

    2 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Cessation de la nomination de Colin Richardson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 27 août 2010

    3 pages3.6

    legacy

    1 pagesLQ02

    legacy

    1 pagesLQ02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 21 oct. 2009

    4 pages3.6

    Certificat modifié de constitution du comité des créanciers

    1 pages3.4

    Rapport du séquestre administratif

    87 pages3.10

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    legacy

    2 pages405(1)

    Certificat de changement de nom

    Company name changed bison concrete products LIMITED\certificate issued on 23/10/08
    3 pagesCERTNM

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de BCP REALISATIONS (2008) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BURNESS LLP
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secrétaire
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    99448920001
    BRACEGIRDLE, Stephen James
    Well Lane
    NP16 6RA Llanvair Discded
    Village Farm Court
    South Monmouthshire
    Administrateur
    Well Lane
    NP16 6RA Llanvair Discded
    Village Farm Court
    South Monmouthshire
    United KingdomBritishChief Executive Officer130013500001
    BURFORD, Christopher Stuart
    The Royd
    40 Duchy Road
    HG1 2ER Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    The Royd
    40 Duchy Road
    HG1 2ER Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant78941130002
    MITCHELL, David
    Balgray
    66 Williams Way
    WD7 7HB Radlett
    Hertfordshire
    Administrateur
    Balgray
    66 Williams Way
    WD7 7HB Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant92280130001
    WRIGHT, Gordon Nicholson
    8 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    8 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British38011750001
    CLUCAS, Alan Donald
    1 Cawthorpe Lodge
    Cawthorpe
    PE10 0AB Bourne
    Lincolnshire
    Administrateur
    1 Cawthorpe Lodge
    Cawthorpe
    PE10 0AB Bourne
    Lincolnshire
    EnglandBritishCompany44016220001
    CRANE, Anthony Charles
    The Ramblers Bank Road
    Penn
    HP10 8LA High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Ramblers Bank Road
    Penn
    HP10 8LA High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishTechnical Director51055880003
    HANKINSON, Derek William
    Foxlea Manor
    Dorneywood Road
    SL1 8PS Burnham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Foxlea Manor
    Dorneywood Road
    SL1 8PS Burnham
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director822380001
    HOBBS, Ronald Robert Collins
    Blue Hills
    Yalding Hill
    ME18 6AN Yalding
    Kent
    Administrateur
    Blue Hills
    Yalding Hill
    ME18 6AN Yalding
    Kent
    BritishCompany Director9643470002
    KELLY, Peter
    9 Derwent Gardens
    LE65 1HJ Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Administrateur
    9 Derwent Gardens
    LE65 1HJ Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    BritishChartered Structural Engineer63823970001
    LOMAS, Robert Edwin
    Birkrigg Wynnswick Road
    Seer Green
    HP9 2XW Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Birkrigg Wynnswick Road
    Seer Green
    HP9 2XW Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director3536140001
    NELSON, Michael John
    Millbrook House
    Mill Lane, Hanwood
    SY5 8LT Shrewsbury
    Shropshire
    Administrateur
    Millbrook House
    Mill Lane, Hanwood
    SY5 8LT Shrewsbury
    Shropshire
    BritishChartered Quantity Surveyor63823910002
    PAGE, Kenneth Ernest
    57 Sandcliffe Road
    Midway
    DE11 7PH Swadlincote
    Derbyshire
    Administrateur
    57 Sandcliffe Road
    Midway
    DE11 7PH Swadlincote
    Derbyshire
    BritishCommercial Director51055750001
    PAIRMAN, Lynda Annette
    Ballagawne Cottage Ballagawne Road
    Colby
    IM9 4AZ Castletown
    Isle Of Man
    Administrateur
    Ballagawne Cottage Ballagawne Road
    Colby
    IM9 4AZ Castletown
    Isle Of Man
    BritishSolicitor/Company Director132910006
    RICHARDSON, Colin Charles
    29a Coventry Road
    CV34 5HN Warwick
    Warwickshire
    Administrateur
    29a Coventry Road
    CV34 5HN Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritishCommercial Director112531390001
    STICKLAND, David John
    12 Mitchells Close
    DE3 0UH Etwall
    Derbyshire
    Administrateur
    12 Mitchells Close
    DE3 0UH Etwall
    Derbyshire
    BritishDirector104243260003
    SWARBRECK, Alan
    4 Chatsworth
    B79 7SJ Tamworth
    Staffordshire
    Administrateur
    4 Chatsworth
    B79 7SJ Tamworth
    Staffordshire
    BritishFinance Director51055660001
    TREANOR, Terence Malcolm
    6 Mill End Lane
    Alrewas
    DE13 7BX Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    6 Mill End Lane
    Alrewas
    DE13 7BX Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishCompany Director822550002
    WALKER, Robert James
    20 Saxton Drive
    Four Oaks
    B74 4XZ Sutton Coldfield
    Administrateur
    20 Saxton Drive
    Four Oaks
    B74 4XZ Sutton Coldfield
    BritishPlanning Director51055610002
    WHEELER, Paul Alexander
    31 Milverton Road
    Knowle
    B93 0HX Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    31 Milverton Road
    Knowle
    B93 0HX Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishFinance Director69587660002
    WRIGHT, Gordon Nicholson
    8 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    8 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director38011750001

    BCP REALISATIONS (2008) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 25 sept. 1997
    Livré le 10 oct. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the finance documents
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee
    Transactions
    • 10 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 oct. 2008Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (405 (1))
    • 109 sept. 2010Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (LQ02)
    • 110 sept. 2010Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (LQ02)
      • Numéro de dossier 1
    Letter of offset
    Créé le 30 déc. 1991
    Livré le 13 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from wjb (261) limited and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    The balances at the credit of any accounts held by the governor and company of the royal bank of scotland in name of those companies named in theschedule annexed to the 395.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 déc. 1991
    Livré le 13 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    New security agreement
    Créé le 12 juil. 1991
    Livré le 22 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The liabilities (as defined)
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage the real property described- schedule 2 of the form 395 opposite its name and all other real property in england & wales now belonging to it, together with all other particulars as detailed (see doc M395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Bank Limited as Trustee for the Secured Creditors (As Defined)
    Transactions
    • 22 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 27 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Instrument of charge
    Créé le 25 sept. 1989
    Livré le 12 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All present and fixture credit balances , and all rights thereof (see doc M261 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Bank Limited(As Trustee for the Banks)
    Transactions
    • 12 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    • 27 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 25 sept. 1989
    Livré le 06 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transactions
    • 06 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    • 27 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 29 sept. 1988
    Livré le 13 oct. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from lankscroft limited and/or overdroft borravers, under the facility agreement, and/or any charging company under the security agreement or other seacurity document, the bs bond facility and the bs overdroft facility to barclays bank PLC as trustee for the secure & creditors (and all other persons from time to time the trustee or trustee for the secured creditors on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    (See doc M263 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 oct. 1988Enregistrement d'une charge
    Floating charge
    Créé le 22 nov. 1985
    Livré le 11 déc. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £700,000
    Brèves mentions
    Floating charge over the whole of the undertaking and assets whatsoever and wheresoever bothpresent and future of the company.
    Personnes ayant droit
    • Hope Sixteen LTD
    Transactions
    • 11 déc. 1985Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 21 juin 1985
    Livré le 11 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transactions
    • 11 juil. 1985Enregistrement d'une charge

    BCP REALISATIONS (2008) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Robert Jonathan Hunt
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    administrative receiver
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Ian David Green
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham Street
    administrative receiver
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham Street

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0