BAXI BOILERS UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBAXI BOILERS UK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01923295
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BAXI BOILERS UK LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe BAXI BOILERS UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Brooks House
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Warwickshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BAXI BOILERS UK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ADVANCED DESIGN AND MANUFACTURE LIMITED13 mars 198713 mars 1987
    ADVANCE DESIGN AND MANUFACTURE LIMITED17 juin 198517 juin 1985

    Quels sont les derniers comptes de BAXI BOILERS UK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour BAXI BOILERS UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 09 déc. 2011

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juin 2011

    État du capital au 15 juin 2011

    • Capital: GBP 525,612
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    1 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    1 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Karen Roberts le 27 sept. 2010

    2 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur John Mcfaull le 28 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Adrian Egerton Darling le 28 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de 16 Stanier Way Wyvern Business Park Derby Derbyshire DE21 6BF England le 27 sept. 2010

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur John Mcfaull le 13 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Adrian Egerton Darling le 13 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Karen Roberts le 13 janv. 2010

    1 pagesCH03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    1 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    1 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de BAXI BOILERS UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROBERTS, Karen Dawn
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Secrétaire
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    British126457090001
    DARLING, Adrian Egerton
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritishGroup Finance Director13813980005
    MCFAULL, John
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    BritishFinancial Controller83628430003
    BLACK, Pamela Ruby
    The Barn Smallbanks
    Cocking Lane
    LS29 0QQ Addingham
    West Yorkshire
    Secrétaire
    The Barn Smallbanks
    Cocking Lane
    LS29 0QQ Addingham
    West Yorkshire
    British50189010001
    BOND, Sarah Caroline
    Hillside
    37 Rise End, Middleton
    DE4 4LS Wirksworth
    Derbyshire
    Secrétaire
    Hillside
    37 Rise End, Middleton
    DE4 4LS Wirksworth
    Derbyshire
    British90181180006
    HARDMAN, Alan Philip
    156 Vicars Hall Lane
    Worsley
    M28 1HY Salford
    Manchester
    Secrétaire
    156 Vicars Hall Lane
    Worsley
    M28 1HY Salford
    Manchester
    British54046590001
    LEWIS, Colin John
    10 St Michaels Road
    CV35 8NT Claverdon
    Warwickshire
    Secrétaire
    10 St Michaels Road
    CV35 8NT Claverdon
    Warwickshire
    BritishAccountant103938340001
    LOWE, Tracey
    149 Smalley Drive
    Oakwood
    DE21 2SQ Derby
    Derbyshire
    Secrétaire
    149 Smalley Drive
    Oakwood
    DE21 2SQ Derby
    Derbyshire
    British86697030001
    PERKINS, Michael William
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    Secrétaire
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    British30958650001
    ROTHWELL, Peter Jeffrey
    7 Riefield
    Harpers Lane
    BL1 6TA Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    7 Riefield
    Harpers Lane
    BL1 6TA Bolton
    Lancashire
    BritishCs55070650001
    STRATTON, Malcolm
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    Secrétaire
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    British30601260018
    ACORNLEY, John Keith
    Rose Cottage
    Newton Road
    CV13 0QU Odstone
    Warwickshire
    Administrateur
    Rose Cottage
    Newton Road
    CV13 0QU Odstone
    Warwickshire
    EnglandBritishCompany Director151839430001
    ATKIN, Howard Stuart
    2a Armcliffe Road
    Homyolt
    N Yorks
    Administrateur
    2a Armcliffe Road
    Homyolt
    N Yorks
    EnglishDirector68279780001
    BLACK, Michael Robert
    The Barn Smallbanks Cocking Lane
    Addingham
    LS29 0QQ Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Barn Smallbanks Cocking Lane
    Addingham
    LS29 0QQ Ilkley
    West Yorkshire
    EnglishChartered Accountant14335860001
    DROOGAN, Christopher John
    Tarvin Road
    WA6 6XN Frodsham
    Chestnut Farmhouse
    Cheshire
    Administrateur
    Tarvin Road
    WA6 6XN Frodsham
    Chestnut Farmhouse
    Cheshire
    EnglandBritishDirector130729300001
    GRAY, Bryan Mark
    The Firs 69 The Common
    Parbold
    WN8 7EA Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    The Firs 69 The Common
    Parbold
    WN8 7EA Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector34960210001
    LEWIS, Colin John
    10 St Michaels Road
    CV35 8NT Claverdon
    Warwickshire
    Administrateur
    10 St Michaels Road
    CV35 8NT Claverdon
    Warwickshire
    United KingdomBritishAccountant103938340001
    NASH, Robert Leslie
    12 Manor Fields Drive
    DE7 5FA Ilkeston
    Derbyshire
    Administrateur
    12 Manor Fields Drive
    DE7 5FA Ilkeston
    Derbyshire
    United KingdomBritishFinancial Controller83397580001
    PALMER, Christopher John
    Hollyedge 8 Creskeld Crescent
    LS16 9EH Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Hollyedge 8 Creskeld Crescent
    LS16 9EH Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector107061530001
    PERKINS, Michael William
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    United KingdomBritishAccountant30958650001
    NEWMOND ADMINISTRATION LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363930002
    NEWMOND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363780002

    BAXI BOILERS UK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A guarantee and debenture
    Créé le 12 mars 2004
    Livré le 25 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each of the charging companies to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Agent and Trustee (The Security Trustee) for the Securedparties
    Transactions
    • 25 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee and debenture made between the company and the royal bank of scotland PLC as agent and trustee for the secured parties (as defined) pursuant to the intercreditor agreement (as defined)
    Créé le 22 nov. 2000
    Livré le 08 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) including the guarantee and debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 21 janv. 2000
    Livré le 31 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company or any group company to any of the secured parties under, or pursuant to, all or any of the financing documents
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale, London Branch as Agent and Security Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 31 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 03 déc. 1999
    Livré le 21 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (including the guarantee and debenture) (the "secured obligations")
    Brèves mentions
    The leasehold property known as unit 3, aylesham industrial estate, brighouse road, low moor, bradford t/no:WYK393582 all assets and income, with full title guarantee, as continuing security for payment of the secured obligations, all estates or interests in the freehold, leasehold and other immovable property described in the schedule and the proceeds of sale thereof and all buildings and trade and other fixtures on any such property, by way of fixed charge all estates or interests in the freehold, leasehold and other immovable property and the proceeds of sale thereof and all buildings and trade and other fixtures on any such property. For further details see f orm 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale (London Branch)
    Transactions
    • 21 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 29 oct. 1996
    Livré le 01 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 01 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 27 août 1991
    Livré le 31 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    And all injection mould tooling. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transactions
    • 31 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 23 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 18 févr. 1987
    Livré le 24 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 févr. 1987Enregistrement d'une charge
    • 06 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BAXI BOILERS UK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    22 janv. 2013Dissolved on
    09 déc. 2011Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    practitioner
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0