ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS UK LONG PRODUCTS LIMITED

ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS UK LONG PRODUCTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS UK LONG PRODUCTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01924617
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS UK LONG PRODUCTS LIMITED ?

    • Commerce de gros de métaux et minerais métalliques (46720) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS UK LONG PRODUCTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Merseyside
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS UK LONG PRODUCTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    N.S.D. LIMITED09 août 198509 août 1985
    VEERFERRY LIMITED21 juin 198521 juin 1985

    Quels sont les derniers comptes de ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS UK LONG PRODUCTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS UK LONG PRODUCTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71
    A63P3Z74

    Déclaration de solvabilité

    5 pages4.70
    A5ZJPG2B

    Changement d'adresse du siège social de South Park Rd South Park Ind Est Scunthorpe DN17 2BY à 8 Princes Parade Liverpool Merseyside L3 1QH le 28 sept. 2016

    2 pagesAD01
    A5FHCZRC

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600
    A5FHCZRK

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 06 sept. 2016

    LRESSP

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    21 pagesAA
    A4MG5RLN

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 déc. 2015

    État du capital au 08 déc. 2015

    • Capital: GBP 40,000
    SH01
    X4LTQM35

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    20 pagesAA
    A3ZNVD2O

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 déc. 2014

    État du capital au 17 déc. 2014

    • Capital: GBP 40,000
    SH01
    X3MXVQK0

    Cessation de la nomination de Leslie Nanson en tant que secrétaire le 13 août 2014

    1 pagesTM02
    X3E7683L

    Nomination de Mr Steven David Taylor en tant que secrétaire le 13 août 2014

    2 pagesAP03
    X3E767Z4

    Nomination de Mr Michael Timmermans en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01
    X3728KVN

    Cessation de la nomination de Leslie Nanson en tant que directeur

    1 pagesTM01
    X3728INL

    Certificat de changement de nom

    Company name changed N.S.D. LIMITED\certificate issued on 02/12/13
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name02 déc. 2013

    Résolution de changement de nom

    RES15
    change-of-name02 déc. 2013

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    X2MEL657

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 déc. 2013

    État du capital au 02 déc. 2013

    • Capital: GBP 40,000
    SH01
    X2MEJTGH

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Leslie Nanson le 31 mai 2013

    2 pagesCH03
    X2MEJTG9

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    21 pagesAA
    A2I07T6P

    Nomination de Mr Leslie Nanson en tant que secrétaire

    1 pagesAP03
    X29TNC9K

    Cessation de la nomination de Robert Leech en tant que secrétaire

    1 pagesTM02
    X29TNBSQ

    Cessation de la nomination de Robert Leech en tant que directeur

    1 pagesTM01
    X29TNBKX

    Nomination de Mr Sven Van De Putte en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01
    X201TJ0W

    Divers

    Auditors resignation
    1 pagesMISC
    A1OF8ZOH

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    X1N9U1AP

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Leslie Nanson le 06 déc. 2012

    2 pagesCH01
    X1N9U1AH

    Qui sont les dirigeants de ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS UK LONG PRODUCTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TAYLOR, Steven David
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    Secrétaire
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    190135880001
    TIMMERMANS, Michael
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    Administrateur
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    BelgiumBelgianCfo187369640001
    VAN DE PUTTE, Sven
    Cherry Orchard
    Codsall
    WV8 1AD Wolverhampton
    Ash House
    England
    Administrateur
    Cherry Orchard
    Codsall
    WV8 1AD Wolverhampton
    Ash House
    England
    EnglandDutchCeo165399640001
    LEECH, Robert
    11 Laneside
    HD5 0EP Kirkheaton
    Huddersfield
    Secrétaire
    11 Laneside
    HD5 0EP Kirkheaton
    Huddersfield
    British32828650002
    NANSON, Leslie
    Walls Wood
    Baldwins Gate
    ST5 5LD Newcastle
    Chisellers Lodge
    Staffordshire
    England
    Secrétaire
    Walls Wood
    Baldwins Gate
    ST5 5LD Newcastle
    Chisellers Lodge
    Staffordshire
    England
    178769490001
    BADDELEY, Robert Gregory
    Hendre 31 Stamford Road
    Bowdon
    WA14 2JT Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    Hendre 31 Stamford Road
    Bowdon
    WA14 2JT Altrincham
    Cheshire
    BritishDirector28024220001
    BOUZAR, Cedric
    Grove Lane
    WV6 8NJ Wolverhampton
    33
    England
    Administrateur
    Grove Lane
    WV6 8NJ Wolverhampton
    33
    England
    EnglandFrenchCeo138940310002
    GILLET, Vincent
    68-Rue Jean Jacques Rousseau
    FOREIGN Paris
    75001
    France
    Administrateur
    68-Rue Jean Jacques Rousseau
    FOREIGN Paris
    75001
    France
    FranceFrenchDirector113307830001
    HART, Paul Thomas
    Burland House
    Swillington Lane
    LS26 8QU Leeds
    Administrateur
    Burland House
    Swillington Lane
    LS26 8QU Leeds
    British101368860002
    LAMBERT, Michael Robert
    Ryther Hall 136 Westgate Road
    Belton
    DN9 1QB Doncaster
    South Yorkshire
    Administrateur
    Ryther Hall 136 Westgate Road
    Belton
    DN9 1QB Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector41691800001
    LEECH, Robert
    11 Laneside
    HD5 0EP Kirkheaton
    Huddersfield
    Administrateur
    11 Laneside
    HD5 0EP Kirkheaton
    Huddersfield
    United KingdomBritishChartered Accountant32828650002
    LEVISON, Anthony Norman
    6 Stairfoot Lane
    LS17 5EN Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    6 Stairfoot Lane
    LS17 5EN Leeds
    West Yorkshire
    British32828660002
    MACDONALD, John Malcolm Kenneth
    Ensor
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Administrateur
    Ensor
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    British33673310001
    NANSON, Leslie
    Walls Wood
    Baldwins Gate
    ST5 5LD Newcastle
    Chisellers Lodge
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Walls Wood
    Baldwins Gate
    ST5 5LD Newcastle
    Chisellers Lodge
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant102036000004
    SAVAGE, Francois
    5 Rue Des Boucheries
    Reims
    51100
    France
    Administrateur
    5 Rue Des Boucheries
    Reims
    51100
    France
    FranceFrenchDirector126436960001
    WITTEVEEN, Erlend
    Dielmanlaan 4 B-2530
    Boechout
    Belgium
    Administrateur
    Dielmanlaan 4 B-2530
    Boechout
    Belgium
    BelgiumBelgianDirector126436910001

    ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS UK LONG PRODUCTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 03 août 2005
    Livré le 05 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the east side of scotter road, scunthorpe t/no HS292973 all fixtures fittings plant and machinery which may from time to time be erected on or affixed to the property by way of floating charge all other moveable plant machinery implements building materials of all kinds utensils furniture and equipment now or from time to time placed on or used on or about the property and belonging to the company and the undertakings and all other property assets and rights of the borrower whatsoever both present and future.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transactions
    • 05 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage deed
    Créé le 31 août 2004
    Livré le 07 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property to the north east of greenhoe road scunthorpe t/n HS299699. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 07 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage deed
    Créé le 03 févr. 1997
    Livré le 08 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a plot 3 south park road scunthorpe north lincolnshire t/no.HS187159 together with all buildings fixtures fixed plant and machinery goodwill and book debts .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 08 févr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage deed
    Créé le 19 juin 1996
    Livré le 20 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Parcel of land at south park road scunthorpe and by way of assignment the goodwill of the business see form 395 for full details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 20 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 25 oct. 1995
    Livré le 26 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a plots 23 23A & 36 hoylake road plot 43 north farm road & plot 44D down road south park industrial estate scunthorpe t/no HS185215 with all buildings and fixtures thereon and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 26 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating charge
    Créé le 23 juin 1995
    Livré le 14 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the agreement or otherwise
    Brèves mentions
    1.By way of fixed equitable charge (I) all debts the subject of an invoice discounting agreement that fail to vest absolutely in the security holder and all rights in favour of the company related to such debts and (ii) all other amounts owing or becoming due to the company.2.by way of floating charge such of the moneys which the company may receive in respect of the amounts referred to in paragraph 1(ii). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transactions
    • 14 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 20 mars 1991
    Livré le 30 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on the north side of south park road, scunthorpe title no hs 167620. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 30 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 21 oct. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Single debenture
    Créé le 22 janv. 1990
    Livré le 25 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 25 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 21 oct. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment
    Créé le 01 mars 1989
    Livré le 08 mars 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All its right title & interest in and to any contract & all monies & claims due to the company under its contracts (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Ibi Finance (UK) PLC
    Transactions
    • 08 mars 1989Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 08 juil. 1987
    Livré le 14 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land lying to the west of swinnow road bramley leeds 13, west yorkshire title no wyk 340711.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 08 juil. 1987
    Livré le 14 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    529 stanningley road, bramley leeds 13, west yorkshire title no wyk 358252.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 24 oct. 1986
    Livré le 04 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Including trade fixtures 529 stanningley road leeds LS13 4EN. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Harlow & Jones Limited
    Transactions
    • 04 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 12 févr. 1986
    Livré le 18 févr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 févr. 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 27 janv. 1986
    Livré le 30 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land situate to the south of stanningley road, bramley leeds.
    Personnes ayant droit
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 janv. 1986Enregistrement d'une charge

    ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS UK LONG PRODUCTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    12 juil. 2017Dissolved on
    06 sept. 2016Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John David Thomas Milsom
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    practitioner
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Paul Andrew Flint
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    practitioner
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0