MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01926410 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1 Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood Lancashire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 avr. 2015 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Steven Quinlan en tant qu'administrateur le 26 août 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de James Lamar Herbert en tant qu'administrateur le 26 août 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Gareth Smith en tant que directeur le 26 août 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Gareth Smith en tant que secrétaire le 26 août 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Colin Goodwille en tant que directeur le 26 août 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Maclaren Cassells en tant que directeur le 26 août 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ian Leslie Morris en tant que directeur le 26 août 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Stephen Jeffrey Irwin Holmes en tant qu'administrateur le 26 août 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2015 | 7 pages | AA | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Colin Goodwille le 23 oct. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Mr Ian Leslie Morris en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Paul Gareth Smith en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2013 | 4 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Paul Gareth Smith en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Sullivan en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2012 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Dr John Maclaren Cassells en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERBERT, James Lamar | Administrateur | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire | United States | American | 200649010001 | |||||
| HOLMES, Stephen Jeffrey Irwin, Dr | Administrateur | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire | United Kingdom | British | 200627160001 | |||||
| QUINLAN, Steven | Administrateur | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire | United States | American | 203110190001 | |||||
| BROWN, Michael Stewart | Secrétaire | Flat 6 Derwent Park House New Road DE22 1DR Derby | British | 86327240001 | ||||||
| COTTON, Angela | Secrétaire | 3 Ravens Holme BL1 5TN Bolton Greater Mancheseter | British | 62018140001 | ||||||
| DUNBAR, Stephen John | Secrétaire | 43 Cotswold Drive Horwich BL6 7DE Bolton Lancashire | British | 46237640003 | ||||||
| DUNBAR, Stephen John | Secrétaire | 43 Cotswold Drive Horwich BL6 7DE Bolton Lancashire | British | 46237640003 | ||||||
| JAMES, Richard David | Secrétaire | 19 Mill Close WA2 0ST Warrington Cheshire | British | 80458850001 | ||||||
| MCMAHON, Gregory Joseph | Secrétaire | 7 St Johns Court Lees OL4 3LN Oldham Lancashire | British | 49723980001 | ||||||
| RAPSON, Bernard David | Secrétaire | Bank Cottage Old Forge Lane Preston Capes NN11 3TD Daventry Northamptonshire | British | 3213310001 | ||||||
| SMITH, Paul Gareth | Secrétaire | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire England | 184024770001 | |||||||
| SULLIVAN, Mark James | Secrétaire | 2 Grange Barn Malt Kiln Lane Bispham L40 3SH Ormskirk Lancashire | British | 101060960001 | ||||||
| A B & C SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 38962110003 | |||||||
| HP SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire | 900002670001 | |||||||
| ADLER, Alan William | Administrateur | 37 Grosvenor Square W1X 9AE London | Citizen Of Usa | 3856820001 | ||||||
| BONDSWELL, Andrew | Administrateur | 19 Brier Hill View HD2 1JQ Huddersfield West Yorkshire | British | 62729310001 | ||||||
| BOWHILL, Keith Nicholas | Administrateur | Woodside Sandy Lane Rushmoor GU10 2ET Farnham Surrey | British | 61679460002 | ||||||
| BUHL, Christian | Administrateur | Noddegangen 9 FOREIGN Holte Dk 2840 Denmark | Danish | 30528580001 | ||||||
| CASSELLS, John Maclaren, Dr | Administrateur | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire England | England | British | 63881080001 | |||||
| GOODWILLE, Colin | Administrateur | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire England | England | British | 3856830002 | |||||
| GOODWILLE, Colin | Administrateur | The Old Rectory Church Lane Papworth Everard CB3 8QN Cambridge | England | British | 3856830002 | |||||
| GOODWILLE, Fiona Ford | Administrateur | The Old Rectory Church Lane CB3 8QN Papworth Everard Cambridge | British | 20914960001 | ||||||
| GRNNING, Torben Guth | Administrateur | Flat 3 36 Montagu Square W1H 1TL London | Danish | 18303130001 | ||||||
| GUNLACK, Robert Henry | Administrateur | Treviades Barton High Cross Constantine TR11 5RG Falmouth Cornwall | England | British | 27971040006 | |||||
| HILLARY, Alan | Administrateur | 1 Cameron Close GU6 8EB Cranleigh Surrey | United Kingdom | British | 13184060001 | |||||
| KERTON, Nicholas Anthony, Dr | Administrateur | Brambles Oakfield Hawkhurst TN18 4JR Cranbrook Kent | British | 59321720001 | ||||||
| MORRIS, Ian Leslie | Administrateur | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire England | United Kingdom | British | 138377860001 | |||||
| PRIMROSE, Sandy Blackadder, Doctor | Administrateur | Amersham Road HP13 6QS High Wycombe 21 Buckinghamshire | England | British | 17972160001 | |||||
| SCHRODER, Johan | Administrateur | Christiansholms Parallelvej 15 Dk-2930 Klampenborg Denmark | Danish | 3856860001 | ||||||
| SMITH, Paul Gareth | Administrateur | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire England | England | British | 187422070001 | |||||
| STAMMERS, Brian Michael, Dr | Administrateur | 9 Farley Way MK43 7QL Stevington Bedfordshire | British | 98198380001 | ||||||
| SYMS, Allan, Dr | Administrateur | Customs House Place Penarth Marina CF64 1TP Vale Of Glamorgan 12 Cariff | British | 128513480001 | ||||||
| WALPOLE, Malcolm William | Administrateur | 28 Higher Mead RG24 8YL Old Basing Hampshire | British | 107822300001 |
MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over a deposit held by yorkshire bank PLC (own account) | Créé le 29 nov. 1996 Livré le 19 déc. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Yorkshire bank PLC current account no: 68162730 account name: malthus instruments limited. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 30 nov. 1995 Livré le 02 déc. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or by the companies hereinafter defined ("the customer") and all monies agreed to be paid by the company in accordance with the provisions of any guarantee or guarantees given by the company to the yorkshire bank public limited company in respect of the indebtedness and liability of the customer or any company or companies which may constitute a subsidiary or subsidiaries of the charging company or of any holding company or any (as therein defined) of the charging company or any company or companies which may be otherwise associated with the charging company in business | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 19 mai 1995 Livré le 23 mai 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed | Créé le 19 août 1994 Livré le 30 août 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a lease of even date | |
Brèves mentions The sum of £16,500. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0