MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMALTHUS INSTRUMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01926410
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED ?

    • Autres industries manufacturières n.d.a. (32990) / Industries manufacturières

    Où se situe MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    Lancashire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PULSEGLOW LIMITED27 juin 198527 juin 1985

    Quels sont les derniers comptes de MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Mr Steven Quinlan en tant qu'administrateur le 26 août 2015

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 oct. 2015

    État du capital au 20 oct. 2015

    • Capital: GBP 600,000
    SH01

    Nomination de James Lamar Herbert en tant qu'administrateur le 26 août 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Paul Gareth Smith en tant que directeur le 26 août 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Paul Gareth Smith en tant que secrétaire le 26 août 2015

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Colin Goodwille en tant que directeur le 26 août 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Maclaren Cassells en tant que directeur le 26 août 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ian Leslie Morris en tant que directeur le 26 août 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Stephen Jeffrey Irwin Holmes en tant qu'administrateur le 26 août 2015

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2015

    7 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 oct. 2014

    État du capital au 23 oct. 2014

    • Capital: GBP 600,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Colin Goodwille le 23 oct. 2014

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Ian Leslie Morris en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Paul Gareth Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2013

    4 pagesAA

    Nomination de Mr Paul Gareth Smith en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Mark Sullivan en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 oct. 2013

    État du capital au 02 oct. 2013

    • Capital: GBP 600,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2012

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Nomination de Dr John Maclaren Cassells en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HERBERT, James Lamar
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    Administrateur
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    United StatesAmerican200649010001
    HOLMES, Stephen Jeffrey Irwin, Dr
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    Administrateur
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    United KingdomBritish200627160001
    QUINLAN, Steven
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    Administrateur
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    United StatesAmerican203110190001
    BROWN, Michael Stewart
    Flat 6 Derwent Park House
    New Road
    DE22 1DR Derby
    Secrétaire
    Flat 6 Derwent Park House
    New Road
    DE22 1DR Derby
    British86327240001
    COTTON, Angela
    3 Ravens Holme
    BL1 5TN Bolton
    Greater Mancheseter
    Secrétaire
    3 Ravens Holme
    BL1 5TN Bolton
    Greater Mancheseter
    British62018140001
    DUNBAR, Stephen John
    43 Cotswold Drive
    Horwich
    BL6 7DE Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    43 Cotswold Drive
    Horwich
    BL6 7DE Bolton
    Lancashire
    British46237640003
    DUNBAR, Stephen John
    43 Cotswold Drive
    Horwich
    BL6 7DE Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    43 Cotswold Drive
    Horwich
    BL6 7DE Bolton
    Lancashire
    British46237640003
    JAMES, Richard David
    19 Mill Close
    WA2 0ST Warrington
    Cheshire
    Secrétaire
    19 Mill Close
    WA2 0ST Warrington
    Cheshire
    British80458850001
    MCMAHON, Gregory Joseph
    7 St Johns Court
    Lees
    OL4 3LN Oldham
    Lancashire
    Secrétaire
    7 St Johns Court
    Lees
    OL4 3LN Oldham
    Lancashire
    British49723980001
    RAPSON, Bernard David
    Bank Cottage Old Forge Lane
    Preston Capes
    NN11 3TD Daventry
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Bank Cottage Old Forge Lane
    Preston Capes
    NN11 3TD Daventry
    Northamptonshire
    British3213310001
    SMITH, Paul Gareth
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    Secrétaire
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    184024770001
    SULLIVAN, Mark James
    2 Grange Barn
    Malt Kiln Lane Bispham
    L40 3SH Ormskirk
    Lancashire
    Secrétaire
    2 Grange Barn
    Malt Kiln Lane Bispham
    L40 3SH Ormskirk
    Lancashire
    British101060960001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    38962110003
    HP SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Oxford House
    Cliftonville
    NN1 5PN Northampton
    Northamptonshire
    Secrétaire désigné
    Oxford House
    Cliftonville
    NN1 5PN Northampton
    Northamptonshire
    900002670001
    ADLER, Alan William
    37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    Administrateur
    37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    Citizen Of Usa3856820001
    BONDSWELL, Andrew
    19 Brier Hill View
    HD2 1JQ Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    19 Brier Hill View
    HD2 1JQ Huddersfield
    West Yorkshire
    British62729310001
    BOWHILL, Keith Nicholas
    Woodside
    Sandy Lane Rushmoor
    GU10 2ET Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Woodside
    Sandy Lane Rushmoor
    GU10 2ET Farnham
    Surrey
    British61679460002
    BUHL, Christian
    Noddegangen 9
    FOREIGN Holte Dk 2840
    Denmark
    Administrateur
    Noddegangen 9
    FOREIGN Holte Dk 2840
    Denmark
    Danish30528580001
    CASSELLS, John Maclaren, Dr
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    Administrateur
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    EnglandBritish63881080001
    GOODWILLE, Colin
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    Administrateur
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    EnglandBritish3856830002
    GOODWILLE, Colin
    The Old Rectory Church Lane
    Papworth Everard
    CB3 8QN Cambridge
    Administrateur
    The Old Rectory Church Lane
    Papworth Everard
    CB3 8QN Cambridge
    EnglandBritish3856830002
    GOODWILLE, Fiona Ford
    The Old Rectory Church Lane
    CB3 8QN Papworth Everard
    Cambridge
    Administrateur
    The Old Rectory Church Lane
    CB3 8QN Papworth Everard
    Cambridge
    British20914960001
    GRNNING, Torben Guth
    Flat 3
    36 Montagu Square
    W1H 1TL London
    Administrateur
    Flat 3
    36 Montagu Square
    W1H 1TL London
    Danish18303130001
    GUNLACK, Robert Henry
    Treviades Barton
    High Cross Constantine
    TR11 5RG Falmouth
    Cornwall
    Administrateur
    Treviades Barton
    High Cross Constantine
    TR11 5RG Falmouth
    Cornwall
    EnglandBritish27971040006
    HILLARY, Alan
    1 Cameron Close
    GU6 8EB Cranleigh
    Surrey
    Administrateur
    1 Cameron Close
    GU6 8EB Cranleigh
    Surrey
    United KingdomBritish13184060001
    KERTON, Nicholas Anthony, Dr
    Brambles Oakfield
    Hawkhurst
    TN18 4JR Cranbrook
    Kent
    Administrateur
    Brambles Oakfield
    Hawkhurst
    TN18 4JR Cranbrook
    Kent
    British59321720001
    MORRIS, Ian Leslie
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    Administrateur
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    United KingdomBritish138377860001
    PRIMROSE, Sandy Blackadder, Doctor
    Amersham Road
    HP13 6QS High Wycombe
    21
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Amersham Road
    HP13 6QS High Wycombe
    21
    Buckinghamshire
    EnglandBritish17972160001
    SCHRODER, Johan
    Christiansholms
    Parallelvej 15 Dk-2930 Klampenborg
    Denmark
    Administrateur
    Christiansholms
    Parallelvej 15 Dk-2930 Klampenborg
    Denmark
    Danish3856860001
    SMITH, Paul Gareth
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    Administrateur
    Quest Park
    Moss Hall Road
    BL9 7JJ Heywood
    1
    Lancashire
    England
    EnglandBritish187422070001
    STAMMERS, Brian Michael, Dr
    9 Farley Way
    MK43 7QL Stevington
    Bedfordshire
    Administrateur
    9 Farley Way
    MK43 7QL Stevington
    Bedfordshire
    British98198380001
    SYMS, Allan, Dr
    Customs House Place
    Penarth Marina
    CF64 1TP Vale Of Glamorgan
    12
    Cariff
    Administrateur
    Customs House Place
    Penarth Marina
    CF64 1TP Vale Of Glamorgan
    12
    Cariff
    British128513480001
    WALPOLE, Malcolm William
    28 Higher Mead
    RG24 8YL Old Basing
    Hampshire
    Administrateur
    28 Higher Mead
    RG24 8YL Old Basing
    Hampshire
    British107822300001

    MALTHUS INSTRUMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over a deposit held by yorkshire bank PLC (own account)
    Créé le 29 nov. 1996
    Livré le 19 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Yorkshire bank PLC current account no: 68162730 account name: malthus instruments limited.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 nov. 1995
    Livré le 02 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or by the companies hereinafter defined ("the customer") and all monies agreed to be paid by the company in accordance with the provisions of any guarantee or guarantees given by the company to the yorkshire bank public limited company in respect of the indebtedness and liability of the customer or any company or companies which may constitute a subsidiary or subsidiaries of the charging company or of any holding company or any (as therein defined) of the charging company or any company or companies which may be otherwise associated with the charging company in business
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 02 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 mai 1995
    Livré le 23 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed
    Créé le 19 août 1994
    Livré le 30 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a lease of even date
    Brèves mentions
    The sum of £16,500.
    Personnes ayant droit
    • J. Sainsbury Trustees Limited and J Sainsbury Trustees (No.2) Limited
    Transactions
    • 30 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0