36 POULTRY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la société36 POULTRY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01930484
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de 36 POULTRY LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe 36 POULTRY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de 36 POULTRY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    C.G.I.S. 36 POULTRY LIMITED28 avr. 200328 avr. 2003
    GREYCOAT COMMERCIAL DEVELOPMENTS LIMITED30 juil. 198530 juil. 1985
    GREYCOAT COUNTY & SUBURBAN DEVELOPMENTS LIMITED15 juil. 198515 juil. 1985

    Quels sont les derniers comptes de 36 POULTRY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour 36 POULTRY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB le 23 nov. 2012

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 09 nov. 2012

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 oct. 2012

    État du capital au 10 oct. 2012

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2011

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2010

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2009

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Brian Watt le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Graham Paine le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew John Jackson le 05 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Robert Michael Hannigan le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Paolo Alonzi le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    2 pagesAD02

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages353

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2008

    8 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Director's authorisation 14/11/2008
    RES13

    legacy

    4 pages363a

    Qui sont les dirigeants de 36 POULTRY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ALONZI, Paolo
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    Secrétaire
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    Italian113225330001
    HANNIGAN, Robert Michael
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    Administrateur
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    United KingdomBritish81510590004
    JACKSON, Andrew John
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    Administrateur
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    United KingdomBritish83130180001
    PAINE, David Graham
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    Administrateur
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    ScotlandBritish79124040001
    WATT, Mark Brian
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    Administrateur
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    United KingdomBritish85845500002
    BROWN, Norman Clifford
    7 Peto Place
    Regents Park
    NW1 4DT London
    Secrétaire
    7 Peto Place
    Regents Park
    NW1 4DT London
    British881730001
    EVANS, Michael
    Willowtyne
    Victoria Road
    EH41 4DJ Haddington
    East Lothian
    Secrétaire
    Willowtyne
    Victoria Road
    EH41 4DJ Haddington
    East Lothian
    British98652120001
    REITH, Julie Katharine
    Flat 3f2 47 Brunswick Road
    EH7 5PD Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    Flat 3f2 47 Brunswick Road
    EH7 5PD Edinburgh
    Midlothian
    British112039220001
    STEINBERG, Mark Neil
    Wadham Gardens
    NW3 3DN London
    11
    Secrétaire
    Wadham Gardens
    NW3 3DN London
    11
    British59275730001
    BROCK, Robert Stuart
    1 Lord Roberts Mews
    Waterford Road Fulham
    SW6 2DW London
    Administrateur
    1 Lord Roberts Mews
    Waterford Road Fulham
    SW6 2DW London
    United KingdomBritish102450290001
    BROWN, Norman Clifford
    56 Magnolia Dene
    Hazlemere
    HP15 7QE High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    56 Magnolia Dene
    Hazlemere
    HP15 7QE High Wycombe
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish881730003
    COLE, Terence Shelby
    Phillimore Gardens
    W8 7QE London
    24
    Administrateur
    Phillimore Gardens
    W8 7QE London
    24
    United KingdomBritish71810060003
    COLLINS, Steven Ross
    Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PL London
    70
    Administrateur
    Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PL London
    70
    United KingdomBritish7128850001
    CRAVEN, Andrew Martin
    10 Bloomfield Road
    Highgate
    N6 4ET London
    Administrateur
    10 Bloomfield Road
    Highgate
    N6 4ET London
    EnglandBritish75392720001
    GUIGNARD, Richard Charles Peter
    38a The Avenue
    WD7 7DW Radlett
    Hertfordshire
    Administrateur
    38a The Avenue
    WD7 7DW Radlett
    Hertfordshire
    British881740001
    KUMAR, Walter Krishan
    31 West Hill Park
    N6 6ND London
    Administrateur
    31 West Hill Park
    N6 6ND London
    United KingdomBritish70463990001
    MCGUIRE, Martin Anton
    4 Gilmour Road
    EH16 5NF Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    4 Gilmour Road
    EH16 5NF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish46513600001
    POOLE, Martin Arnold
    The Deep End
    40 Wood Street
    GU12 5JG Ashvale
    Surrey
    Administrateur
    The Deep End
    40 Wood Street
    GU12 5JG Ashvale
    Surrey
    British38285250001
    QUICKE, Martin William
    17 Great Austins
    GU9 8JQ Farnham
    Surrey
    Administrateur
    17 Great Austins
    GU9 8JQ Farnham
    Surrey
    British42668030002
    STEINBERG, Mark Neil
    Wadham Gardens
    NW3 3DN London
    11
    Administrateur
    Wadham Gardens
    NW3 3DN London
    11
    United KingdomBritish59275730001
    STRICKLAND, Christopher Norman
    31 Gorst Road
    SW11 6JB London
    Administrateur
    31 Gorst Road
    SW11 6JB London
    EnglandBritish881760001
    THORNTON, Peter Anthony
    Van Buren Cottage Queens Ride
    SW13 0JF London
    Administrateur
    Van Buren Cottage Queens Ride
    SW13 0JF London
    United KingdomBritish1808300001

    36 POULTRY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 17 avr. 2003
    Livré le 26 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Thirtieth supplemental trust deed
    Créé le 11 avr. 2003
    Livré le 22 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The freehold land and buildings comprising scottish life house poultry and land and buildings in the old jewry together known as 36 poultry london EC2 t/n NGL115626 together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery from the time being thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Law Debentures Trustees Limited
    Transactions
    • 22 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A security agreement, between, inter alia, the agent (as defined) and the chargor (the "security agreement")
    Créé le 02 nov. 2001
    Livré le 13 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in another capacity whatsoever) of each obligor to any finance party under each finance document except for any obligation which, if it were so included, would result in the security agreement contravening section 151 of the companies act 1985. (all terms as defined)
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage f/h land k/a 36 poultry, london, EC2, t/no NGL115626. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo- Und Vereinsbank Aktiengesellschaft (The "Agent")
    Transactions
    • 13 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 avr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement dated 8TH november 1999 between, amongst others, the chargor and bayerische hypo-und vereinsbank aktiengesellschaft, london branch.
    Créé le 08 nov. 1999
    Livré le 18 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contigent and whether owed jointly or serverally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to any finance party under each finance document.
    Brèves mentions
    The free/hold land as 36 poultry, london EC2 t/no:NGL1156. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo- Und Vereinsbank Aktiengesllschaft London Branch(As Agent and Trustee for the Finance Parties) (the "Agent")
    Transactions
    • 18 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 avr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 19 janv. 1999
    Livré le 20 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H scottish life house 36-39 poultry london EC2 and land & buildings at old jewry-NGL115626 and all buildings fixtures and rental/other income-see form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale
    Transactions
    • 20 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    36 POULTRY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 nov. 2012Commencement of winding up
    07 avr. 2014Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Colin Peter Dempster
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    practitioner
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Derek Hyslop
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    practitioner
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0