PARAMOUNT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPARAMOUNT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01934366
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PARAMOUNT LIMITED ?

    • (9305) /

    Où se situe PARAMOUNT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PARAMOUNT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PARAMOUNT P.L.C.22 févr. 198922 févr. 1989
    SILVER BEAR P.L.C.29 juil. 198529 juil. 1985

    Quels sont les derniers comptes de PARAMOUNT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au02 janv. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour PARAMOUNT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 13 nov. 2013

    17 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 13 nov. 2013

    17 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 22 avr. 2013

    16 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 18 oct. 2012

    17 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 22 mai 2012

    39 pages2.24B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    61 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    6 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de 8-10 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH le 05 déc. 2011

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Comptes complets modifiés jusqu'au 02 janv. 2011

    14 pagesAAMD

    legacy

    10 pagesMG01

    Comptes pour une société dormante établis au 02 janv. 2011

    7 pagesAA

    Nomination de Mr Stephen Rushworth Smith en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de William Rollason en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 juin 2011

    État du capital au 24 juin 2011

    • Capital: GBP 4,157,690.4
    SH01

    Cessation de la nomination de Matthew Emerson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr William Rollason en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Simon George Rowe en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Période comptable actuelle prolongée du 29 juin 2010 au 29 déc. 2010

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Mark Phillips en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Matthew Charles Emerson en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de PARAMOUNT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROWE, Simon George
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Administrateur
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandBritishDirector68119020002
    SMITH, Stephen Rushworth
    Hatton Garden
    EC1N 8LE London
    63-66
    Administrateur
    Hatton Garden
    EC1N 8LE London
    63-66
    United KingdomBritishNone6894950002
    DANGERFIELD, John
    Pulford Place
    Wrexham Road
    CH4 9DG Pulford
    Cheshire
    Secrétaire
    Pulford Place
    Wrexham Road
    CH4 9DG Pulford
    Cheshire
    BritishAccountant117743550001
    DARWIN, Richard James
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    Secrétaire
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    BritishDirector148079910001
    HILL, Peter Martin
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    Secrétaire
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    BritishCeo130983750001
    JACKSON, Graham Michael, Dr
    Maesmor Hall
    Maerdy
    LL21 0NS Corwen
    Clwyd
    Secrétaire
    Maesmor Hall
    Maerdy
    LL21 0NS Corwen
    Clwyd
    British20761790001
    PINCUS, Barry Martin
    19 Willifield Way
    NW11 7XU London
    Secrétaire
    19 Willifield Way
    NW11 7XU London
    British46444010002
    BARBOUR, Anthony George
    Bolesworth Castle
    Tattenhall
    CH3 9HQ Chester
    Administrateur
    Bolesworth Castle
    Tattenhall
    CH3 9HQ Chester
    BritishBusinessman1448620001
    BASING, Nicholas Andrew
    John Watkin Close
    KT19 7LW Epsom
    4
    Surrey
    Administrateur
    John Watkin Close
    KT19 7LW Epsom
    4
    Surrey
    EnglandBritishChief Executive140766360001
    BRAMLEY, Michael Lloyd
    53 Spring Lane
    Burn Bridge
    HG3 1NP Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    53 Spring Lane
    Burn Bridge
    HG3 1NP Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector46914100003
    D'ARCY, Lynne
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director106840540001
    DANGERFIELD, John
    Pulford Place
    Wrexham Road
    CH4 9DG Pulford
    Cheshire
    Administrateur
    Pulford Place
    Wrexham Road
    CH4 9DG Pulford
    Cheshire
    BritishAccountant117743550001
    DARWIN, Richard James
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    Administrateur
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    United KingdomBritishDirector148079910001
    DAVIES, Paul
    Greenacres
    Tamarix Close,Gedling
    NG4 4AJ Nottingham
    Administrateur
    Greenacres
    Tamarix Close,Gedling
    NG4 4AJ Nottingham
    BritishDirector5020990002
    DICKSON, Leslie Cranstoun
    10 Uplands Delamere Park
    Cuddington
    CW8 2XL Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    10 Uplands Delamere Park
    Cuddington
    CW8 2XL Northwich
    Cheshire
    BritishDirector25070870001
    ELMAN, Ralph
    1 Bickenhall Mansions
    Bickenhall Street
    W1U 6BP London
    Administrateur
    1 Bickenhall Mansions
    Bickenhall Street
    W1U 6BP London
    BritishDirector80068050001
    EMERSON, Matthew Charles
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0DH London
    8
    Administrateur
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0DH London
    8
    EnglandBritishAccountant61777750002
    FRYER, John Malcolm
    Old Stores 34a
    Ribchester Road
    BB1 9HU Blackburn
    Lancashire
    Administrateur
    Old Stores 34a
    Ribchester Road
    BB1 9HU Blackburn
    Lancashire
    BritishBanker44961580001
    HILL, Peter Martin
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    Administrateur
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    EnglandBritishCeo130983750001
    HUDD, David Leslie
    97 Gunterstone Road
    W14 9BT London
    Administrateur
    97 Gunterstone Road
    W14 9BT London
    EnglandBritishChartered Accountant26032950002
    JONES, Leonard Edward
    82 Royal Arch Apartments
    The Mailbox
    B1 1RB Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    82 Royal Arch Apartments
    The Mailbox
    B1 1RB Birmingham
    West Midlands
    BritishChartered Accountant76599820001
    KING, William James
    Springwood House
    Birch Heath Lane, Christleton
    CH3 7AP Chester
    Cheshire
    Administrateur
    Springwood House
    Birch Heath Lane, Christleton
    CH3 7AP Chester
    Cheshire
    BritishDirector64187110004
    LAWSON, Carole Mary
    34 Moss Bank Road
    WA11 7DE St Helens
    Merseyside
    Administrateur
    34 Moss Bank Road
    WA11 7DE St Helens
    Merseyside
    BritishSolicitor48885070001
    LUNN, George Michael
    Fairmount
    17 Ledcameroch Road
    G61 4AB Bearsden Glasgow
    Dunbartonshire
    Administrateur
    Fairmount
    17 Ledcameroch Road
    G61 4AB Bearsden Glasgow
    Dunbartonshire
    United KingdomBritishDirector194960002
    MEARNS, Alexander
    1 Windsor Road
    Crosby
    L23 7TR Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    1 Windsor Road
    Crosby
    L23 7TR Liverpool
    Merseyside
    BritishDirector35737020002
    MILLS, Christopher Harwood Bernard
    Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    10
    Administrateur
    Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    10
    United KingdomBritishDirector35557050001
    MILLS, Christopher Harwood Bernard
    Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    10
    Administrateur
    Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    10
    United KingdomBritishDirector35557050001
    MORTON, Brian George
    37 Meadow Vale
    Outwood
    WF1 3TD Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    37 Meadow Vale
    Outwood
    WF1 3TD Wakefield
    West Yorkshire
    BritishDirector Of Finance22731400001
    NAGGAR, Guy Anthony
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    Administrateur
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    United KingdomItalianDirector1496660001
    NEILL, Ian Smeeton
    22 Boxgrove Avenue
    GU1 1XG Guildford
    Surrey
    Administrateur
    22 Boxgrove Avenue
    GU1 1XG Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishCeo6744750002
    PHILLIPS, Mark Randall
    Scotts Cottage
    Scots Lane
    MK18 2HX Adstock
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Scotts Cottage
    Scots Lane
    MK18 2HX Adstock
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector80508130001
    PRICE, Robert Dennis
    Otters Bank Farm
    Fishpool Lane Delamere
    CW8 2HP Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    Otters Bank Farm
    Fishpool Lane Delamere
    CW8 2HP Tarporley
    Cheshire
    BritishDirector22672440001
    ROE, Neil Clifford
    Wind Hill Church Road
    Thornton In Craven
    BD23 3TN Skipton
    North Yorkshire
    Administrateur
    Wind Hill Church Road
    Thornton In Craven
    BD23 3TN Skipton
    North Yorkshire
    United KingdomBritishOperations Director100873710001
    ROLLASON, William
    8-10 Grosvenor Gardens
    London
    SW1W 0DH
    Administrateur
    8-10 Grosvenor Gardens
    London
    SW1W 0DH
    United KingdomBritishDirector140347580001
    STANDING, Peter Heaton
    16 Hob Hey Lane
    Culcheth
    WA3 4NQ Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    16 Hob Hey Lane
    Culcheth
    WA3 4NQ Warrington
    Cheshire
    BritishChief Executive23728590001

    PARAMOUNT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A supplemental security, accession and confirmation deed
    Créé le 22 sept. 2011
    Livré le 28 sept. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The chargor, with full title guarantee, in favour of the security trustee (as trustee for the finance parties), hereby respectively charged on the terms set out in the relevant charging clause of the relevant security documents its assets as more specifically referred to in the relevant security documents, the secured liabilities see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 17 juil. 2009
    Livré le 27 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 28 sept. 2006
    Livré le 05 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each security provider to the senior finance parties and the mezzanine finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 30 août 2005
    Livré le 02 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the junior finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Starlight Investments Limited (Security Trustee)
    Transactions
    • 02 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 mai 2005
    Livré le 27 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 27 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 avr. 2003
    Livré le 29 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 nov. 1998
    Livré le 17 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (I) afon goch inn,flintshire;wa 642065;(ii) anchor inn,north shropshire; sl 55332;(iii) aston arms,vale royal,cheshire; ch 348040 plus 104 other properties listed on schedule;all plant,machinery,fixtures/fittings,furniture,equipment,etc thereon; the goodwill of business and proceeds of any insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC,as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 17 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 nov. 1998
    Livré le 17 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC,as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 17 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of life policy
    Créé le 07 janv. 1997
    Livré le 23 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement and any of the "security documents" (as defined in the assignment)
    Brèves mentions
    The policy numbered jgn 13988 dated 7TH january 1997 in an amount of £250,000 on the life of paul davies issued through J.D.bassett and others and all monies (including claims profits and bonuses ) payable thereunder and all other rights of the company therein. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 févr. 1996
    Livré le 10 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H the bogie steamliner 81 salisbury street liverpool t/n MS355754 and by way of fixed charge all buildings and other structures any goodwill all plant machinery and other chattels the rental sums the proceeds of any claim under any insurance policy and by way of floating charge all unattached plant machinery and chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over sale proceeds account
    Créé le 02 mars 1995
    Livré le 21 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement (as defined)
    Brèves mentions
    The sale proceeds account no.01539664 Opened in the books of the bank of scotland and all monies constituting the balance to the credit of the account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland(As Agent for the Banks (as Defined)
    Transactions
    • 21 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 14 févr. 1995
    Livré le 17 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee secured by any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brèves mentions
    The spiral staircase old hall street liverpool together with any proceeds of insurance & all rents the benefit of all securities & guarantees & all interest due in respect thereof.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 19 déc. 1994
    Livré le 06 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brèves mentions
    Bleak house 127, 129, 131 & 133 park hill road & 87, 89, 91 & 93 cockburn street liverpool with the proceeds of any sale the rents the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 19 déc. 1994
    Livré le 06 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brèves mentions
    The derby arms 365/367 mill street liverpool with the proceeds of any insurance the rents the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 19 déc. 1994
    Livré le 06 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brèves mentions
    The new inn peasley cross lane st helens lancs and the proceeds of any insurance the rents & benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 19 déc. 1994
    Livré le 06 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brèves mentions
    Mount vernon 1 irvine street liverpool with the proceeds of any insurance the rents & benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 19 déc. 1994
    Livré le 06 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brèves mentions
    The poste house 23 cumberland street liverpool with the proceeds of any insurance all rents the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 19 déc. 1994
    Livré le 06 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brèves mentions
    The globe inn 44 park road liverpool with the proceeds of any insurance all rents & benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 19 déc. 1994
    Livré le 06 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brèves mentions
    The leasowe castle 1 demesne street seacombe wallasey wirral merseyside with any proceeds of insurance all rents & the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 19 déc. 1994
    Livré le 06 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brèves mentions
    The salvation 199 walton road liverpool with the proceeds of any insurance the benefit of all guarantees all rents. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 19 déc. 1994
    Livré le 06 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brèves mentions
    The sun inn 43/45 mill lane macclesfield cheshire and the proceeds of any insurance all rents the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 19 déc. 1994
    Livré le 06 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brèves mentions
    The smithfield 1062 ashton old road openshaw manchester with the proceeds of any insurance all rents & the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 19 déc. 1994
    Livré le 06 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brèves mentions
    Owd kitts 14 glodwick oldham gtr manchester with any proceeds of any insurance the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 23 nov. 1994
    Livré le 08 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £96,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The rubber duck 5 strand road bootle liverpool.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 nov. 1994
    Livré le 15 nov. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £55,200 due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brèves mentions
    The welcome inn 58 north john street st. Helens merseyside.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland(As Agent)
    Transactions
    • 15 nov. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    PARAMOUNT LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 nov. 2011Administration started
    13 nov. 2013Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Matthew David Smith
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Nicholas Guy Edwards
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3WA 66 Shoe Lane
    London
    practitioner
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3WA 66 Shoe Lane
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0